333 ESTATES LIMITED
Überblick
Unternehmensname | 333 ESTATES LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03205737 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von 333 ESTATES LIMITED?
- Gaststätten und Bars (56302) / Gastgewerbe
Wo befindet sich 333 ESTATES LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Studios C & D 209 St. John's Hill SW11 1TH London United Kingdom |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von 333 ESTATES LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
LONGSHOT ESTATES LIMITED | 30. Mai 1996 | 30. Mai 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von 333 ESTATES LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für 333 ESTATES LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Mai 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Notification of Farm Street Inns Limited as a person with significant control on 01. Juli 2016 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Cessation of 333 Holdings Limited (Application for Strike Off) as a person with significant control on 01. Juli 2016 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Juni 2018 bis 31. Dez. 2018 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Mai 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2017 | 24 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Mai 2017 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 032057370009, erstellt am 13. Apr. 2017 | 65 Seiten | MR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2016 | 22 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2015 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Polly Jane Dyson am 01. Sept. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Polly Jane Dyson am 01. Sept. 2015 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Alexander Langlands Pearse am 01. Sept. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 17 Mossop Street London SW3 2LY zum Studios C & D 209 st. John's Hill London SW11 1th am 09. Sept. 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2014 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2013 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2012 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von 333 ESTATES LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYSON, Polly Jane | Sekretär | 209 St. John's Hill SW11 1TH London Studios C & D United Kingdom | British | 165457370001 | ||||||
DYSON, Polly Jane | Geschäftsführer | 209 St. John's Hill SW11 1TH London Studios C & D United Kingdom | England | British | Accountant | 161237340001 | ||||
LANGLANDS PEARSE, Alexander | Geschäftsführer | 209 St. John's Hill SW11 1TH London Studios C & D United Kingdom | England | British | Company Director | 48400200005 | ||||
CADBURY, Joel Michael | Sekretär | 16a Wilton Street SW1X 7AG London | British | 21253350004 | ||||||
DUNMORE, Eric Maurice | Sekretär | 21 Golden Square W1F 9JN London | British | Chartered Accountant | 65297300003 | |||||
GIL, Alberto | Sekretär | Kearton Close CR8 5EN Kenley 5 Surrey | British | 157708220001 | ||||||
HOLCROFT, Thomas Bernard Manning | Sekretär | 17 Mossop Street London SW3 2LY | British | 151499600001 | ||||||
LANGLANDS PEARSE, Alexander | Sekretär | Walnut Tree Cottage The Priory Stomp Road SL1 7LR Burnham Buckinghamshire | British | 48400200004 | ||||||
PRIDEAUX, Simon Timothy | Sekretär | 51 Cobbold Road W12 9LA London | British | Company Director | 121068530001 | |||||
VIGORS, Oliver Richard | Sekretär | 20 Cranley Place SW7 3NH London | British | 21902980005 | ||||||
ASHCROFT CAMERON SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 4 Rivers House Fentiman Walk SG14 1DB Hertford Hertfordshire | 900004530001 | |||||||
CADBURY, Joel Michael | Geschäftsführer | 35 Lower Belgrave Street SW1W 0LS London | England | British | Director | 21253350005 | ||||
DUNMORE, Eric Maurice | Geschäftsführer | 21 Golden Square W1F 9JN London | British | Chartered Accountant | 65297300003 | |||||
HOLCROFT, Thomas Bernard Manning | Geschäftsführer | 17 Mossop Street London SW3 2LY | England | British | Chartered Accountant | 60759250002 | ||||
PRIDEAUX, Simon Timothy | Geschäftsführer | 51 Cobbold Road W12 9LA London | England | British | Company Director | 121068530001 | ||||
VIGORS, Oliver Richard | Geschäftsführer | 20 Cranley Place SW7 3NH London | British | Sales Director | 21902980005 | |||||
ASHCROFT CAMERON NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 4 Rivers House Fentiman Walk SG14 1DB Hertford Hertfordshire | 900004520001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei 333 ESTATES LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farm Street Inns Limited | 01. Juli 2016 | 209 St. John's Hill SW11 1TH London Studios C & D England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
333 Holdings Limited (Application For Strike Off) | 06. Apr. 2016 | 209 St John's Hill SW11 1TH London Studios C & D United Kingdom | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat 333 ESTATES LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 13. Apr. 2017 Geliefert am 19. Apr. 2017 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 31. März 2010 Geliefert am 07. Apr. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 22. Dez. 2008 Geliefert am 24. Dez. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Unit 1 9 devonshire square london. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 06. Juli 2006 Geliefert am 21. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H admiral codrington public house 17 mossop street london t/no BGL31638 and l/h salisbury tavern sherbrooke road london t/no BGL32093. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental deed (to a debenture dated 21ST may 2004) | Erstellt am 16. Aug. 2004 Geliefert am 21. Aug. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage l/h admiral codrington public house 17 mossop street london t/n BGL31638 together with all present and future buildings fixtures including trade and tenant's fixtures and plant and machinery which are at any such property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 21. Mai 2004 Geliefert am 05. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a the salisbury tavern sherbrooke road london t/no BGL32093. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge of licensed premises | Erstellt am 18. Dez. 2001 Geliefert am 29. Dez. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The salisbury tavern 21 sherbrooke road london SW6 7XH l/h t/no: BGL32093. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 03. Aug. 2000 Geliefert am 10. Aug. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/Hold property known as admiral codrington 17 mossop st,london SW3 2LW; BGL31638. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 10. Juli 2000 Geliefert am 14. Juli 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0