PHILIP TOMLINS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePHILIP TOMLINS LIMITED
    UnternehmensstatusUmwandlung / Auflösung
    RechtsformUmwandlung / Auflösung
    Unternehmensnummer 03206191
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PHILIP TOMLINS LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich PHILIP TOMLINS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    New Century House
    Manchester
    M60 4ES
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PHILIP TOMLINS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis11. Jan. 2012

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für PHILIP TOMLINS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für PHILIP TOMLINS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Verschiedenes

    Forms b & z - convert to i&ps
    2 SeitenMISC

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Convert to i&ps 14/08/2012
    RES13

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital10. Aug. 2012

    Kapitalaufstellung am 10. Aug. 2012

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 11. Jan. 2012

    3 SeitenAA

    Ernennung von Andrew Oldale als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Neil Walker als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von David Hendry als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 11. Jan. 2011

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 11. Jan. 2010

    3 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr George Murray Tinning am 31. Juli 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Neil James Walker am 31. Juli 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Samuel Patrick Donald Kershaw am 31. Juli 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr David Buchan Hendry am 31. Juli 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mrs Caroline Jane Sellers am 31. Juli 2010

    2 SeitenCH03

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 10. Jan. 2009

    3 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 12. Jan. 2008

    4 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 11. Jan. 2007

    3 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von PHILIP TOMLINS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SELLERS, Caroline Jane
    c/o C/O Governance Department
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    5th Floor, New Century House
    Sekretär
    c/o C/O Governance Department
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    5th Floor, New Century House
    British45801060004
    KERSHAW, Samuel Patrick Donald
    c/o C/O Governance Department
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    5th Floor, New Century House
    Geschäftsführer
    c/o C/O Governance Department
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    5th Floor, New Century House
    EnglandBritish101845900003
    OLDALE, Andrew
    Brantingham Road
    Chorlton
    M21 0TS Manchester
    15
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Brantingham Road
    Chorlton
    M21 0TS Manchester
    15
    United Kingdom
    EnglandBritish167083200001
    TINNING, George Murray
    c/o C/O Governance Department
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    5th Floor, New Century House
    Geschäftsführer
    c/o C/O Governance Department
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    5th Floor, New Century House
    United KingdomBritish126913730001
    GREENFIELD, Phillip Lee Richard
    Wharf Road
    OX10 7EW Shillingford
    The Nook
    Oxfordshire
    Sekretär
    Wharf Road
    OX10 7EW Shillingford
    The Nook
    Oxfordshire
    British161062970001
    MITCHELL, Clare Marion
    111 Wolsey Drive
    KT2 5DR Kingston
    Surrey
    Sekretär
    111 Wolsey Drive
    KT2 5DR Kingston
    Surrey
    British72762420001
    PANTELI, Andreas
    61 Ashley Road
    KT18 5BN Epsom
    Surrey
    Sekretär
    61 Ashley Road
    KT18 5BN Epsom
    Surrey
    British109275700001
    TOMLINS, Catherine Mary
    White Gates
    Dumbleton
    WR11 6TQ Evesham
    Worcestershire
    Sekretär
    White Gates
    Dumbleton
    WR11 6TQ Evesham
    Worcestershire
    British48020890001
    SAME-DAY COMPANY SERVICES LIMITED
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    Bevollmächtigter Sekretär
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    900000980001
    CARPENTER, Paul Kenneth Christopher
    Grasmere
    36 Chester Road
    SK12 1EU Poyton
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Grasmere
    36 Chester Road
    SK12 1EU Poyton
    Cheshire
    British119893930001
    GREENFIELD, Phillip Lee Richard
    Wharf Road
    OX10 7EW Shillingford
    The Nook
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Wharf Road
    OX10 7EW Shillingford
    The Nook
    Oxfordshire
    EnglandBritish161062970001
    HENDRY, David Buchan
    c/o C/O Governance Department
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    5th Floor, New Century House
    Geschäftsführer
    c/o C/O Governance Department
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    5th Floor, New Century House
    ScotlandBritish128555100001
    HENDRY, David Buchan
    Cardney Estate
    Butterstone
    PH8 0EY By Dunkeld
    Over Cardney Farmhouse
    Perthshire
    Geschäftsführer
    Cardney Estate
    Butterstone
    PH8 0EY By Dunkeld
    Over Cardney Farmhouse
    Perthshire
    ScotlandBritish128555100001
    HEWITT, Paul William
    Hough Hall
    Newcastle Road Hough
    CW2 5JG Crewe
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Hough Hall
    Newcastle Road Hough
    CW2 5JG Crewe
    Cheshire
    EnglandBritish163759450001
    HULME, Martyn Alan
    20 Walton Heath Drive
    SK10 2QN Macclesfield
    Cheshire
    Geschäftsführer
    20 Walton Heath Drive
    SK10 2QN Macclesfield
    Cheshire
    United KingdomBritish77326830003
    JEYNES, Martyn Richard
    Allendale Windmill Lane
    WR7 4HG Inkberrow
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Allendale Windmill Lane
    WR7 4HG Inkberrow
    Worcestershire
    British48020960001
    TINNING, George Murray
    17 Briar Road
    Kirkintilloch
    G66 3SA Glasgow
    Geschäftsführer
    17 Briar Road
    Kirkintilloch
    G66 3SA Glasgow
    United KingdomBritish126913730001
    TOMLINS, Philip David
    Clare Villa
    112 Westwood Road, Ebley
    GL5 4ST Stroud
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Clare Villa
    112 Westwood Road, Ebley
    GL5 4ST Stroud
    Gloucestershire
    United KingdomBritish123902780002
    WALKER, Neil James
    c/o C/O Governance Department
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    5th Floor, New Century House
    Geschäftsführer
    c/o C/O Governance Department
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    5th Floor, New Century House
    EnglandBritish126913860001
    WILDMAN & BATTELL LIMITED
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    900000970001

    Hat PHILIP TOMLINS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 21. Apr. 2004
    Geliefert am 28. Apr. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 08. Okt. 1999
    Geliefert am 28. Okt. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 36 and 37 the leys evesham worcestershire. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Okt. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Apr. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 08. Okt. 1999
    Geliefert am 28. Okt. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 1 northwick road evesham worcestershire. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Okt. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Apr. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 08. Aug. 1996
    Geliefert am 21. Aug. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Aug. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Apr. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0