PHILIP TOMLINS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PHILIP TOMLINS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Umwandlung / Auflösung |
| Rechtsform | Umwandlung / Auflösung |
| Unternehmensnummer | 03206191 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PHILIP TOMLINS LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich PHILIP TOMLINS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | New Century House Manchester M60 4ES |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PHILIP TOMLINS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 11. Jan. 2012 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für PHILIP TOMLINS LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für PHILIP TOMLINS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verschiedenes Forms b & z - convert to i&ps | 2 Seiten | MISC | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 11. Jan. 2012 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Andrew Oldale als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Neil Walker als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Hendry als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 11. Jan. 2011 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 11. Jan. 2010 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr George Murray Tinning am 31. Juli 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Neil James Walker am 31. Juli 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Samuel Patrick Donald Kershaw am 31. Juli 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr David Buchan Hendry am 31. Juli 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mrs Caroline Jane Sellers am 31. Juli 2010 | 2 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 10. Jan. 2009 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 12. Jan. 2008 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 11. Jan. 2007 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PHILIP TOMLINS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELLERS, Caroline Jane | Sekretär | c/o C/O Governance Department Corporation Street M60 4ES Manchester 5th Floor, New Century House | British | 45801060004 | ||||||
| KERSHAW, Samuel Patrick Donald | Geschäftsführer | c/o C/O Governance Department Corporation Street M60 4ES Manchester 5th Floor, New Century House | England | British | 101845900003 | |||||
| OLDALE, Andrew | Geschäftsführer | Brantingham Road Chorlton M21 0TS Manchester 15 United Kingdom | England | British | 167083200001 | |||||
| TINNING, George Murray | Geschäftsführer | c/o C/O Governance Department Corporation Street M60 4ES Manchester 5th Floor, New Century House | United Kingdom | British | 126913730001 | |||||
| GREENFIELD, Phillip Lee Richard | Sekretär | Wharf Road OX10 7EW Shillingford The Nook Oxfordshire | British | 161062970001 | ||||||
| MITCHELL, Clare Marion | Sekretär | 111 Wolsey Drive KT2 5DR Kingston Surrey | British | 72762420001 | ||||||
| PANTELI, Andreas | Sekretär | 61 Ashley Road KT18 5BN Epsom Surrey | British | 109275700001 | ||||||
| TOMLINS, Catherine Mary | Sekretär | White Gates Dumbleton WR11 6TQ Evesham Worcestershire | British | 48020890001 | ||||||
| SAME-DAY COMPANY SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 9 Perseverance Works Kingsland Road E2 8DD London | 900000980001 | |||||||
| CARPENTER, Paul Kenneth Christopher | Geschäftsführer | Grasmere 36 Chester Road SK12 1EU Poyton Cheshire | British | 119893930001 | ||||||
| GREENFIELD, Phillip Lee Richard | Geschäftsführer | Wharf Road OX10 7EW Shillingford The Nook Oxfordshire | England | British | 161062970001 | |||||
| HENDRY, David Buchan | Geschäftsführer | c/o C/O Governance Department Corporation Street M60 4ES Manchester 5th Floor, New Century House | Scotland | British | 128555100001 | |||||
| HENDRY, David Buchan | Geschäftsführer | Cardney Estate Butterstone PH8 0EY By Dunkeld Over Cardney Farmhouse Perthshire | Scotland | British | 128555100001 | |||||
| HEWITT, Paul William | Geschäftsführer | Hough Hall Newcastle Road Hough CW2 5JG Crewe Cheshire | England | British | 163759450001 | |||||
| HULME, Martyn Alan | Geschäftsführer | 20 Walton Heath Drive SK10 2QN Macclesfield Cheshire | United Kingdom | British | 77326830003 | |||||
| JEYNES, Martyn Richard | Geschäftsführer | Allendale Windmill Lane WR7 4HG Inkberrow Worcestershire | British | 48020960001 | ||||||
| TINNING, George Murray | Geschäftsführer | 17 Briar Road Kirkintilloch G66 3SA Glasgow | United Kingdom | British | 126913730001 | |||||
| TOMLINS, Philip David | Geschäftsführer | Clare Villa 112 Westwood Road, Ebley GL5 4ST Stroud Gloucestershire | United Kingdom | British | 123902780002 | |||||
| WALKER, Neil James | Geschäftsführer | c/o C/O Governance Department Corporation Street M60 4ES Manchester 5th Floor, New Century House | England | British | 126913860001 | |||||
| WILDMAN & BATTELL LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 9 Perseverance Works Kingsland Road E2 8DD London | 900000970001 |
Hat PHILIP TOMLINS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 21. Apr. 2004 Geliefert am 28. Apr. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 08. Okt. 1999 Geliefert am 28. Okt. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a 36 and 37 the leys evesham worcestershire. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 08. Okt. 1999 Geliefert am 28. Okt. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a 1 northwick road evesham worcestershire. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 08. Aug. 1996 Geliefert am 21. Aug. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0