TARGETFOLLOW (WARRINGTON) LIMITED

TARGETFOLLOW (WARRINGTON) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTARGETFOLLOW (WARRINGTON) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03206425
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TARGETFOLLOW (WARRINGTON) LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich TARGETFOLLOW (WARRINGTON) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Riverside House
    11-12 Riverside Road
    NR1 1SQ Norwich
    Norfolk
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TARGETFOLLOW (WARRINGTON) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für TARGETFOLLOW (WARRINGTON) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital10. Juni 2013

    Kapitalaufstellung am 10. Juni 2013

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. März 2012 bis 30. Sept. 2012

    3 SeitenAA01

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Peter Allan Dawson am 16. Dez. 2011

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011

    17 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Peter Allan Dawson am 29. Okt. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Paul Laurence Huberman am 29. Okt. 2010

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010

    17 SeitenAA

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Änderung der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Beendigung der Bestellung von Ardeshir Naghshineh als Sekretär

    2 SeitenTM02

    Ernennung von Mr Peter Allan Dawson als Direktor

    3 SeitenAP01

    Ernennung von Paul Laurence Huberman als Direktor

    3 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Shapoor Naghshineh als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Ardeshir Naghshineh als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Vanessa Fletcher als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Ian Fox als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009

    17 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008

    17 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    Wer sind die Geschäftsführer von TARGETFOLLOW (WARRINGTON) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DAWSON, Peter Allan
    Montreal Road
    TN13 2EP Sevenoaks
    Oak Beams
    Kent
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Montreal Road
    TN13 2EP Sevenoaks
    Oak Beams
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Surveyor155666140002
    HUBERMAN, Paul Laurence
    Wildwood Road
    NW11 6UL London
    15
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Wildwood Road
    NW11 6UL London
    15
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant3470530003
    NAGHSHINEH, Ardeshir
    Mergate Farmhouse
    Mergate Lane Bracon Ash
    NR14 8ER Norwich
    Norfolk
    Sekretär
    Mergate Farmhouse
    Mergate Lane Bracon Ash
    NR14 8ER Norwich
    Norfolk
    BritishProperty Consultant60588430004
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Bevollmächtigter Sekretär
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    BULLUS, Thomas Andrew
    The Cottage
    West Drive
    GU25 4NA Virginia Water
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Cottage
    West Drive
    GU25 4NA Virginia Water
    Surrey
    BritishInsurance Consultant15754510005
    FLETCHER, Vanessa Anne
    Wrentham House
    86 Southwold Road, Wrentham
    NR34 7JF Beccles
    Geschäftsführer
    Wrentham House
    86 Southwold Road, Wrentham
    NR34 7JF Beccles
    EnglandBritishChartered Accountant101139900001
    FOX, Ian Stuart
    Dove Barn
    Queen's Road Hethersett
    NR9 3DB Norwich
    Geschäftsführer
    Dove Barn
    Queen's Road Hethersett
    NR9 3DB Norwich
    EnglandBritishProperty Developer154671930001
    MCDOUGALL, Kenneth Alan
    Manor Farm
    Colby
    NR11 7EE Norwich
    Geschäftsführer
    Manor Farm
    Colby
    NR11 7EE Norwich
    EnglandBritishBusinessman30058720002
    NAGHSHINEH, Ardeshir
    Mergate Farmhouse
    Mergate Lane Bracon Ash
    NR14 8ER Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Mergate Farmhouse
    Mergate Lane Bracon Ash
    NR14 8ER Norwich
    Norfolk
    EnglandBritishProperty Consultant60588430004
    NAGHSHINEH, Shapoor
    The Old Hall
    Church Lane Barford
    NR9 4AY Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    The Old Hall
    Church Lane Barford
    NR9 4AY Norwich
    Norfolk
    EnglandBritishDirector52621450004
    NAGHSHINEH, Shapoor
    13 Bury Street
    NR2 2DJ Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    13 Bury Street
    NR2 2DJ Norwich
    Norfolk
    AmericanCompany Director52621450001
    WILD, Neil
    24 Beatrice Road
    NR1 4BB Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    24 Beatrice Road
    NR1 4BB Norwich
    Norfolk
    BritishChartered Surveyor67690810001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    Hat TARGETFOLLOW (WARRINGTON) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 24. Mai 2005
    Geliefert am 06. Juni 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land at st james' court wilderspool causeway warrington t/no CH401914 and the ancillary rights. By way of fixed charge all plant machinery and chattels, all monies standing to the credit of each account, all rental income, its goodwill and uncalled capital. By way of assignment the benefit and rights under any agreement and all other contracts, the benefit and claims under or in respect of the specified insurances and rental income. By way of floating charge the undertaking property rights and assets.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Security Trustee for the Financeparties (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 06. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 19. Juli 2002
    Geliefert am 26. Juli 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h property being st james' court wilderpool causeway warrington t/n CH401914. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Security Trustee for the Financeparties
    Transaktionen
    • 26. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Third party debenture
    Erstellt am 15. Feb. 2001
    Geliefert am 01. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities owed jointly and severally or in any other capacity whatsoever of targetfollow group limited (the "borrower") and the company to the chargees from time to time under such finance document
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Morgan Stanley Mortgage Servicing Limited (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 01. März 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Aug. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security agreement
    Erstellt am 15. Dez. 1999
    Geliefert am 29. Dez. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from bloomsbury property investments limited and the company to the chargee as agent and trustee for the finance parties (as defined in the credit agreement dated 15TH december 1999 under each finance document (as defined)
    Kurze Angaben
    F/H property and buildings k/a st james court wilderspool causeway warrington t/no: CH401914 .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 29. Dez. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. März 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 05. März 1999
    Geliefert am 17. März 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 17. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Dez. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. März 1999
    Geliefert am 17. März 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property known as st james court wilderspool causeway, warrington title number CH401914. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 17. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Dez. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over rent account
    Erstellt am 29. Juli 1996
    Geliefert am 02. Aug. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to, or in connection with, the finance documents (including without limitation, the debenture) (the "secured obligations")
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge the deposited monies and all the right title benefit and interest of the borrower whatsoever present and future therein together with any certificates of deposit,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Hypothekenbank Frankfurt A.G.
    Transaktionen
    • 02. Aug. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. März 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment of rents
    Erstellt am 29. Juli 1996
    Geliefert am 02. Aug. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to, or in connection with, the finance documents (including without limitation, the debenture) (the "secured obligations")
    Kurze Angaben
    All the borrower's right title and interest present and future, in and to the rents. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Hypothekenbank Frankfurt A.G.
    Transaktionen
    • 02. Aug. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. März 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 29. Juli 1996
    Geliefert am 02. Aug. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to, or in connection with, the finance documents (including without limitation, the debenture) (the "secured obligations")
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Hypothekenbank Frankfurt A.G.
    Transaktionen
    • 02. Aug. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. März 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0