TARGETFOLLOW (WARRINGTON) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | TARGETFOLLOW (WARRINGTON) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03206425 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TARGETFOLLOW (WARRINGTON) LIMITED?
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich TARGETFOLLOW (WARRINGTON) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Riverside House 11-12 Riverside Road NR1 1SQ Norwich Norfolk |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TARGETFOLLOW (WARRINGTON) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TARGETFOLLOW (WARRINGTON) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. März 2012 bis 30. Sept. 2012 | 3 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Peter Allan Dawson am 16. Dez. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Peter Allan Dawson am 29. Okt. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Paul Laurence Huberman am 29. Okt. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ardeshir Naghshineh als Sekretär | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Peter Allan Dawson als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Paul Laurence Huberman als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Shapoor Naghshineh als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ardeshir Naghshineh als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Vanessa Fletcher als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ian Fox als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TARGETFOLLOW (WARRINGTON) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAWSON, Peter Allan | Geschäftsführer | Montreal Road TN13 2EP Sevenoaks Oak Beams Kent United Kingdom | England | British | Chartered Surveyor | 155666140002 | ||||
HUBERMAN, Paul Laurence | Geschäftsführer | Wildwood Road NW11 6UL London 15 United Kingdom | England | British | Chartered Accountant | 3470530003 | ||||
NAGHSHINEH, Ardeshir | Sekretär | Mergate Farmhouse Mergate Lane Bracon Ash NR14 8ER Norwich Norfolk | British | Property Consultant | 60588430004 | |||||
HALLMARK SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 120 East Road N1 6AA London | 900004100001 | |||||||
BULLUS, Thomas Andrew | Geschäftsführer | The Cottage West Drive GU25 4NA Virginia Water Surrey | British | Insurance Consultant | 15754510005 | |||||
FLETCHER, Vanessa Anne | Geschäftsführer | Wrentham House 86 Southwold Road, Wrentham NR34 7JF Beccles | England | British | Chartered Accountant | 101139900001 | ||||
FOX, Ian Stuart | Geschäftsführer | Dove Barn Queen's Road Hethersett NR9 3DB Norwich | England | British | Property Developer | 154671930001 | ||||
MCDOUGALL, Kenneth Alan | Geschäftsführer | Manor Farm Colby NR11 7EE Norwich | England | British | Businessman | 30058720002 | ||||
NAGHSHINEH, Ardeshir | Geschäftsführer | Mergate Farmhouse Mergate Lane Bracon Ash NR14 8ER Norwich Norfolk | England | British | Property Consultant | 60588430004 | ||||
NAGHSHINEH, Shapoor | Geschäftsführer | The Old Hall Church Lane Barford NR9 4AY Norwich Norfolk | England | British | Director | 52621450004 | ||||
NAGHSHINEH, Shapoor | Geschäftsführer | 13 Bury Street NR2 2DJ Norwich Norfolk | American | Company Director | 52621450001 | |||||
WILD, Neil | Geschäftsführer | 24 Beatrice Road NR1 4BB Norwich Norfolk | British | Chartered Surveyor | 67690810001 | |||||
HALLMARK REGISTRARS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 120 East Road N1 6AA London | 900004090001 |
Hat TARGETFOLLOW (WARRINGTON) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 24. Mai 2005 Geliefert am 06. Juni 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land at st james' court wilderspool causeway warrington t/no CH401914 and the ancillary rights. By way of fixed charge all plant machinery and chattels, all monies standing to the credit of each account, all rental income, its goodwill and uncalled capital. By way of assignment the benefit and rights under any agreement and all other contracts, the benefit and claims under or in respect of the specified insurances and rental income. By way of floating charge the undertaking property rights and assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 19. Juli 2002 Geliefert am 26. Juli 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The f/h property being st james' court wilderpool causeway warrington t/n CH401914. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Third party debenture | Erstellt am 15. Feb. 2001 Geliefert am 01. März 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities owed jointly and severally or in any other capacity whatsoever of targetfollow group limited (the "borrower") and the company to the chargees from time to time under such finance document | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security agreement | Erstellt am 15. Dez. 1999 Geliefert am 29. Dez. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities due or to become due from bloomsbury property investments limited and the company to the chargee as agent and trustee for the finance parties (as defined in the credit agreement dated 15TH december 1999 under each finance document (as defined) | |
Kurze Angaben F/H property and buildings k/a st james court wilderspool causeway warrington t/no: CH401914 .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 05. März 1999 Geliefert am 17. März 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 05. März 1999 Geliefert am 17. März 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The freehold property known as st james court wilderspool causeway, warrington title number CH401914. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge over rent account | Erstellt am 29. Juli 1996 Geliefert am 02. Aug. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to, or in connection with, the finance documents (including without limitation, the debenture) (the "secured obligations") | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge the deposited monies and all the right title benefit and interest of the borrower whatsoever present and future therein together with any certificates of deposit,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of assignment of rents | Erstellt am 29. Juli 1996 Geliefert am 02. Aug. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to, or in connection with, the finance documents (including without limitation, the debenture) (the "secured obligations") | |
Kurze Angaben All the borrower's right title and interest present and future, in and to the rents. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 29. Juli 1996 Geliefert am 02. Aug. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to, or in connection with, the finance documents (including without limitation, the debenture) (the "secured obligations") | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0