ORBIS SECURITY SYSTEMS LIMITED

ORBIS SECURITY SYSTEMS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameORBIS SECURITY SYSTEMS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03206562
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ORBIS SECURITY SYSTEMS LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich ORBIS SECURITY SYSTEMS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Security House The Summit
    Hanworth Road
    TW16 5DB Sunbury On Thames
    Middlesex
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ORBIS SECURITY SYSTEMS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ORBIS ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS LIMITED07. März 199707. März 1997
    ORBIS ELECTRONIC SYSTEMS LIMITED15. Aug. 199615. Aug. 1996
    DE FACTO 509 LIMITED03. Juni 199603. Juni 1996

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ORBIS SECURITY SYSTEMS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für ORBIS SECURITY SYSTEMS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2008

    5 SeitenAA

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    legacy

    1 SeitenCAP-MDSC

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten353

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2007

    5 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten353

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2006

    5 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2005

    5 SeitenAA

    Gesellschaftsvertrag und Satzung

    13 SeitenMA

    legacy

    3 Seiten363s

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2004

    5 SeitenAA

    legacy

    7 Seiten363s

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2003

    5 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von ORBIS SECURITY SYSTEMS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ALPHONSUS, Anton Bernard
    Security House The Summit
    Hanworth Road
    TW16 5DB Sunbury On Thames
    Middlesex
    Sekretär
    Security House The Summit
    Hanworth Road
    TW16 5DB Sunbury On Thames
    Middlesex
    British79364980002
    ALPHONSUS, Anton Bernard
    Security House The Summit
    Hanworth Road
    TW16 5DB Sunbury On Thames
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Security House The Summit
    Hanworth Road
    TW16 5DB Sunbury On Thames
    Middlesex
    EnglandBritish79364980002
    KAYE, David Leo
    Security House
    The Summit Hanworth Road
    TW16 5DB Sunbury On Thames
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Security House
    The Summit Hanworth Road
    TW16 5DB Sunbury On Thames
    Middlesex
    EnglandBritish76947780002
    DIBBLE, Keith George
    8 Newcastle Avenue
    IG6 3EE Ilford
    Essex
    Sekretär
    8 Newcastle Avenue
    IG6 3EE Ilford
    Essex
    British82410610001
    GODFRAY, Terence William
    39 Robin Lane
    GU47 9AU Sandhurst
    Berkshire
    Sekretär
    39 Robin Lane
    GU47 9AU Sandhurst
    Berkshire
    British63510007
    HOW, David Alfred George, Mr.
    Michaelmas Fair
    Ashdon
    CB10 2JE Saffron Walden
    Essex
    Sekretär
    Michaelmas Fair
    Ashdon
    CB10 2JE Saffron Walden
    Essex
    British21860001
    RANDALL, Martin Keith
    Jacks Platt
    Duddleswell
    TN22 3JR Uckfield
    East Sussex
    Sekretär
    Jacks Platt
    Duddleswell
    TN22 3JR Uckfield
    East Sussex
    British40012240002
    TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Bevollmächtigter Sekretär
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    900006100001
    BRENTNALL, Trevor Alan
    Dolloways House
    Howbourne Lane
    TN22 4DR Buxted
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Dolloways House
    Howbourne Lane
    TN22 4DR Buxted
    East Sussex
    British39686000001
    CHILD, Colin
    113 Moorgate Road
    Kippax
    LS25 7ET Leeds
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    113 Moorgate Road
    Kippax
    LS25 7ET Leeds
    Yorkshire
    British58605420002
    DAVIS, Barry John
    7 Hever Close
    SS5 4XB Hockley
    Essex
    Geschäftsführer
    7 Hever Close
    SS5 4XB Hockley
    Essex
    British58605340002
    FARRANT, Stephen Ben
    26 Moorside
    S10 4LN Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    26 Moorside
    S10 4LN Sheffield
    South Yorkshire
    British74798610001
    MCNUTT, Alexander Samuel
    8 Wood Aven Drive
    Stewartfield
    G74 4UE East Kilbride
    Lanarkshire
    Geschäftsführer
    8 Wood Aven Drive
    Stewartfield
    G74 4UE East Kilbride
    Lanarkshire
    British113348780001
    QUINLAN, Ian
    52 Bears Rails Park
    Old Windsor
    SL4 2HN Windsor
    Berkshire
    Geschäftsführer
    52 Bears Rails Park
    Old Windsor
    SL4 2HN Windsor
    Berkshire
    British2521720002
    RANDALL, Martin Keith
    Jacks Platt
    Duddleswell
    TN22 3JR Uckfield
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Jacks Platt
    Duddleswell
    TN22 3JR Uckfield
    East Sussex
    United KingdomBritish40012240002
    RICHES, Alan
    Abbots Court Farm
    Priory Road Tiptree
    CO5 0QE Colchester
    Essex
    Geschäftsführer
    Abbots Court Farm
    Priory Road Tiptree
    CO5 0QE Colchester
    Essex
    British23383240001
    ROBERTS, David Edward
    5 Garricks Villa
    Hampton Court Road
    TW12 2EJ Hampton
    Middlesex
    Geschäftsführer
    5 Garricks Villa
    Hampton Court Road
    TW12 2EJ Hampton
    Middlesex
    British58549730002
    SCOTT, Ian
    67 Willow Lane
    Milton
    OX14 4EG Abingdon
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    67 Willow Lane
    Milton
    OX14 4EG Abingdon
    Oxfordshire
    British47244190002
    STEWART, Michael Henley
    Heathlands Keepers Lane
    Hyde Heath
    HP6 5RJ Amersham
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Heathlands Keepers Lane
    Hyde Heath
    HP6 5RJ Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish6788520001
    WEBSTER, Richard John
    21 Belfield Road
    M20 6BJ Manchester
    Lancashire
    Geschäftsführer
    21 Belfield Road
    M20 6BJ Manchester
    Lancashire
    EnglandBritish143663270001
    TRAVERS SMITH LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    900006090001
    TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    900006100001

    Hat ORBIS SECURITY SYSTEMS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 20. Aug. 1999
    Geliefert am 28. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    In favour of the chargee by clause 2.1 of the debenture, the company (a) covenanted and undertook that it will on demand in writing made to it by the security trustee pay or discharge to the security trustee all money and liabilities on or after the date of the debenture due, owing or incurred to each beneficiary by the company under or pursuant to the senior finance documents; (b) covenanted, undertook and guaranteed that it will on demand in writing made to it by the security trustee pay or discharge to the security trustee all money and liabilities on or after the date of the debenture due, owing or incurred to each beneficiary by each other company (except as a guarantor for the company) under or pursuant to the senior finance documents
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage all f/h and l/h land in england and wales; by way of first fixed charge all plant and machinery goodwill and uncalled capital book and other debts; by way of first floaitng charge all assets owned by the chargor except to the extent that such assets are for the time being effectively charged by any fixed charge referred to above,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dresdner Bank Ag (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 28. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Juni 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture supplemental to a composite guarantee and debenture dated 24TH october 1997
    Erstellt am 25. Jan. 1999
    Geliefert am 25. Jan. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Each and every liability due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the beneficiaries (as defined) or any of the other beneficiaries on the terms and conditions set out in the debenture and the guarantee and debenture under or pursuant to the facility documents (as defined) including any liability in respect of any further advances made thereunder and every sum (of principal interest or otherwise) now or hereafter owing due or incurred by the company to the security trustee (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries in respect of such liabilities
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Investment Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Sept. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A composite guarantee and debenture
    Erstellt am 24. Okt. 1997
    Geliefert am 07. Nov. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Each and every liability due from the company to hsbc investment bank PLC (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries (and whether solely or jointly with one or more persons and whether as principal or as surety) under or pursuant to the facility documents (as defined) including any liability in respect of any further advances made thereunder and every sum (of principal, interest or otherwise) now or hereafter owing, due or incurred by the company to the security trustee (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries in respect of such liabilities
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge its real property; all its tangible movable property not assigned pursuant to clause 6.1(b) of the guarantee and debenture and all goodwill; by way of first floating charge the whole of its undertaking and assets present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Investment Bank Plcas Security Trustee for the Beneficiaries on the Terms and Conditions Set Out in the Guarantee and Debenture
    Transaktionen
    • 07. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Sept. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 03. Okt. 1996
    Geliefert am 16. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Nov. 1997Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 25. Mai 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0