DOWNTREE CONSULTANTS LIMITED

DOWNTREE CONSULTANTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameDOWNTREE CONSULTANTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03207291
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von DOWNTREE CONSULTANTS LIMITED?

    • Vermietung und Verpachtung von Immobilien von Wohnungsbaugesellschaften (68201) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich DOWNTREE CONSULTANTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von DOWNTREE CONSULTANTS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    UPGROVE PROPERTIES (FINLAND) LIMITED17. Juni 199617. Juni 1996
    VALERANGE LIMITED04. Juni 199604. Juni 1996

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DOWNTREE CONSULTANTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2013

    Welche sind die letzten Einreichungen für DOWNTREE CONSULTANTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    12 SeitenLIQ14

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. März 2017

    10 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 06. Mai 2016

    10 Seiten3.6

    Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager

    4 SeitenRM02

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. März 2016

    8 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. März 2016

    12 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Guardian Business Recovery 72 Temple Chambers Temple Avenue London EC4Y 0HP zum 150 Aldersgate Street London EC1A 4AB am 11. Apr. 2016

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Bescheinigung über die Abberufung des freiwilligen Liquidators

    1 Seiten4.38

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 08. Jan. 2016

    12 Seiten3.6

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 6 Snow Hill London EC1A 2AY zum Guardian Business Recovery 72 Temple Chambers Temple Avenue London EC4Y 0HP am 18. Jan. 2016

    1 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Palladium House 1/4 Argyll Street London W1F 7LD zum 6 Snow Hill London EC1A 2AY am 13. Apr. 2015

    2 SeitenAD01

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    6 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 26. März 2015

    LRESEX

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed upgrove properties (finland) LIMITED\certificate issued on 04/02/15
    3 SeitenCERTNM
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name04. Feb. 2015

    Namensänderung durch Beschluss

    NM01
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 02. Feb. 2015

    RES15

    Ernennung eines Receivers oder Managers

    4 SeitenRM01

    Jahresrückblick erstellt bis 04. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital26. Juni 2014

    Kapitalaufstellung am 26. Juni 2014

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr David Mckenzie Spence am 03. Juni 2014

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr David Mckenzie Spence am 03. Juni 2014

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Sekretärs für Sary Eleini am 03. Juni 2014

    1 SeitenCH03

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2013

    16 SeitenAA

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. März 2013 bis 30. Sept. 2013

    1 SeitenAA01

    Jahresrückblick erstellt bis 04. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Wer sind die Geschäftsführer von DOWNTREE CONSULTANTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ELEINI, Sary
    Avenue Road
    NW8 6DD London
    35 St Stephens Close
    England
    Sekretär
    Avenue Road
    NW8 6DD London
    35 St Stephens Close
    England
    British61890910001
    SPENCE, David Mckenzie
    Smythies Avenue
    CO1 2UR Colchester
    15
    England
    Sekretär
    Smythies Avenue
    CO1 2UR Colchester
    15
    England
    BritishDirector142855850001
    ELEINI, Murad Isaac
    Apartment 13b Edeficio Pichincha
    Avenida Libertador La Florida Sul
    Venezuela
    Geschäftsführer
    Apartment 13b Edeficio Pichincha
    Avenida Libertador La Florida Sul
    Venezuela
    VenezuelaItalianDirector62577230001
    SPENCE, David Mckenzie
    Smythies Avenue
    CO1 2UR Colchester
    15
    England
    Geschäftsführer
    Smythies Avenue
    CO1 2UR Colchester
    15
    England
    United KingdomBritishDirector142855850003
    NOTEHOLD LIMITED
    6 Stoke Newington Road
    N16 7XN London
    Bevollmächtigter Sekretär
    6 Stoke Newington Road
    N16 7XN London
    900002210001
    NOTEHURST LIMITED
    6 Stoke Newington Road
    N16 7XN London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    6 Stoke Newington Road
    N16 7XN London
    900002200001

    Hat DOWNTREE CONSULTANTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture (floating charge)
    Erstellt am 19. Sept. 2005
    Geliefert am 29. Sept. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    With full title guarantee charges by way of first floating charge all property and assets both present and future and from time to time owned by the company or in which the company may have an interest.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 29. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Sept. 2005
    Geliefert am 29. Sept. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 5 new conduit street, kings lynn t/no NK191211, f/h property k/a 9 london road, bognor regis t/no WSX254951, f/h property k/a 27A market place, great yarmouth t/no NK56600 for details of further property charged please refer to form 395. together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 29. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 116. Jan. 2015Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (RM01)
    • 117. Mai 2016Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (RM02)
      • Aktenzeichen 1
    Legal charge
    Erstellt am 09. Mai 2002
    Geliefert am 29. Mai 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All that f/h property k/a 14 buttermarket bury st edmonds suffolk t/n SK161632 with all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time thereon.fixed charge and assignment the aggregate of the gross rents licence fees and monies receivable now or at any time in the future.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Nordea Bank Finland PLC
    Transaktionen
    • 29. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Juli 1999
    Geliefert am 09. Juli 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that f/h property k/a 99 high street southend on sea essex.t/no EX123999 with all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time thereon.fixed charge and assignment the aggregate of the gross rents licence fees and monies receivable now or at any time in the future.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Merita Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Juni 1999
    Geliefert am 02. Juli 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H 27A market place great yarmouth l/b norfolk-NK56600. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Merita Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Jan. 1999
    Geliefert am 11. Jan. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 9 london road bognor regis west sussex with all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time thereon by way of a first fixed charge and assignment the aggregate of the gross rents licence fees and monies receivable now or at any time in the future arising out of any and all licences leases in respect of the property by way of a first floating charge all plant machinery implements utensils furniture and equipment from time to time all right title and interest in and to any proceeds of any insurance by way of assignment all the companys right title benefit and interest in all monies which are at any time payable to it under any interest rate protection agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Merita Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 25. Juni 1996
    Geliefert am 28. Juni 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of a first floating charge:- (I) all book debts and other debts now and from time to time due or owing to the company (ii) all the goodwill and uncalled capital of the company (iii) all the remaning undertaking property and assets of the company whatsoever and wheresoever both present and future.
    Berechtigte Personen
    • Merita Bank LTD
    Transaktionen
    • 28. Juni 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Sept. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge on bank accounts
    Erstellt am 25. Juni 1996
    Geliefert am 28. Juni 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever (including without limitation, under a facility letter dated 6TH june 1996 addressed by the bank to and receipted in acknowledgement on the 12TH june 1996 by the company relating to a secured credit facility in the maximum amount of £330,000 and including all variations thereto and replacements thereof and all documents expressed to be supplemental thereto)
    Kurze Angaben
    By way of assignment and charge by way of first fixed charge all of the company's rights title and interest in and to all monies now or at any time in the future standing to the credit of all and any current and future bank account of whatsoever nature whether denominated in sterling or in any other currency of the company and/or in which the company is or shall be interested with the bank or any of them.
    Berechtigte Personen
    • Merita Bank LTD
    Transaktionen
    • 28. Juni 1996Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Juni 1996
    Geliefert am 28. Juni 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (I) by way of a fitst legal mortgage all that freehold known as 5 new conduit street kings lynn norfolk with all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time thereon.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Merita Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Juni 1996Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Juni 1996
    Geliefert am 28. Juni 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (I) by way of legal mortgage all that freehold property known as 2/4 minster place ely cambridgeshire t/n-CB192222 with all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Merita Bank LTD
    Transaktionen
    • 28. Juni 1996Registrierung einer Belastung (395)

    Hat DOWNTREE CONSULTANTS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Elaine Tooke
    55 Baker Street
    W1U 8AN London
    Receiver Manager
    55 Baker Street
    W1U 8AN London
    Marc Sirio Nardini
    55 Baker Street
    W1U 8AN London
    Receiver Manager
    55 Baker Street
    W1U 8AN London
    2
    DatumTyp
    26. März 2015Beginn der Liquidation
    18. Jan. 2018Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    John Edmund Paylor
    6 Snow Hill
    EC1A 2AY London
    Praktiker
    6 Snow Hill
    EC1A 2AY London
    Emma Sayers
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Praktiker
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Jeremy Mark Willmont
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Praktiker
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0