EX-RCC SUB-CO LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | EX-RCC SUB-CO LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03208807 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von EX-RCC SUB-CO LIMITED?
- (5530) /
Wo befindet sich EX-RCC SUB-CO LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 8-10 Grosvenor Gardens London SW1W 0DH |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von EX-RCC SUB-CO LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| RICHOUX COFFEE COMPANY LIMITED | 25. Sept. 1996 | 25. Sept. 1996 |
| SANDTABLE LIMITED | 06. Juni 1996 | 06. Juni 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EX-RCC SUB-CO LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 02. Jan. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für EX-RCC SUB-CO LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 02. Jan. 2011 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Stephen Rushworth Smith als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von William Rollason als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Matthew Emerson als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr William Rollason als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Simon George Rowe als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 29. Juni 2010 bis 29. Dez. 2010 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Ernennung von Matthew Charles Emerson als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Hill als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 12 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. Juni 2009 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 22. Juni 2008 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 225 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 24. Juni 2007 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von EX-RCC SUB-CO LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROWE, Simon George | Geschäftsführer | 8-10 Grosvenor Gardens London SW1W 0DH | England | British | 68119020002 | |||||
| SMITH, Stephen Rushworth | Geschäftsführer | Hatton Garden EC1N 8LE London 63-66 | United Kingdom | British | 6894950002 | |||||
| CROXFORD, John Robert | Sekretär | Stanley Court Worcester Road SH2 6SD Sutton 18 Surrey | British | 139724880002 | ||||||
| GAMBLE, Stephen | Sekretär | 92 Bressey Grove South Woodford E18 2HX London | British | 106836430001 | ||||||
| GARDNER, Douglas Charles | Sekretär | 27 Balcombe Road RH16 1NZ Haywards Heath West Sussex | British | 75225920001 | ||||||
| HOLDER, Ian Keith | Sekretär | 39a Great Percy Street WC1X 9RD London | British | 60759970001 | ||||||
| LANGRIDGE, Megan Joy | Sekretär | 42 Everest Drive Hoo St Werburgh ME3 9AW Rochester Kent | British | 86459820005 | ||||||
| RIVERS, Paul Edward | Sekretär | Fox Cottage 1a Abingdon Road Tubney OX13 5QL Abingdon Oxfordshire | British | 62321110002 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| ABRAHAM, Neville Victor | Geschäftsführer | 82 Addison Road W14 8ED London | United Kingdom | British | 10579160002 | |||||
| BASING, Nicholas Andrew | Geschäftsführer | Kinrara Cavendish Road KT13 0JW Weybridge Surrey | British | 89419000001 | ||||||
| DA COSTA, Michael Phillip | Geschäftsführer | 43 Clifton Hill St John Wood NW8 0QE London | British | 26140900001 | ||||||
| DARWIN, Richard James | Geschäftsführer | 25 Meadow Road KT10 0RZ Claygate Surrey | United Kingdom | British | 148079910001 | |||||
| EMERSON, Matthew Charles | Geschäftsführer | Grosvenor Gardens SW1W 0DH London 8-10 | England | British | 61777750002 | |||||
| GARDNER, Douglas Charles | Geschäftsführer | 27 Balcombe Road RH16 1NZ Haywards Heath West Sussex | British | 75225920001 | ||||||
| HILL, Peter Martin | Geschäftsführer | Silver Crescent W4 5SE London 8a | England | British | 130983750001 | |||||
| HOLDER, Ian Keith | Geschäftsführer | Top Flats 55 Lexham Gardens W8 5JS London | British | 60759970002 | ||||||
| ISAACSON, Laurence Ivor | Geschäftsführer | 5 Chalcot Crescent NW1 8YE London | United Kingdom | British | 2996380001 | |||||
| JOFFE, Russel | Geschäftsführer | Apartment 203 Marine Heights 93 Ramatyam 46851 Herzliya Pituach Israel | British | 58916680002 | ||||||
| PAYMAN, Robert Alan | Geschäftsführer | Amberley 11 Ferncroft Avenue NW3 7PG London | British | 61741360001 | ||||||
| RIVERS, Paul Edward | Geschäftsführer | Fox Cottage 1a Abingdon Road Tubney OX13 5QL Abingdon Oxfordshire | England | British | 62321110002 | |||||
| ROLLASON, William | Geschäftsführer | 8-10 Grosvenor Gardens London SW1W 0DH | United Kingdom | British | 140347580001 | |||||
| WILLIAMS, David Grey | Geschäftsführer | Orchard House Shootersway Lane HP4 3NW Berkhamsted Hertfordshire | England | British | 33840400001 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Hat EX-RCC SUB-CO LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 18. Feb. 1998 Geliefert am 05. März 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to a facility letter dated 17TH december 1997 | |
Kurze Angaben Leasehold 171 piccadilly london W1.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture deed | Erstellt am 16. Apr. 1997 Geliefert am 19. Apr. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0