BARNET COPTHALL SOCCER CENTRE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BARNET COPTHALL SOCCER CENTRE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03213650 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BARNET COPTHALL SOCCER CENTRE LIMITED?
- (9999) /
Wo befindet sich BARNET COPTHALL SOCCER CENTRE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Powerleague Soccer Centre Pursley Road NW7 2BB Millhill London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BARNET COPTHALL SOCCER CENTRE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| MILL HILL SOCCER CENTRE LIMITED | 05. Sept. 1996 | 05. Sept. 1996 |
| POWERLEAGUE HENDON LTD | 07. Aug. 1996 | 07. Aug. 1996 |
| CROWNCREST LEISURE LIMITED | 18. Juni 1996 | 18. Juni 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BARNET COPTHALL SOCCER CENTRE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BARNET COPTHALL SOCCER CENTRE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 18. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Sean Tracey am 18. Juni 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Sheena Marion Beckwith am 18. Juni 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mrs Sheena Marion Beckwith am 18. Juni 2010 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2009 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Juni 2008 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2007 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 01. Juli 2006 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 10 Seiten | 363s | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 02. Juli 2005 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
Bescheinigung über die Herabsetzung des gezeichneten Kapitals | 1 Seiten | CERT15 | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | OC138 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BARNET COPTHALL SOCCER CENTRE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECKWITH, Sheena Marion | Sekretär | Powerleague Soccer Centre Pursley Road NW7 2BB Millhill London | British | 77381700002 | ||||||
| BECKWITH, Sheena Marion | Geschäftsführer | Powerleague Soccer Centre Pursley Road NW7 2BB Millhill London | Scotland | British | 77381700002 | |||||
| TRACEY, Sean Paul | Geschäftsführer | Powerleague Soccer Centre Pursley Road NW7 2BB Millhill London | Scotland | British | 105080540001 | |||||
| HALL, Jeremy Clive | Sekretär | 42 Newacres Newburgh WN8 7TU Wigan Lancashire | British | 35444860001 | ||||||
| FIRST SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 72 New Bond Street W1S 1RR London | 900000780001 | |||||||
| BUCHANAN, William Arthur Neil | Geschäftsführer | 3 Westerton Court Clarkston G76 8NG Glasgow Lanarkshire | United Kingdom | British | 67066450003 | |||||
| HALL, Jeremy Clive | Geschäftsführer | 42 Newacres Newburgh WN8 7TU Wigan Lancashire | England | British | 35444860001 | |||||
| MOORE, Adrian Richard | Geschäftsführer | 1 Chaucer Close SL4 3ER Windsor Berkshire | Uk | British | 96121170001 | |||||
| ORMEROD, Warren David | Geschäftsführer | 34 Old Oak Close WS9 8SE Aldridge West Midlands | British | 49052640001 | ||||||
| SELLERS, Philip Edward | Geschäftsführer | Yarrimba 31 Howards Thicket SL9 7NT Gerrards Cross Buckinghamshire | United Kingdom | British | 10598350001 | |||||
| TAYLOR, Alan Lewis | Geschäftsführer | 6 Heathside Close Moor Park HA6 2EQ Northwood Middlesex | British | 4947700001 | ||||||
| FIRST DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 72 New Bond Street W1S 1RR London | 900000770001 |
Hat BARNET COPTHALL SOCCER CENTRE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 02. Dez. 1999 Geliefert am 16. Dez. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee acting for itself and as trustee on behalf of the investors (as defined) under the investment agreement of even date pursuant to the deed of guarantee of even date | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 02. Dez. 1999 Geliefert am 11. Dez. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 02. Aug. 1999 Geliefert am 12. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. Apr. 1998 Geliefert am 02. Mai 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben Excluding the legally charged property and including stocks and shares acquired pursuant to scrip dividends and other than royalties and other sums payable in respect of all intellectual property rights. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 24. Apr. 1998 Geliefert am 02. Mai 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben L/H land at pursley road hendon london borough of barnet. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0