OHI BEAUMONT PARK LTD
Überblick
| Unternehmensname | OHI BEAUMONT PARK LTD |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03213741 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von OHI BEAUMONT PARK LTD?
- Pflegeheime für ältere und behinderte Menschen (87100) / Gesundheits- und Sozialwesen
Wo befindet sich OHI BEAUMONT PARK LTD?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Tower 42 25 Old Broad Street EC2N 1HQ London England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von OHI BEAUMONT PARK LTD?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BEAUMONT PARK LIMITED | 22. Mai 2002 | 22. Mai 2002 |
| PINELAKE CARE LIMITED | 18. Juni 1996 | 18. Juni 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von OHI BEAUMONT PARK LTD?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für OHI BEAUMONT PARK LTD?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 18. Juni 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 21 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 35 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 27. Sept. 2017
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 18. Juni 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Notification of Ohi Healthcare Homes (Central) Ltd as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 1 Seiten | PSC02 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Daniel J Booth am 01. März 2017 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Robert Stephenson am 01. März 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Michael Ritz am 01. März 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Daniel Booth am 01. März 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Citypoint Level 33 1 Ropemaker Street London EC2Y 9UE England zum Tower 42 25 Old Broad Street London EC2N 1HQ am 28. Apr. 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 22 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 32 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||||||||||||||
Zweite Einreichung des Jahresabschlusses bis 18. Juni 2016 | 23 Seiten | RP04AR01 | ||||||||||||||
Zweite Einreichung des Jahresabschlusses bis 18. Juni 2015 | 23 Seiten | RP04AR01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von OHI BEAUMONT PARK LTD?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOOTH, Daniel J | Sekretär | 303 International Circle Suite 200 21030 Hunt Valley Omega Healthcare Investors, Inc. Maryland United States | 197726300001 | |||||||
| BOOTH, Daniel James | Geschäftsführer | 303 International Circle Suite 200 21030 Hunt Valley Omega Healthcare Investors, Inc. Maryland United States | United States | American | 265749890001 | |||||
| RITZ, Michael Daniel | Geschäftsführer | 303 International Circle Suite 200 21030 Hunt Valley Omega Healthcare Investors, Inc. Maryland United States | United States | American | 231342520001 | |||||
| STEPHENSON, Robert | Geschäftsführer | 303 International Circle Suite 200 21030 Hunt Valley Omega Healthcare Investors, Inc. Maryland United States | United States | American | 196594350001 | |||||
| BOCIEK, Martin John | Sekretär | 34 Brockwell MK43 7TD Oakley Bedfordshire | British | 82185990001 | ||||||
| BOGGON, Deirdre Irene | Sekretär | Elmbank 36 London Road St Ippolyts SG4 7NG Hitchin Hertfordshire | British | 51553190001 | ||||||
| CLOUGH, Richard Stanley | Sekretär | Hanini 50 Second Avenue CO13 9LX Frinton On Sea Essex | British | 7897560001 | ||||||
| LOMER, Graham Charles | Sekretär | Aldersgate Street EC1A 4HY London 140 England | British | 96916290001 | ||||||
| WATERLOW SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003950001 | |||||||
| BATES, David John | Geschäftsführer | The Crescent CO13 9AP Frinton-On-Sea 4 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 96384800003 | |||||
| BOCIEK, Martin John | Geschäftsführer | 34 Brockwell MK43 7TD Oakley Bedfordshire | England | British | 82185990001 | |||||
| CHRISTIAN, Deborah Helen | Geschäftsführer | Aldersgate Street EC1A 4HY London 140 England | England | British | 187897170001 | |||||
| CLOUGH, Richard Stanley | Geschäftsführer | Lodge House Lodge Lane Langham CO4 5NE Colchester Essex | England | British | 7897560002 | |||||
| LOMER, Graham Charles | Geschäftsführer | Aldersgate Street EC1A 4HY London 140 England | United Kingdom | British | 147828420021 | |||||
| ROGERS, Pamela Anne | Geschäftsführer | Linden House 40 High Street Roxton MK44 3EB Bedford | British | 63140670001 | ||||||
| STOTT, Yvette Ann | Geschäftsführer | 36 The Paddocks Potton SG19 2QD Sandy Bedfordshire | British | 56606030001 | ||||||
| WARD, Gordon Robert | Geschäftsführer | Rua Do Pombo Corriero Vilamoura, 8125, Quarteira Algarve Portugal | British | 48287480003 | ||||||
| WATERLOW NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003940001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei OHI BEAUMONT PARK LTD?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohi Healthcare Homes (Central) Ltd | 06. Apr. 2016 | 25 Old Broad Street EC2N 1HQ London Tower 42 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat OHI BEAUMONT PARK LTD Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal mortgage | Erstellt am 04. Apr. 2008 Geliefert am 10. Apr. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Mill lane nursing home felixstowe suffolk SK275266; the gables nursing home marine parade great yarmouth norfolk NK338434; fornham house fornham st martin bury st edmunds suffolk SK145383 (for further details of properties charged please refer to form 395) and/or its proceeds of sale. Floating charge its undertaking and all its other property assets and rights whatsoever and wheresoever see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 04. Apr. 2008 Geliefert am 08. Apr. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent and trustee for the finance parties) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Mill lane nursing home felixstowe suffolk t/no SK275266 the gables nursing home marine parade great yarmouth norfolk t/no NK338434 fornham house fornham st martin bury st edmunds suffolk t/no SK145383 for details of further properties charged please refer to form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 04. Aug. 2005 Geliefert am 11. Aug. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 01. Feb. 2002 Geliefert am 12. Feb. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. Feb. 2002 Geliefert am 12. Feb. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage over all that freehold property known as west of shortmead street biggleswade and freehold property on the west side of shortmead street biggleswade. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 26. Sept. 2000 Geliefert am 30. Sept. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The land and buildings on the west side of shortmead st biggleswade known as beaumont park shortmead st biggleswade t/no BD123120 BD127708. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge over chattels | Erstellt am 26. Sept. 2000 Geliefert am 30. Sept. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben With full title guarantee by way of first fixed charge: 1)the fixed assets together with any and all assets subsequently acquired by the company by way of replacement thereof 2)items of real or personal property tangible or intangible . fixed assets: 37 beds 37 wardrobes 37 chairs. For details of further properties charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 21. Aug. 1996 Geliefert am 31. Aug. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The property k/a land and premises at shotmead street, biggleswade bedford t/n's BD123120 and BD127708 assigns the goodwill of the business and the benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Aug. 1996 Geliefert am 31. Aug. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0