OHI BEAUMONT PARK LTD

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameOHI BEAUMONT PARK LTD
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03213741
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von OHI BEAUMONT PARK LTD?

    • Pflegeheime für ältere und behinderte Menschen (87100) / Gesundheits- und Sozialwesen

    Wo befindet sich OHI BEAUMONT PARK LTD?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Tower 42 25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von OHI BEAUMONT PARK LTD?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BEAUMONT PARK LIMITED22. Mai 200222. Mai 2002
    PINELAKE CARE LIMITED18. Juni 199618. Juni 1996

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von OHI BEAUMONT PARK LTD?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für OHI BEAUMONT PARK LTD?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Bestätigungserklärung erstellt am 18. Juni 2018 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    21 SeitenAA

    legacy

    35 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT2

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE2

    legacy

    2 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 27. Sept. 2017

    • Kapital: GBP 1
    5 SeitenSH19

    legacy

    2 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Reduction of share premium account 27/09/2017
    RES13
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Bestätigungserklärung erstellt am 18. Juni 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Notification of Ohi Healthcare Homes (Central) Ltd as a person with significant control on 06. Apr. 2016

    1 SeitenPSC02

    Änderung der Details des Sekretärs für Daniel J Booth am 01. März 2017

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Mr Robert Stephenson am 01. März 2017

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Michael Ritz am 01. März 2017

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Daniel Booth am 01. März 2017

    2 SeitenCH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Citypoint Level 33 1 Ropemaker Street London EC2Y 9UE England zum Tower 42 25 Old Broad Street London EC2N 1HQ am 28. Apr. 2017

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    22 SeitenAA

    legacy

    32 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE2

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT2

    Zweite Einreichung des Jahresabschlusses bis 18. Juni 2016

    23 SeitenRP04AR01

    Zweite Einreichung des Jahresabschlusses bis 18. Juni 2015

    23 SeitenRP04AR01

    Wer sind die Geschäftsführer von OHI BEAUMONT PARK LTD?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BOOTH, Daniel J
    303 International Circle
    Suite 200
    21030 Hunt Valley
    Omega Healthcare Investors, Inc.
    Maryland
    United States
    Sekretär
    303 International Circle
    Suite 200
    21030 Hunt Valley
    Omega Healthcare Investors, Inc.
    Maryland
    United States
    197726300001
    BOOTH, Daniel James
    303 International Circle
    Suite 200
    21030 Hunt Valley
    Omega Healthcare Investors, Inc.
    Maryland
    United States
    Geschäftsführer
    303 International Circle
    Suite 200
    21030 Hunt Valley
    Omega Healthcare Investors, Inc.
    Maryland
    United States
    United StatesAmerican265749890001
    RITZ, Michael Daniel
    303 International Circle
    Suite 200
    21030 Hunt Valley
    Omega Healthcare Investors, Inc.
    Maryland
    United States
    Geschäftsführer
    303 International Circle
    Suite 200
    21030 Hunt Valley
    Omega Healthcare Investors, Inc.
    Maryland
    United States
    United StatesAmerican231342520001
    STEPHENSON, Robert
    303 International Circle
    Suite 200
    21030 Hunt Valley
    Omega Healthcare Investors, Inc.
    Maryland
    United States
    Geschäftsführer
    303 International Circle
    Suite 200
    21030 Hunt Valley
    Omega Healthcare Investors, Inc.
    Maryland
    United States
    United StatesAmerican196594350001
    BOCIEK, Martin John
    34 Brockwell
    MK43 7TD Oakley
    Bedfordshire
    Sekretär
    34 Brockwell
    MK43 7TD Oakley
    Bedfordshire
    British82185990001
    BOGGON, Deirdre Irene
    Elmbank 36 London Road
    St Ippolyts
    SG4 7NG Hitchin
    Hertfordshire
    Sekretär
    Elmbank 36 London Road
    St Ippolyts
    SG4 7NG Hitchin
    Hertfordshire
    British51553190001
    CLOUGH, Richard Stanley
    Hanini 50 Second Avenue
    CO13 9LX Frinton On Sea
    Essex
    Sekretär
    Hanini 50 Second Avenue
    CO13 9LX Frinton On Sea
    Essex
    British7897560001
    LOMER, Graham Charles
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    Sekretär
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    British96916290001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    BATES, David John
    The Crescent
    CO13 9AP Frinton-On-Sea
    4
    Essex
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    The Crescent
    CO13 9AP Frinton-On-Sea
    4
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritish96384800003
    BOCIEK, Martin John
    34 Brockwell
    MK43 7TD Oakley
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    34 Brockwell
    MK43 7TD Oakley
    Bedfordshire
    EnglandBritish82185990001
    CHRISTIAN, Deborah Helen
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    Geschäftsführer
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    EnglandBritish187897170001
    CLOUGH, Richard Stanley
    Lodge House
    Lodge Lane Langham
    CO4 5NE Colchester
    Essex
    Geschäftsführer
    Lodge House
    Lodge Lane Langham
    CO4 5NE Colchester
    Essex
    EnglandBritish7897560002
    LOMER, Graham Charles
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    Geschäftsführer
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    United KingdomBritish147828420021
    ROGERS, Pamela Anne
    Linden House 40 High Street
    Roxton
    MK44 3EB Bedford
    Geschäftsführer
    Linden House 40 High Street
    Roxton
    MK44 3EB Bedford
    British63140670001
    STOTT, Yvette Ann
    36 The Paddocks
    Potton
    SG19 2QD Sandy
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    36 The Paddocks
    Potton
    SG19 2QD Sandy
    Bedfordshire
    British56606030001
    WARD, Gordon Robert
    Rua Do Pombo Corriero
    Vilamoura, 8125, Quarteira
    Algarve
    Portugal
    Geschäftsführer
    Rua Do Pombo Corriero
    Vilamoura, 8125, Quarteira
    Algarve
    Portugal
    British48287480003
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei OHI BEAUMONT PARK LTD?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Ohi Healthcare Homes (Central) Ltd
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    England
    06. Apr. 2016
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageEngland
    RegistrierungsortEngland
    Registrierungsnummer03995046
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat OHI BEAUMONT PARK LTD Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal mortgage
    Erstellt am 04. Apr. 2008
    Geliefert am 10. Apr. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Mill lane nursing home felixstowe suffolk SK275266; the gables nursing home marine parade great yarmouth norfolk NK338434; fornham house fornham st martin bury st edmunds suffolk SK145383 (for further details of properties charged please refer to form 395) and/or its proceeds of sale. Floating charge its undertaking and all its other property assets and rights whatsoever and wheresoever see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 10. Apr. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Mai 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 04. Apr. 2008
    Geliefert am 08. Apr. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent and trustee for the finance parties) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Mill lane nursing home felixstowe suffolk t/no SK275266 the gables nursing home marine parade great yarmouth norfolk t/no NK338434 fornham house fornham st martin bury st edmunds suffolk t/no SK145383 for details of further properties charged please refer to form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC in Its Capacity as Security Trustee
    Transaktionen
    • 08. Apr. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Mai 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 04. Aug. 2005
    Geliefert am 11. Aug. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 01. Feb. 2002
    Geliefert am 12. Feb. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 12. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Feb. 2002
    Geliefert am 12. Feb. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage over all that freehold property known as west of shortmead street biggleswade and freehold property on the west side of shortmead street biggleswade. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 12. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 26. Sept. 2000
    Geliefert am 30. Sept. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The land and buildings on the west side of shortmead st biggleswade known as beaumont park shortmead st biggleswade t/no BD123120 BD127708. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 30. Sept. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge over chattels
    Erstellt am 26. Sept. 2000
    Geliefert am 30. Sept. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    With full title guarantee by way of first fixed charge: 1)the fixed assets together with any and all assets subsequently acquired by the company by way of replacement thereof 2)items of real or personal property tangible or intangible . fixed assets: 37 beds 37 wardrobes 37 chairs. For details of further properties charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 30. Sept. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Aug. 1996
    Geliefert am 31. Aug. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The property k/a land and premises at shotmead street, biggleswade bedford t/n's BD123120 and BD127708 assigns the goodwill of the business and the benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Aug. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Okt. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 21. Aug. 1996
    Geliefert am 31. Aug. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Aug. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Mai 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0