ELECTRONIQUE GROUP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameELECTRONIQUE GROUP LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03214376
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ELECTRONIQUE GROUP LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich ELECTRONIQUE GROUP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o C/O ROBNOR RESINS LIMITED
    31 Hunts Rise
    South Marston
    SN3 4TE Swindon
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ELECTRONIQUE GROUP LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    RAVENGOLD LIMITED19. Juni 199619. Juni 1996

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ELECTRONIQUE GROUP LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2014

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für ELECTRONIQUE GROUP LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für ELECTRONIQUE GROUP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Robnor Resins Limited Hunts Rise South Marston Swindon SN3 4TE zum C/O C/O Robnor Resins Limited 31 Hunts Rise South Marston Swindon SN3 4TE am 21. Okt. 2015

    1 SeitenAD01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2014

    7 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Crawford Wilson Gillan als Geschäftsführer am 16. Feb. 2015

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Crawford Wilson Gillan als Sekretär am 16. Feb. 2015

    1 SeitenTM02

    Jahresrückblick erstellt bis 17. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital19. Jan. 2015

    Kapitalaufstellung am 19. Jan. 2015

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2013

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 17. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital17. Jan. 2014

    Kapitalaufstellung am 17. Jan. 2014

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Frederick Hawley als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mr Crawford Wilson Gillan als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Crawford Wilson Gillan als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Ernennung von Mr John Rae Henderson als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Frederick Hawley als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Gilles Coulombeau als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    legacy

    SeitenANNOTATION

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Gilles Maire Jean Francois Coulombeau am 01. März 2013

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2012

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2011

    11 SeitenAA

    Kapitalaufstellung am 28. Juli 2011

    • Kapital: GBP 1
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    legacy

    3 SeitenMG02

    Wer sind die Geschäftsführer von ELECTRONIQUE GROUP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HENDERSON, John Rae
    c/o C/O Robnor Resins Limited
    Hunts Rise
    South Marston
    SN3 4TE Swindon
    31
    England
    Geschäftsführer
    c/o C/O Robnor Resins Limited
    Hunts Rise
    South Marston
    SN3 4TE Swindon
    31
    England
    ScotlandBritish43301650001
    GILLAN, Crawford Wilson
    Hunts Rise
    South Marston
    SN3 4TE Swindon
    C/O Robnor Resins Limited
    Sekretär
    Hunts Rise
    South Marston
    SN3 4TE Swindon
    C/O Robnor Resins Limited
    182622810001
    HAWLEY, Frederick William
    3 Booth Road
    WA14 4AX Altrincham
    Cheshire
    Sekretär
    3 Booth Road
    WA14 4AX Altrincham
    Cheshire
    British13540840002
    HARPER CORPORATION LIMITED
    60 Tabernacle Street
    EC2A 4NB London
    Bevollmächtigter Sekretär
    60 Tabernacle Street
    EC2A 4NB London
    900013980001
    COULOMBEAU, Gilles Maire Jean Francois
    Hawton
    NG24 3RN Newark
    Glebe House
    Nottinghamshire
    England
    Geschäftsführer
    Hawton
    NG24 3RN Newark
    Glebe House
    Nottinghamshire
    England
    United KingdomFrench15117870004
    GILLAN, Crawford Wilson
    Hunts Rise
    South Marston
    SN3 4TE Swindon
    C/O Robnor Resins Limited
    Geschäftsführer
    Hunts Rise
    South Marston
    SN3 4TE Swindon
    C/O Robnor Resins Limited
    United KingdomBritish182618510001
    HARDIE, Reginald George
    The Bend 451 Chester Road
    Woodford
    SK7 1QP Stockport
    Cheshire
    Geschäftsführer
    The Bend 451 Chester Road
    Woodford
    SK7 1QP Stockport
    Cheshire
    British422650001
    HAWLEY, Frederick William
    3 Booth Road
    WA14 4AX Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    3 Booth Road
    WA14 4AX Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish13540840002
    LING, Philip Henry
    The Old Farmhouse
    Cockpole Green
    RG10 8NT Wargrave
    Berkshire
    Geschäftsführer
    The Old Farmhouse
    Cockpole Green
    RG10 8NT Wargrave
    Berkshire
    United KingdomBritish2326420001
    WALTON, Michael Edward D'Arcy
    39 Frewin Road
    SW18 3LR London
    Geschäftsführer
    39 Frewin Road
    SW18 3LR London
    EnglandBritish34866270001
    L.C.I. DIRECTORS LIMITED
    60 Tabernacle Street
    EC2A 4NB London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    60 Tabernacle Street
    EC2A 4NB London
    900013970001

    Hat ELECTRONIQUE GROUP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 01. Okt. 1999
    Geliefert am 21. Okt. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    65,002 ordinary shares of £1 each in the issued share capital of electronique limited and all stocks securities and other property charged under the terms of the charge. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 21. Okt. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juli 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Apr. 1999
    Geliefert am 15. Apr. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a units 2A and 2B hulme hall lane manchester t/n GM413956. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Mai 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Apr. 1999
    Geliefert am 15. Apr. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a unit b harwood road littlehampton t/n WSX54330. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Mai 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Apr. 1999
    Geliefert am 15. Apr. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a unit a harwood road littlehampton t/n WSX50703. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Mai 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Apr. 1999
    Geliefert am 15. Apr. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a land on the west side of byrom street liverpool t/n MS125497. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Mai 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Apr. 1999
    Geliefert am 15. Apr. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a unit 2 harwood road littlehampton t/n WSX79974. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Mai 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Apr. 1999
    Geliefert am 15. Apr. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a 42-48 fentenoy street liverpool t/n MS124039. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Jan. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 13. Feb. 1999
    Geliefert am 23. Feb. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (For property details see form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Mai 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignation of keyman policy
    Erstellt am 10. März 1997
    Geliefert am 19. März 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The life assurance policy dated 16 february 1996 issuedby crowe life on tthe life of colin douglas murray for the amount of £100,000 contract no. 733/Rml 16762 certificate number sed 1289 and all sums assured thereby and bonuses and benefits arising thereunder.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. März 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Mai 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of keyman policy
    Erstellt am 04. Dez. 1996
    Geliefert am 13. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this assignment of keyman policy
    Kurze Angaben
    Crowe life assurance company policy no.sed 1221 dated 13.9.96 over the life of christopher james wilkins, sum assured:£100,000, together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 13. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Mai 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of keyman policy
    Erstellt am 04. Dez. 1996
    Geliefert am 13. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this assignment of keyman policy
    Kurze Angaben
    Crowe life assurance company policy no.sed 1217 dated 13.9.96 over the life of david smith, sum assured:£100,000, together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 13. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Mai 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of keyman policy
    Erstellt am 04. Dez. 1996
    Geliefert am 13. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this assignment of keyman policy
    Kurze Angaben
    Crowe life assurance company policy no.sed 1219 dated 13.9.96 over the life of giles marie coulombeau, sum assured:£500,000, together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 13. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Mai 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of keyman policy
    Erstellt am 04. Dez. 1996
    Geliefert am 13. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this assignment of keyman policy
    Kurze Angaben
    Crowe life assurance company policy no.sed 1218 dated 13.9.96 over the life of neil ancell, sum assured:£100,000, together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 13. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Mai 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of keyman policy
    Erstellt am 04. Dez. 1996
    Geliefert am 13. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this assignment of keyman policy
    Kurze Angaben
    Crowe life assurance company policy no.sed 1220 dated 13.9.96 over the life of fredrick william hawley, sum assured:£100,000, together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 13. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Mai 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage and charge
    Erstellt am 31. Juli 1996
    Geliefert am 02. Aug. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Lands and premises situate in the townland of killyhevlin parish of enniskillen barony of tirkennedy and county fermanagh .. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 02. Aug. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juni 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 14. Mai 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 31. Juli 1996
    Geliefert am 02. Aug. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the banks (as defined) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 02. Aug. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Mai 1999Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 14. Mai 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0