ELECTRONIQUE GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ELECTRONIQUE GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03214376 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ELECTRONIQUE GROUP LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich ELECTRONIQUE GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o C/O ROBNOR RESINS LIMITED 31 Hunts Rise South Marston SN3 4TE Swindon England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ELECTRONIQUE GROUP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| RAVENGOLD LIMITED | 19. Juni 1996 | 19. Juni 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ELECTRONIQUE GROUP LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für ELECTRONIQUE GROUP LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für ELECTRONIQUE GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Robnor Resins Limited Hunts Rise South Marston Swindon SN3 4TE zum C/O C/O Robnor Resins Limited 31 Hunts Rise South Marston Swindon SN3 4TE am 21. Okt. 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2014 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Crawford Wilson Gillan als Geschäftsführer am 16. Feb. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Crawford Wilson Gillan als Sekretär am 16. Feb. 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 17. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2013 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 17. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Frederick Hawley als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Crawford Wilson Gillan als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Crawford Wilson Gillan als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Ernennung von Mr John Rae Henderson als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Frederick Hawley als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gilles Coulombeau als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
legacy | Seiten | ANNOTATION | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Gilles Maire Jean Francois Coulombeau am 01. März 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2012 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2011 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 28. Juli 2011
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ELECTRONIQUE GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HENDERSON, John Rae | Geschäftsführer | c/o C/O Robnor Resins Limited Hunts Rise South Marston SN3 4TE Swindon 31 England | Scotland | British | 43301650001 | |||||
| GILLAN, Crawford Wilson | Sekretär | Hunts Rise South Marston SN3 4TE Swindon C/O Robnor Resins Limited | 182622810001 | |||||||
| HAWLEY, Frederick William | Sekretär | 3 Booth Road WA14 4AX Altrincham Cheshire | British | 13540840002 | ||||||
| HARPER CORPORATION LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 60 Tabernacle Street EC2A 4NB London | 900013980001 | |||||||
| COULOMBEAU, Gilles Maire Jean Francois | Geschäftsführer | Hawton NG24 3RN Newark Glebe House Nottinghamshire England | United Kingdom | French | 15117870004 | |||||
| GILLAN, Crawford Wilson | Geschäftsführer | Hunts Rise South Marston SN3 4TE Swindon C/O Robnor Resins Limited | United Kingdom | British | 182618510001 | |||||
| HARDIE, Reginald George | Geschäftsführer | The Bend 451 Chester Road Woodford SK7 1QP Stockport Cheshire | British | 422650001 | ||||||
| HAWLEY, Frederick William | Geschäftsführer | 3 Booth Road WA14 4AX Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | 13540840002 | |||||
| LING, Philip Henry | Geschäftsführer | The Old Farmhouse Cockpole Green RG10 8NT Wargrave Berkshire | United Kingdom | British | 2326420001 | |||||
| WALTON, Michael Edward D'Arcy | Geschäftsführer | 39 Frewin Road SW18 3LR London | England | British | 34866270001 | |||||
| L.C.I. DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 60 Tabernacle Street EC2A 4NB London | 900013970001 |
Hat ELECTRONIQUE GROUP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Erstellt am 01. Okt. 1999 Geliefert am 21. Okt. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 65,002 ordinary shares of £1 each in the issued share capital of electronique limited and all stocks securities and other property charged under the terms of the charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. Apr. 1999 Geliefert am 15. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The l/h property k/a units 2A and 2B hulme hall lane manchester t/n GM413956. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. Apr. 1999 Geliefert am 15. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The l/h property k/a unit b harwood road littlehampton t/n WSX54330. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. Apr. 1999 Geliefert am 15. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The l/h property k/a unit a harwood road littlehampton t/n WSX50703. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. Apr. 1999 Geliefert am 15. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The l/h property k/a land on the west side of byrom street liverpool t/n MS125497. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. Apr. 1999 Geliefert am 15. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a unit 2 harwood road littlehampton t/n WSX79974. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. Apr. 1999 Geliefert am 15. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a 42-48 fentenoy street liverpool t/n MS124039. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 13. Feb. 1999 Geliefert am 23. Feb. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (For property details see form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignation of keyman policy | Erstellt am 10. März 1997 Geliefert am 19. März 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The life assurance policy dated 16 february 1996 issuedby crowe life on tthe life of colin douglas murray for the amount of £100,000 contract no. 733/Rml 16762 certificate number sed 1289 and all sums assured thereby and bonuses and benefits arising thereunder. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of keyman policy | Erstellt am 04. Dez. 1996 Geliefert am 13. Dez. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this assignment of keyman policy | |
Kurze Angaben Crowe life assurance company policy no.sed 1221 dated 13.9.96 over the life of christopher james wilkins, sum assured:£100,000, together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of keyman policy | Erstellt am 04. Dez. 1996 Geliefert am 13. Dez. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this assignment of keyman policy | |
Kurze Angaben Crowe life assurance company policy no.sed 1217 dated 13.9.96 over the life of david smith, sum assured:£100,000, together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of keyman policy | Erstellt am 04. Dez. 1996 Geliefert am 13. Dez. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this assignment of keyman policy | |
Kurze Angaben Crowe life assurance company policy no.sed 1219 dated 13.9.96 over the life of giles marie coulombeau, sum assured:£500,000, together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of keyman policy | Erstellt am 04. Dez. 1996 Geliefert am 13. Dez. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this assignment of keyman policy | |
Kurze Angaben Crowe life assurance company policy no.sed 1218 dated 13.9.96 over the life of neil ancell, sum assured:£100,000, together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of keyman policy | Erstellt am 04. Dez. 1996 Geliefert am 13. Dez. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this assignment of keyman policy | |
Kurze Angaben Crowe life assurance company policy no.sed 1220 dated 13.9.96 over the life of fredrick william hawley, sum assured:£100,000, together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage and charge | Erstellt am 31. Juli 1996 Geliefert am 02. Aug. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Lands and premises situate in the townland of killyhevlin parish of enniskillen barony of tirkennedy and county fermanagh .. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. Juli 1996 Geliefert am 02. Aug. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and the banks (as defined) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0