BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03214421 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o BRUNTWOOD LIMITED York House York Street M2 3BB Manchester England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BRUNTWOOD SECOND PROPERTIES LIMITED | 12. Aug. 1996 | 12. Aug. 1996 |
| BRUNTWOOD SECOND ESTATES LIMITED | 19. Juli 1996 | 19. Juli 1996 |
| SLATERSHELFCO 318 LIMITED | 20. Juni 1996 | 20. Juni 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Bruntwood Limited City Tower Piccadilly Plaza Manchester M1 4BT zum C/O Bruntwood Limited York House York Street Manchester M2 3BB am 07. Juni 2016 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2014 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2013 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Kevin James Crotty am 28. Juni 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2012 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Kevin James Crotty als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2011 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Allan als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * City Tower Piccadilly Plaza Manchester M1 4BT United Kingdom* am 05. Jan. 2012 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2010 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robert Yates als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Marland als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Malin als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Iain Grant als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Crowther als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2009 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOKES, Katharine Jane | Sekretär | c/o Bruntwood Limited York Street M2 3BB Manchester York House England | British | 96739300002 | ||||||
| CROTTY, Kevin James | Geschäftsführer | c/o Bruntwood Limited York Street M2 3BB Manchester York House England | England | British | 117797270004 | |||||
| OGLESBY, Christopher George | Geschäftsführer | c/o Bruntwood Limited York Street M2 3BB Manchester York House England | United Kingdom | British | 53530470002 | |||||
| OGLESBY, Michael John | Geschäftsführer | c/o Bruntwood Limited York Street M2 3BB Manchester York House England | United Kingdom | British | 148307320001 | |||||
| GREENWOOD, Clive Norman Kristian | Sekretär | Meadows Farm SK12 7EH Kettleshulme Cheshire | British | 2582690002 | ||||||
| ORRELL, Jeremy Peter | Bevollmächtigter Sekretär | 2 Greylands Close M33 6GS Sale Cheshire | British | 900005190001 | ||||||
| ALLAN, Andrew John | Geschäftsführer | c/o Bruntwood Limited Piccadilly Plaza M1 4BT Manchester City Tower United Kingdom | United Kingdom | British | 80043450001 | |||||
| CROWTHER, Peter Andrew | Geschäftsführer | Piccadilly Plaza M1 4BT Manchester City Tower United Kingdom | United Kingdom | British | 102710080002 | |||||
| GRANT, Iain James | Geschäftsführer | Piccadilly Plaza M1 4BT Manchester City Tower United Kingdom | United Kingdom | British | 45918940003 | |||||
| GREENWOOD, Clive Norman Kristian | Geschäftsführer | Meadows Farm SK12 7EH Kettleshulme Cheshire | United Kingdom | British | 2582690002 | |||||
| GUEST, David Robert James | Geschäftsführer | 21 Beech Road Chorlton M21 8BX Manchester Lancashire | United Kingdom | British | 102710440001 | |||||
| HEWITT, Michael | Geschäftsführer | 11 Marryat Close Winwick Park WA2 8XS Warrington Cheshire | England | British | 108552010001 | |||||
| MALIN, Richard William | Geschäftsführer | Piccadilly Plaza M1 4BT Manchester City Tower United Kingdom | United Kingdom | British | 48153170001 | |||||
| MARLAND, John Roderick | Geschäftsführer | Piccadilly Plaza M1 4BT Manchester City Tower United Kingdom | United Kingdom | British | 102712120001 | |||||
| MORRIS, Antony Howard | Geschäftsführer | 17 St Margarets Close Prestwich M25 2LY Manchester | British | 48178610001 | ||||||
| OGLESBY, Jean Davies | Geschäftsführer | Moss Farm Southdowns Road Bowdon WA14 3DR Altrincham Cheshire | England | British | 29553390001 | |||||
| ORRELL, Jeremy Peter | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 2 Greylands Close M33 6GS Sale Cheshire | British | 900005190001 | ||||||
| ROBERTS, Christopher Andrew | Geschäftsführer | Swann Lane Cheadle Hulme SK8 7HU Cheadle 70a Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 139641910001 | |||||
| YATES, Robert David | Geschäftsführer | Piccadilly Plaza M1 4BT Manchester City Tower United Kingdom | England | British | 30535590006 |
Hat BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| B2000 borrower security agreement | Erstellt am 06. Feb. 2007 Geliefert am 20. Feb. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other borrower secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 23. Juni 2004 Geliefert am 01. Juli 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the banks on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a overseas house, quay street t/no LA355462 together with all buildings, fixtures and fittings and fixed plant and machinery thereon, all plant, machinery, implements, utensils, building materials, carpets, furniture andequipment now or in the future placed on or used in or about the mortgaged prope. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 18. Dez. 2003 Geliefert am 03. Jan. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the banks and each of them on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of first legal mortgage the freehold property known as overseas house quay street t/n LA355462 by way of fixed charge all plant machinery implements building materials all of the companys rights and benefits under any agreements and the benefit of each and all of the personal covenants by the lesses underlesses or licensees under the occupational leases. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 14. Nov. 2000 Geliefert am 24. Nov. 2000 | Vollständig erf üllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land adjoining marsland house,marsland rd,sale,gt.manchester. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 23. Juni 1999 Geliefert am 30. Juni 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage f/h land and buildings k/a lancastrian office buildings talbot road stretford greater manchester t/n-LA234523.. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. Aug. 1998 Geliefert am 27. Aug. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H land and and buildings k/a bank house faulkner street manchester t/no.LA360892. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. Aug. 1998 Geliefert am 27. Aug. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the l/h land and buildings k/a bank chambers adjoining bank house faulkner street manchester being the whole of the land under t/nos.GM789357 and GM789673. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 05. Juni 1998 Geliefert am 15. Juni 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land and buildings k/a marsland house marsland road sale t/nos.GM53071 and GM323015 and goodwill of any business. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 31. Dez. 1996 Geliefert am 03. Jan. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a quay house 28 quay street manchester t/n GM66438 the goodwill of the business and the proceeds of any insurance. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 13. Nov. 1996 Geliefert am 19. Nov. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0