BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED

BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03214421
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o BRUNTWOOD LIMITED
    York House
    York Street
    M2 3BB Manchester
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BRUNTWOOD SECOND PROPERTIES LIMITED12. Aug. 199612. Aug. 1996
    BRUNTWOOD SECOND ESTATES LIMITED19. Juli 199619. Juli 1996
    SLATERSHELFCO 318 LIMITED20. Juni 199620. Juni 1996

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2014

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Bruntwood Limited City Tower Piccadilly Plaza Manchester M1 4BT zum C/O Bruntwood Limited York House York Street Manchester M2 3BB am 07. Juni 2016

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital12. Apr. 2016

    Kapitalaufstellung am 12. Apr. 2016

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2014

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital09. Apr. 2015

    Kapitalaufstellung am 09. Apr. 2015

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2013

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital08. Apr. 2014

    Kapitalaufstellung am 08. Apr. 2014

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Kevin James Crotty am 28. Juni 2013

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2012

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Ernennung von Mr Kevin James Crotty als Direktor

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2011

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Andrew Allan als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * City Tower Piccadilly Plaza Manchester M1 4BT United Kingdom* am 05. Jan. 2012

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2010

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Robert Yates als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von John Marland als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Richard Malin als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Iain Grant als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Peter Crowther als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2009

    5 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    VOKES, Katharine Jane
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    Sekretär
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    British96739300002
    CROTTY, Kevin James
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    Geschäftsführer
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    EnglandBritish117797270004
    OGLESBY, Christopher George
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    Geschäftsführer
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    United KingdomBritish53530470002
    OGLESBY, Michael John
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    Geschäftsführer
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    United KingdomBritish148307320001
    GREENWOOD, Clive Norman Kristian
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    Sekretär
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    British2582690002
    ORRELL, Jeremy Peter
    2 Greylands Close
    M33 6GS Sale
    Cheshire
    Bevollmächtigter Sekretär
    2 Greylands Close
    M33 6GS Sale
    Cheshire
    British900005190001
    ALLAN, Andrew John
    c/o Bruntwood Limited
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    c/o Bruntwood Limited
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritish80043450001
    CROWTHER, Peter Andrew
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritish102710080002
    GRANT, Iain James
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritish45918940003
    GREENWOOD, Clive Norman Kristian
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    United KingdomBritish2582690002
    GUEST, David Robert James
    21 Beech Road
    Chorlton
    M21 8BX Manchester
    Lancashire
    Geschäftsführer
    21 Beech Road
    Chorlton
    M21 8BX Manchester
    Lancashire
    United KingdomBritish102710440001
    HEWITT, Michael
    11 Marryat Close
    Winwick Park
    WA2 8XS Warrington
    Cheshire
    Geschäftsführer
    11 Marryat Close
    Winwick Park
    WA2 8XS Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish108552010001
    MALIN, Richard William
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritish48153170001
    MARLAND, John Roderick
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritish102712120001
    MORRIS, Antony Howard
    17 St Margarets Close
    Prestwich
    M25 2LY Manchester
    Geschäftsführer
    17 St Margarets Close
    Prestwich
    M25 2LY Manchester
    British48178610001
    OGLESBY, Jean Davies
    Moss Farm Southdowns Road
    Bowdon
    WA14 3DR Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Moss Farm Southdowns Road
    Bowdon
    WA14 3DR Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish29553390001
    ORRELL, Jeremy Peter
    2 Greylands Close
    M33 6GS Sale
    Cheshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    2 Greylands Close
    M33 6GS Sale
    Cheshire
    British900005190001
    ROBERTS, Christopher Andrew
    Swann Lane
    Cheadle Hulme
    SK8 7HU Cheadle
    70a
    Cheshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Swann Lane
    Cheadle Hulme
    SK8 7HU Cheadle
    70a
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish139641910001
    YATES, Robert David
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    EnglandBritish30535590006

    Hat BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    B2000 borrower security agreement
    Erstellt am 06. Feb. 2007
    Geliefert am 20. Feb. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other borrower secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Borrower Security Trustee) (Whether from Its Own Account Oras Trustee for the Borrower Secured Creditors)
    Transaktionen
    • 20. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Juni 2004
    Geliefert am 01. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the banks on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a overseas house, quay street t/no LA355462 together with all buildings, fixtures and fittings and fixed plant and machinery thereon, all plant, machinery, implements, utensils, building materials, carpets, furniture andequipment now or in the future placed on or used in or about the mortgaged prope. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC (As Agent and Trustee for the Banks)
    Transaktionen
    • 01. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Dez. 2003
    Geliefert am 03. Jan. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the banks and each of them on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage the freehold property known as overseas house quay street t/n LA355462 by way of fixed charge all plant machinery implements building materials all of the companys rights and benefits under any agreements and the benefit of each and all of the personal covenants by the lesses underlesses or licensees under the occupational leases. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Nov. 2000
    Geliefert am 24. Nov. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land adjoining marsland house,marsland rd,sale,gt.manchester.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 24. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Dez. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Juni 1999
    Geliefert am 30. Juni 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage f/h land and buildings k/a lancastrian office buildings talbot road stretford greater manchester t/n-LA234523.. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 30. Juni 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Dez. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 24. Aug. 1998
    Geliefert am 27. Aug. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H land and and buildings k/a bank house faulkner street manchester t/no.LA360892. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 27. Aug. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Dez. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 24. Aug. 1998
    Geliefert am 27. Aug. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the l/h land and buildings k/a bank chambers adjoining bank house faulkner street manchester being the whole of the land under t/nos.GM789357 and GM789673. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 27. Aug. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Dez. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Juni 1998
    Geliefert am 15. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings k/a marsland house marsland road sale t/nos.GM53071 and GM323015 and goodwill of any business. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 15. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Dez. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Dez. 1996
    Geliefert am 03. Jan. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a quay house 28 quay street manchester t/n GM66438 the goodwill of the business and the proceeds of any insurance. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 03. Jan. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 13. Nov. 1996
    Geliefert am 19. Nov. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 19. Nov. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Dez. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0