OVERSON LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameOVERSON LIMITED
    UnternehmensstatusIn Verwaltung
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03214899
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von OVERSON LIMITED?

    • (9305) /

    Wo befindet sich OVERSON LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Recovery Hjs
    12 -14 Carlton Place
    SO15 2EA Southampton
    Hampshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von OVERSON LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am30. Juni 2007
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am30. Apr. 2008
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2006

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für OVERSON LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis21. Juni 2017
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung05. Juli 2017
    ÜberfälligJa

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für OVERSON LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss
    ÜberfälligJa

    Welche sind die letzten Einreichungen für OVERSON LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Beendigung der Bestellung von Charles Henry Pfister als Sekretär am 07. Mai 2015

    2 SeitenTM02

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    5 Seiten2.24B

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    6 Seiten2.23B

    Vorschlag des Verwalters

    10 Seiten2.17B

    legacy

    1 Seiten287

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2006

    7 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2005

    7 SeitenAA

    legacy

    7 Seiten363s

    legacy

    1 Seiten403a

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2004

    7 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    7 Seiten363s
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    annual-return29. Juni 2004

    legacy

    363(287)
    annual-return29. Juni 2004

    legacy

    363(288)

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2003

    7 SeitenAA

    legacy

    7 Seiten363s

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2002

    7 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    3 Seiten395

    Wer sind die Geschäftsführer von OVERSON LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HAGER, Robert John
    Oaklands Clarks Green
    Rusper Road Capel
    RH5 5HE Dorking
    Surrey
    Geschäftsführer
    Oaklands Clarks Green
    Rusper Road Capel
    RH5 5HE Dorking
    Surrey
    British48574770001
    HAGER, Robert John
    Oaklands Clarks Green
    Rusper Road Capel
    RH5 5HE Dorking
    Surrey
    Sekretär
    Oaklands Clarks Green
    Rusper Road Capel
    RH5 5HE Dorking
    Surrey
    British48574770001
    HARRISON, Irene Lesley
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    South Glamorgan
    Bevollmächtigter Sekretär
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    South Glamorgan
    British900003790001
    PFISTER, Charles Henry
    Braemar
    3 Jenner Road
    GU1 3AQ Guildford
    Surrey
    Sekretär
    Braemar
    3 Jenner Road
    GU1 3AQ Guildford
    Surrey
    British67081640001
    BURGON, Mark Edward
    4 Chartwell Mews
    Carron Lane
    GU29 9ST Midhurst
    West Sussex
    Geschäftsführer
    4 Chartwell Mews
    Carron Lane
    GU29 9ST Midhurst
    West Sussex
    EnglandBritish100433200001
    BUSINESS INFORMATION RESEARCH & REPORTING LIMITED
    Crown House
    64 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Crown House
    64 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    900005500001

    Hat OVERSON LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 19. Aug. 2002
    Geliefert am 30. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold land forming part of the garden of the property known as outerfield,tilford road,hindhead; part t/no sy 108357. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Aug. 2002
    Geliefert am 24. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £60,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All that freehold land formerly part of the property outerfield tilford road hindhead surrey GU26 6SF.
    Berechtigte Personen
    • Mirafora Themistocli
    Transaktionen
    • 24. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Aug. 2002
    Geliefert am 24. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £75,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All that freehold land formerly part of the garden of outerfield tilford road hindhead surrey GU26 6SF.
    Berechtigte Personen
    • Carolyn Mary Popham
    Transaktionen
    • 24. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Aug. 2002
    Geliefert am 24. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £25,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All that freehold land formerly part of the garden of outerfield tilford road hindhead surrey GU26 6SF.
    Berechtigte Personen
    • Montagu Graeme Macdonald
    Transaktionen
    • 24. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Jan. 2002
    Geliefert am 05. Feb. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Property k/a land adjoining courts mount road haslemere surrey.
    Berechtigte Personen
    • C.H. Pfister & R.J. Hager as Trustees of D M Hager Discretionary Settlement
    Transaktionen
    • 05. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Jan. 2002
    Geliefert am 05. Feb. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a land adjoining courts mount barn courts mount road haslemere surrey. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 19. Dez. 2001
    Geliefert am 20. Dez. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Dez. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Juli 2000
    Geliefert am 15. Aug. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement and this charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a the old bus depot 65 north street midhurst west sussex.
    Berechtigte Personen
    • R J Hager(As Trustees of the Mrs D M Hager 1997 Settlement)
    • C H Pfister
    Transaktionen
    • 15. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Nov. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Juli 2000
    Geliefert am 11. Aug. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement and this charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a the old bus depot 65 north street midhurst west sussex.
    Berechtigte Personen
    • Robert Michael Macdonald
    • Montagu Graeme Macdonald
    • Carolyn Mary Popham
    Transaktionen
    • 11. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Okt. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Juli 2000
    Geliefert am 11. Aug. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement and this charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a the old bus depot 65 north street midhurst west sussex.
    Berechtigte Personen
    • Donald Slough
    Transaktionen
    • 11. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Okt. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 28. Juli 2000
    Geliefert am 01. Aug. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H part of the old bus depot midhurst west sussex. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Okt. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge of whole
    Erstellt am 19. Nov. 1999
    Geliefert am 19. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £25,000 due from the company to the chargee in accordance with the terms of the supplemental agreement of even date
    Kurze Angaben
    F/Hold land lying to the north east of petworth rd,haslemere and garages; t/no sy 677075.
    Berechtigte Personen
    • Carolyn Mary Popham
    Transaktionen
    • 19. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Dez. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge of whole
    Erstellt am 03. Juni 1998
    Geliefert am 09. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £50,000 due or to become due from the company to the chargees
    Kurze Angaben
    Land to the north of petworth road haslemere and garages surrey.
    Berechtigte Personen
    • Carolyn Mary Popham and Robert Michael Macdonald
    Transaktionen
    • 09. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Dez. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage deed
    Erstellt am 03. Juni 1998
    Geliefert am 05. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land to the rear of 24 petworth road haslemere surrey t/n SY677075. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Juni 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge of whole
    Erstellt am 19. Nov. 1997
    Geliefert am 21. Nov. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £50,000.00 due or to become due from the company to the chargees
    Kurze Angaben
    Land and buildings adjacent to greencroft scotland drive haslemere surreyt/no.SY248372.
    Berechtigte Personen
    • Carolyn Mary Popham
    • Robert Michael Macdonald
    Transaktionen
    • 21. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed floating charge
    Erstellt am 13. Okt. 1997
    Geliefert am 14. Okt. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 18TH august 1997
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a the wheatsheaf grayswood roaf witley haslemere surrey t/n SY382663 and by way of floating charge the undertaking of the company and all it's property assets and rights present and future.
    Berechtigte Personen
    • Plt Limited
    Transaktionen
    • 14. Okt. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. März 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 21. Mai 1997
    Geliefert am 22. Mai 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land adjacent to greencroft scotland drive haslemere surrey t/n-SY248372 by way of legal mortgage the property of the mortagagor as specified above together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery from time to time thereon, by way of fixed charge all present and future book and other debts, by way of floating charge all present and future stock, goods, moveable plant, machinery, implements, utensils, furniture and equipment, by way of assignment the goodwill of the business (if any) and the full benefit of all present and future licences (if any).. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 31. Juli 1996
    Geliefert am 07. Aug. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 8TH july 1996 and this charge
    Kurze Angaben
    First fixed legal mortgage f/h property k/a the cottages verdley place furnhurst chichester west sussex first fixed charge all the company's right title and interest in any account from time to time opened and maintained by the company in accordance with the provisions of this charge and all monies (including interest thereon) standing from time to time to the credit of such account. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Plt Limited
    Transaktionen
    • 07. Aug. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Mai 1997Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 05. Sept. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge of whole
    Erstellt am 31. Juli 1996
    Geliefert am 01. Aug. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £140,000 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    C1-C8 and GC1-GC5 verdley place fernhurst t/no wsx 195964.
    Berechtigte Personen
    • Mrs Dulcie Marguerite Hager
    Transaktionen
    • 01. Aug. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Mai 1997Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 05. Sept. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat OVERSON LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    02. Feb. 2007Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Shane Biddlecombe
    Hjs Recovery 12-14 Carlton Place
    SO15 2EA Southampton
    Hampshire
    Praktiker
    Hjs Recovery 12-14 Carlton Place
    SO15 2EA Southampton
    Hampshire
    Gordon John Johnston
    Hjs Recovery 12-14 Carlton Place
    SO15 2EA Southampton
    Hampshire
    Praktiker
    Hjs Recovery 12-14 Carlton Place
    SO15 2EA Southampton
    Hampshire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0