FOUNTAINS WALK TRUSTEE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | FOUNTAINS WALK TRUSTEE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03216675 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von FOUNTAINS WALK TRUSTEE LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich FOUNTAINS WALK TRUSTEE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Duff & Phelps Ltd The Shard 32 London Bridge Street SE1 9SG London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von FOUNTAINS WALK TRUSTEE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| PINCO 799 LIMITED | 25. Juni 1996 | 25. Juni 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FOUNTAINS WALK TRUSTEE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für FOUNTAINS WALK TRUSTEE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 20 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 1st Floor Unit 16 Manor Court Business Park Scarborough YO11 3TU zum Duff & Phelps Ltd the Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG am 10. Mai 2018 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 1 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Juni 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Notification of Fountains Walk Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2016 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Valsec Director Limited am 24. Feb. 2017 | 1 Seiten | CH02 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Valad Secretarial Services Limited am 24. Feb. 2017 | 1 Seiten | CH04 | ||||||||||
Ernennung von Mr James Edward Maddy als Direktor am 24. Feb. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Neil Kenneth Robertson als Geschäftsführer am 24. Feb. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2015 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Neil Kenneth Robertson als Direktor am 05. Jan. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Claire Treacy als Geschäftsführer am 05. Jan. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Claire Treacy als Direktor am 31. Juli 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Martyn James Mccarthy als Geschäftsführer am 31. Juli 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2014 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Martyn James Mccarthy am 30. Jan. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von FOUNTAINS WALK TRUSTEE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROMWELL CORPORATE SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | 3 Semple Street EH3 8BL Edinburgh 1st Floor Exchange Place 3 United Kingdom |
| 133355520004 | ||||||||||
| MADDY, James Edward | Geschäftsführer | Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 137459000002 | |||||||||
| CROMWELL DIRECTOR LIMITED | Geschäftsführer | Floor Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st United Kingdom |
| 102622300003 | ||||||||||
| ASH, Christine Ann | Sekretär | 18 Holbeck Avenue YO11 2XQ Scarborough North Yorkshire | British | 67480001 | ||||||||||
| BROOK, Susan Margaret | Sekretär | 16 Bradley Lane Rufforth YO23 3QJ York North Yorkshire | British | 72328070001 | ||||||||||
| COOPER, Hilary Joan | Sekretär | 73 Stepney Road YO12 5BT Scarborough North Yorkshire | British | 51307940002 | ||||||||||
| DI CIACCA, Cesidio Martin | Sekretär | 45 Blairston Avenue G71 8SA Bothwell Lanarkshire | British | 1267050001 | ||||||||||
| FRASER, Leslie Murray Fraser | Sekretär | 20 Franklin Street YO12 7JU Scarborough North Yorkshire | British | 53477320001 | ||||||||||
| MCBRIDE, Stephen Paul | Sekretär | Gryffe Main Street Upper Poppleton YO26 6EL York North Yorkshire | British | 56953000002 | ||||||||||
| MCCABE, Sandra | Sekretär | 13 Deepdale Avenue YO11 2UQ Scarborough The White House North Yorkshire | British | 920260005 | ||||||||||
| RICHARDSON, Paul | Sekretär | 2 Newdale Usher Park Haxby YO32 3LN York North Yorkshire | British | 60649820001 | ||||||||||
| PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | 1 Park Row LS1 5AB Leeds West Yorkshire | 76579530001 | |||||||||||
| BURNLEY, John Lewis | Geschäftsführer | Lantern Cottage Weeton Lane, Weeton LS17 0AN Leeds | England | British | 35543830001 | |||||||||
| DI CIACCA, Cesidio Martin | Geschäftsführer | 45 Blairston Avenue G71 8SA Bothwell Lanarkshire | Scotland | British | 1267050001 | |||||||||
| MCBRIDE, Stephen Paul | Geschäftsführer | Gryffe Main Street Upper Poppleton YO26 6EL York North Yorkshire | United Kingdom | British | 56953000002 | |||||||||
| MCCABE, Kevin Charles | Geschäftsführer | The White House 13 Deepdale Avenue YO11 2UQ Scarborough North Yorkshire | British | 109250000001 | ||||||||||
| MCCARTHY, Martyn James | Geschäftsführer | Floor Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st United Kingdom | United Kingdom | Australian | 126149680033 | |||||||||
| ROBERTSON, Neil Kenneth | Geschäftsführer | Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 158937210001 | |||||||||
| SHEPHERD, Marcus Owen | Geschäftsführer | 64 Clarence Road TW11 0BW Teddington Middx | United Kingdom | British | 41925000003 | |||||||||
| TANDY, Didier Michel | Geschäftsführer | Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House 20 North Yorkshire | England | British | 69909950001 | |||||||||
| TREACY, Claire | Geschäftsführer | Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | Irish | 189529610001 | |||||||||
| EUROPA DIRECTOR LIMITED | Geschäftsführer | Europa House 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough North Yorkshire | 102560510001 | |||||||||||
| PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Geschäftsführer | 1 Park Row LS1 5AB Leeds West Yorkshire | 76579530001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei FOUNTAINS WALK TRUSTEE LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fountains Walk Limited | 06. Apr. 2016 | 3 Semple Street EH3 8BL Edinburgh 1st Floor, Exchange Place 3 Scotland | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat FOUNTAINS WALK TRUSTEE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 22. März 2012 Geliefert am 30. März 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 50-53 taff street 56 and 58 taff street land on the east side of temperence place 1 1A 2 and 3A gas road pontypridd t/no WA123958 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession and charge | Erstellt am 11. März 2011 Geliefert am 25. März 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All of its rights title and interest from time to time in respect of any sums payable to it pursuant to any insurance policies,any hedging agreement,all land in england and wales see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. Aug. 1996 Geliefert am 06. Aug. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or the fountains walk limited partnership (the general partner) and barclays bank PLC as trustee for hanover property unit trust as limited partner, acting through the general partner | |
Kurze Angaben F/H property k/a 50/53 taff street, pontypridd t/no. WA123958, 56/58 taff street, pontypridd t/no. WA390110, land on the east side of temperance place, pontypridd t/no. WA372947, 1/1A gas road, pontypridd t/no. WA436390, 3A gas road, pontypridd t/no. WA147070 and 2 gas road, pontypridd t/no. WA307661. Fixed charges on all buildings and other structures on the property, any goodwill, all plant mahcinery and other items and the proceeds of any claim made under any insurance policy relating to property. Floating charge all unattached plant machinery chattels and goods. Assignment of rental sums.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat FOUNTAINS WALK TRUSTEE LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0