PHIP CH LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PHIP CH LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03217536 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PHIP CH LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich PHIP CH LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 5th Floor Greener House 66-68 Haymarket SW1Y 4RF London England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PHIP CH LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CATHEDRAL HEALTHCARE LIMITED | 11. Mai 2004 | 11. Mai 2004 |
| MOUNT ANVIL HEALTHCARE LIMITED | 12. Mai 1999 | 12. Mai 1999 |
| PRIMARY PARTNERSHIPS LIMITED | 01. Mai 1998 | 01. Mai 1998 |
| ANVIL LONDON LIMITED | 27. Juni 1996 | 27. Juni 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PHIP CH LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PHIP CH LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Juli 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Christopher Austin als Direktor am 01. Apr. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy David Walker Arnott als Geschäftsführer am 01. Apr. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Richard Howell als Direktor am 01. Apr. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Philip John Holland als Geschäftsführer am 01. Apr. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Juli 2016 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Philip John Holland am 08. Juli 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Juli 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Juli 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Timothy David Walker Arnott am 01. Mai 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Timothy David Walker Arnott am 22. Juli 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Nexus Management Services Limited als Sekretär | 3 Seiten | AP04 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Ryder Court, Ground Floor 14 Ryder Street London SW1Y 6QB* am 07. Mai 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Margaret Vaughan als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von J O Hambro Capital Management Limited als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PHIP CH LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEXUS MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Sekretär | Greener House 66-68 Haymarket SW1Y 4RF London 5th Floor England |
| 57253330002 | ||||||||||
| AUSTIN, David Christopher | Geschäftsführer | Greener House 66-68 Haymarket SW1Y 4RF London 5th Floor England | United Kingdom | British | 131339590001 | |||||||||
| HOWELL, Richard | Geschäftsführer | Greener House 66-68 Haymarket SW1Y 4RF London 5th Floor England | England | British | 164790590001 | |||||||||
| HYMAN, Harry Abraham | Geschäftsführer | Greener House 66-68 Haymarket SW1Y 4RF London 5th Floor England England | England | British | 35560380005 | |||||||||
| DEAMER, Kenneth | Sekretär | Lucky Stones Rowhill Road DA2 7QQ Wilmington Kent | British | 8521670002 | ||||||||||
| HURLEY, Cornelius Killian | Sekretär | 28 Millenium Wharf WD3 1AZ Rickmansworth Hertfordshire | Irish | 47179960002 | ||||||||||
| SCOTT, Christopher Richard | Sekretär | Crow Plain Oast House Crow Plain Collier Street TN12 9PU Tonbridge Kent | British | 81998190003 | ||||||||||
| STEVENS, Philip Martin | Sekretär | Forge House Maiden Street Weston SG4 7AA Hitchin Hertfordshire | British | 102528350001 | ||||||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 | |||||||||||
| J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | Sekretär | 14 Ryder Street SW1Y 6QB London Ground Floor, Ryder Court England |
| 117915530003 | ||||||||||
| BENNETT, Barry John | Geschäftsführer | Meadowdown Doggetts Wood Close HP8 4TL Chalfont St. Giles Buckinghamshire | United Kingdom | Irish | 14707370002 | |||||||||
| BORER, Derek | Geschäftsführer | 133 Ridge Lane WD17 4SX Watford Hertfordshire | British | 60451400001 | ||||||||||
| HAMBRO, James Daryl | Geschäftsführer | Ryder Court, Ground Floor 14 Ryder Street SW1Y 6QB London | United Kingdom | British | 53684400001 | |||||||||
| HOLLAND, Philip John | Geschäftsführer | Greener House 66-68 Haymarket SW1Y 4RF London 5th Floor England England | England | British | 163838050001 | |||||||||
| HURLEY, Cornelius Killian | Geschäftsführer | 28 Millenium Wharf WD3 1AZ Rickmansworth Hertfordshire | United Kingdom | Irish | 47179960002 | |||||||||
| ISAACS, Paul Samuel | Geschäftsführer | Rosemead Woodhill Road CM3 4DY Danbury Essex | England | British | 141827450001 | |||||||||
| NEWMAN, Victor Edward | Geschäftsführer | 70 Oakfield Road Southgate N14 6LX London | British | 23635170001 | ||||||||||
| SCOTT, Christopher Richard | Geschäftsführer | Crow Plain Oast House Crow Plain Collier Street TN12 9PU Tonbridge Kent | England | British | 81998190003 | |||||||||
| UPTON, Richard | Geschäftsführer | Old Bearhurst Battenhurst Road TN5 7DU Stonegate East Sussex | England | British | 204950320001 | |||||||||
| VAUGHAN, Margaret Helen | Geschäftsführer | Ryder Court, Ground Floor 14 Ryder Street SW1Y 6QB London | United Kingdom | British | 123167120001 | |||||||||
| WALKER ARNOTT, Timothy David | Geschäftsführer | Greener House 66-68 Haymarket SW1Y 4RF London 5th Floor England England | United Kingdom | British | 61889360004 | |||||||||
| COMBINED NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NA London | 900000090001 | |||||||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PHIP CH LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primary Health Properties Plc | 01. Juni 2016 | 66-68 Haymarket SW1Y 4RF London 5th Floor Greener House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat PHIP CH LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 02. Apr. 2012 Geliefert am 04. Apr. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. März 2008 Geliefert am 28. März 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben (For details of properties charged please refer to form 395) fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating security agreement | Erstellt am 01. Juni 2007 Geliefert am 14. Juni 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 01. Juni 2007 Geliefert am 14. Juni 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben For details of property charged please refer to form 395.. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 13. Juni 2006 Geliefert am 15. Juni 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that f/h property k/a 250-262 high street sheerness kent. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 09. Jan. 2006 Geliefert am 17. Jan. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 09. Jan. 2006 Geliefert am 11. Jan. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land forming part of the old A23 road west of high street handcross. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 26. Nov. 2004 Geliefert am 02. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0