PHIP CH LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePHIP CH LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03217536
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PHIP CH LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich PHIP CH LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    5th Floor Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von PHIP CH LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CATHEDRAL HEALTHCARE LIMITED11. Mai 200411. Mai 2004
    MOUNT ANVIL HEALTHCARE LIMITED12. Mai 199912. Mai 1999
    PRIMARY PARTNERSHIPS LIMITED01. Mai 199801. Mai 1998
    ANVIL LONDON LIMITED27. Juni 199627. Juni 1996

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PHIP CH LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für PHIP CH LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    1 SeitenDS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    5 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 10. Juli 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    4 SeitenMR04

    Ernennung von Mr David Christopher Austin als Direktor am 01. Apr. 2017

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Timothy David Walker Arnott als Geschäftsführer am 01. Apr. 2017

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Richard Howell als Direktor am 01. Apr. 2017

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Philip John Holland als Geschäftsführer am 01. Apr. 2017

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    5 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 10. Juli 2016 mit Aktualisierungen

    6 SeitenCS01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Philip John Holland am 08. Juli 2016

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 10. Juli 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital10. Juli 2015

    Kapitalaufstellung am 10. Juli 2015

    • Kapital: GBP 1,333
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    13 SeitenAA

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 02. Juli 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital30. Juli 2014

    Kapitalaufstellung am 30. Juli 2014

    • Kapital: GBP 1,333
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Timothy David Walker Arnott am 01. Mai 2014

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Timothy David Walker Arnott am 22. Juli 2014

    2 SeitenCH01

    Ernennung von Nexus Management Services Limited als Sekretär

    3 SeitenAP04

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Ryder Court, Ground Floor 14 Ryder Street London SW1Y 6QB* am 07. Mai 2014

    1 SeitenAD01

    Beendigung der Bestellung von Margaret Vaughan als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von J O Hambro Capital Management Limited als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Jahresrückblick erstellt bis 25. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital22. Juli 2013

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 22. Juli 2013

    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    5 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von PHIP CH LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    NEXUS MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    Sekretär
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer4187765
    57253330002
    AUSTIN, David Christopher
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    Geschäftsführer
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    United KingdomBritish131339590001
    HOWELL, Richard
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    Geschäftsführer
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    EnglandBritish164790590001
    HYMAN, Harry Abraham
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    England
    Geschäftsführer
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    England
    EnglandBritish35560380005
    DEAMER, Kenneth
    Lucky Stones Rowhill Road
    DA2 7QQ Wilmington
    Kent
    Sekretär
    Lucky Stones Rowhill Road
    DA2 7QQ Wilmington
    Kent
    British8521670002
    HURLEY, Cornelius Killian
    28 Millenium Wharf
    WD3 1AZ Rickmansworth
    Hertfordshire
    Sekretär
    28 Millenium Wharf
    WD3 1AZ Rickmansworth
    Hertfordshire
    Irish47179960002
    SCOTT, Christopher Richard
    Crow Plain Oast House
    Crow Plain Collier Street
    TN12 9PU Tonbridge
    Kent
    Sekretär
    Crow Plain Oast House
    Crow Plain Collier Street
    TN12 9PU Tonbridge
    Kent
    British81998190003
    STEVENS, Philip Martin
    Forge House Maiden Street
    Weston
    SG4 7AA Hitchin
    Hertfordshire
    Sekretär
    Forge House Maiden Street
    Weston
    SG4 7AA Hitchin
    Hertfordshire
    British102528350001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Bevollmächtigter Sekretär
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT LIMITED
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ground Floor, Ryder Court
    England
    Sekretär
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ground Floor, Ryder Court
    England
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer2176004
    117915530003
    BENNETT, Barry John
    Meadowdown
    Doggetts Wood Close
    HP8 4TL Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Meadowdown
    Doggetts Wood Close
    HP8 4TL Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    United KingdomIrish14707370002
    BORER, Derek
    133 Ridge Lane
    WD17 4SX Watford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    133 Ridge Lane
    WD17 4SX Watford
    Hertfordshire
    British60451400001
    HAMBRO, James Daryl
    Ryder Court, Ground Floor
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Geschäftsführer
    Ryder Court, Ground Floor
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    United KingdomBritish53684400001
    HOLLAND, Philip John
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    England
    Geschäftsführer
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    England
    EnglandBritish163838050001
    HURLEY, Cornelius Killian
    28 Millenium Wharf
    WD3 1AZ Rickmansworth
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    28 Millenium Wharf
    WD3 1AZ Rickmansworth
    Hertfordshire
    United KingdomIrish47179960002
    ISAACS, Paul Samuel
    Rosemead
    Woodhill Road
    CM3 4DY Danbury
    Essex
    Geschäftsführer
    Rosemead
    Woodhill Road
    CM3 4DY Danbury
    Essex
    EnglandBritish141827450001
    NEWMAN, Victor Edward
    70 Oakfield Road
    Southgate
    N14 6LX London
    Geschäftsführer
    70 Oakfield Road
    Southgate
    N14 6LX London
    British23635170001
    SCOTT, Christopher Richard
    Crow Plain Oast House
    Crow Plain Collier Street
    TN12 9PU Tonbridge
    Kent
    Geschäftsführer
    Crow Plain Oast House
    Crow Plain Collier Street
    TN12 9PU Tonbridge
    Kent
    EnglandBritish81998190003
    UPTON, Richard
    Old Bearhurst
    Battenhurst Road
    TN5 7DU Stonegate
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Old Bearhurst
    Battenhurst Road
    TN5 7DU Stonegate
    East Sussex
    EnglandBritish204950320001
    VAUGHAN, Margaret Helen
    Ryder Court, Ground Floor
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Geschäftsführer
    Ryder Court, Ground Floor
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    United KingdomBritish123167120001
    WALKER ARNOTT, Timothy David
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    England
    Geschäftsführer
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    England
    United KingdomBritish61889360004
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PHIP CH LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Primary Health Properties Plc
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor Greener House
    England
    01. Juni 2016
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor Greener House
    England
    Nein
    RechtsformPublic Limited Company
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageCompanies Act
    RegistrierungsortEngland And Wales
    Registrierungsnummer3033634
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.

    Hat PHIP CH LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 02. Apr. 2012
    Geliefert am 04. Apr. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 13. Apr. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 17. März 2008
    Geliefert am 28. März 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    (For details of properties charged please refer to form 395) fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National Treasury Services PLC
    Transaktionen
    • 28. März 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Apr. 2008
    • 16. Juni 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Fixed and floating security agreement
    Erstellt am 01. Juni 2007
    Geliefert am 14. Juni 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Allied Irish Banks P.L.C.
    Transaktionen
    • 14. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Juni 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 01. Juni 2007
    Geliefert am 14. Juni 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    For details of property charged please refer to form 395.. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 14. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Juni 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Juni 2006
    Geliefert am 15. Juni 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that f/h property k/a 250-262 high street sheerness kent. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Juni 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Jan. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 09. Jan. 2006
    Geliefert am 17. Jan. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 17. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Jan. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Jan. 2006
    Geliefert am 11. Jan. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land forming part of the old A23 road west of high street handcross. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Jan. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 26. Nov. 2004
    Geliefert am 02. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 02. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Jan. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0