MICROPONENTS (PLATES) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MICROPONENTS (PLATES) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03218207 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MICROPONENTS (PLATES) LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich MICROPONENTS (PLATES) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 11 Vantage Way Erdington B24 9GZ Birmingham England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MICROPONENTS (PLATES) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ODDJOB QUEENSVILLE 1 LIMITED | 28. Juni 1996 | 28. Juni 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MICROPONENTS (PLATES) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MICROPONENTS (PLATES) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 10. Sept. 2018
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Aug. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 12 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Michael Taylor als Direktor am 21. Apr. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Ian Robert, Mark Mcmurray als Direktor am 21. Apr. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Marina Louise Thomas als Geschäftsführer am 21. Apr. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ian Keith Pargeter als Geschäftsführer am 21. Apr. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Derek John O'neill als Geschäftsführer am 21. Apr. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Simon Robert Grant als Sekretär am 21. Apr. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Atlantic House Aviation Park West, Bournemouth International Airport Christchurch Dorset BH23 6EW zum 11 Vantage Way Erdington Birmingham B24 9GZ am 23. Apr. 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Aug. 2017 mit Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Simon Robert Grant als Sekretär am 28. Okt. 2016 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Marina Thomas als Sekretär am 28. Okt. 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Aug. 2016 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Einzelheiten zur Änderung der an Aktien geknüpften Rechte | 3 Seiten | SH10 | ||||||||||
Änderung der Bezeichnung der Aktienklasse | 2 Seiten | SH08 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MICROPONENTS (PLATES) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCMURRAY, Ian Robert, Mark | Geschäftsführer | Vantage Way Erdington B24 9GZ Birmingham 11 England | England | British | 153191380001 | |||||
| TAYLOR, Michael | Geschäftsführer | Vantage Way Erdington B24 9GZ Birmingham 11 England | England | British | 245595040001 | |||||
| CLOWES, Stephen | Sekretär | 24 Willesley Gardens LE65 2QF Ashby De La Zouch Leicestershire | British | 1764410001 | ||||||
| GRANT, Simon Robert | Sekretär | Vantage Way Erdington B24 9GZ Birmingham 11 England | 217318510001 | |||||||
| HINCHLEY, Karen Jane | Sekretär | 66 Stone Road ST16 2RS Stafford | British | 50580120001 | ||||||
| KERIN, John Brendan | Sekretär | Precision Micro, Vantage Way Erdington B24 9GX Birmingham 11 Uk | British | 56704130004 | ||||||
| THOMAS, Marina | Sekretär | Aviation Park West Bournemouth International Airport BH23 6EW Christchurch Atlantic House Dorset England | British | 170765880001 | ||||||
| CLOWES, Stephen | Geschäftsführer | 24 Willesley Gardens LE65 2QF Ashby De La Zouch Leicestershire | England | British | 1764410001 | |||||
| GOLESTANI, Kian | Geschäftsführer | 2 Hawkesmoor Drive WS14 9YH Lichfield Staffordshire | British | 46764350001 | ||||||
| GREEN, Philip Ernest | Geschäftsführer | Aviation Park West Bournemouth International Airport BH23 6EW Christchurch Atlantic House Dorset England | England | British | 5495960002 | |||||
| HUTCHISON MOSS, James | Geschäftsführer | 455 Lichfield Road B74 4DJ Four Oaks Sutton Coldfield | British | 86536870001 | ||||||
| KERIN, John Brendan | Geschäftsführer | Precision Micro, Vantage Way Erdington B24 9GX Birmingham 11 Uk | England | British | 56704130004 | |||||
| MARRETT, Anthony Rex | Geschäftsführer | Precision Micro, Vantage Way Erdington B24 9GX Birmingham 11 Uk | England | British | 68981240003 | |||||
| MARRETT, Nicola Kathryn | Geschäftsführer | 17 Bishops Road B73 6HX Sutton Coldfield West Midlands | United Kingdom | British | 86353140001 | |||||
| MARRETT, Norman Rex | Geschäftsführer | Joberns Cottage Little Hay Lane WS14 0QD Lichfield Staffordshire | British | 1764420002 | ||||||
| MARRETT, Zoe Louise | Geschäftsführer | 8 Woodside Road HP9 1JG Beaconsfield Buckinghamshire | British | 86353350001 | ||||||
| O'NEILL, Derek John | Geschäftsführer | Vantage Way Erdington B24 9GZ Birmingham 11 England | United Kingdom | British | 87573010001 | |||||
| PARGETER, Ian Keith | Geschäftsführer | Vantage Way Erdington B24 9GZ Birmingham 11 England | England | British | 123123230001 | |||||
| THOMAS, Marina Louise | Geschäftsführer | Vantage Way Erdington B24 9GZ Birmingham 11 England | England | British | 183635400001 | |||||
| TWIGGER, Terence | Geschäftsführer | Aviation Park West Bournemouth International Airport BH23 6EW Christchurch Atlantic House Dorset England | England | British | 45754710002 | |||||
| YOUNG, Mark Lees | Geschäftsführer | Aviation Park West Bournemouth International Airport BH23 6EW Christchurch Atlantic House Dorset England | England | British | 85330350002 | |||||
| YOUNG, Stephen Gareth | Geschäftsführer | Aviation Park West Bournemouth International Airport BH23 6EW Christchurch Atlantic House Dorset England | United Kingdom | British | 21273730002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MICROPONENTS (PLATES) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotomechanix Limited | 06. Apr. 2016 | Aviation Park West Bournemouth International Airport BH23 6EW Christchurch Atlantic House Dorset England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat MICROPONENTS (PLATES) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 01. Nov. 2003 Geliefert am 05. Nov. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| All assets debenture deed | Erstellt am 10. Dez. 2002 Geliefert am 18. Dez. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. Aug. 1998 Geliefert am 11. Aug. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge | Erstellt am 10. Okt. 1997 Geliefert am 16. Okt. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 1 x new atotech pre clean machine ref. 8609-005 serial no. 070-5462. 1 x new atotech developer ref. 8609-002, serial no. 070-5459. 1 x new atotech stripper ref. 8609-004, serial no. 070-5461.. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0