FORENSIC ALLIANCE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | FORENSIC ALLIANCE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03218467 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von FORENSIC ALLIANCE LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich FORENSIC ALLIANCE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Lgc Queens Road TW11 0LY Teddington Middlesex |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FORENSIC ALLIANCE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für FORENSIC ALLIANCE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 08. Sept. 2023
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Juni 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
legacy | 90 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE1 | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | AGREEMENT1 | ||||||||||||||
Ernennung von Ms Lucy Richards als Sekretär am 01. Sept. 2022 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Teri-Anne Cavanagh als Sekretär am 31. Aug. 2022 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Juni 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Alex Thieffry als Direktor am 28. März 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Simon Lawrence Parsons als Geschäftsführer am 24. Jan. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||||||||||||||
legacy | Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | AGREEMENT1 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Euan Ralph Herbert O'sullivan als Direktor am 17. Sept. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy Michael Robinson als Geschäftsführer am 17. Sept. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Juni 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Ernennung von Teri-Anne Cavanagh als Sekretär am 09. Okt. 2020 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
legacy | 85 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | AGREEMENT1 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von FORENSIC ALLIANCE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICHARDS, Lucy | Sekretär | Queens Road TW11 0LY Teddington Lgc Middlesex | 299867120001 | |||||||
| O'SULLIVAN, Euan Ralph Herbert | Geschäftsführer | Queens Road TW11 0LY Teddington Lgc United Kingdom | United Kingdom | British | 218968870001 | |||||
| THIEFFRY, Alex | Geschäftsführer | Queens Road TW11 0LY Teddington Lgc Middlesex | United Kingdom | French | 294526140001 | |||||
| CAVANAGH, Teri-Anne | Sekretär | Queens Road TW11 0LY Teddington Lgc United Kingdom | 283015650001 | |||||||
| CHOW, Maxine | Sekretär | L G C Queens Road TW11 0LY Teddington Middlesex | British | 99327160002 | ||||||
| DONALD, Keith | Sekretär | Queens Road TW11 0LY Teddington Lgc Middlesex England | 195096150001 | |||||||
| GALLOP, Angela Mary Cecilia, Dr | Sekretär | Lgc Queens Road TW11 0LY Teddington Middlesex | British | 107943190001 | ||||||
| HARRISON, Irene Lesley | Bevollmächtigter Sekretär | Fy Mwthin 22 Merthyr Road Tongwynlais CF15 7LH Cardiff South Glamorgan | British | 900003790001 | ||||||
| ILETT, John Edward | Sekretär | Queens Road Teddington TW11 0LY Middlesex | 157007450001 | |||||||
| OGLE, Navneet Kaur | Sekretär | Queens Road TW11 0LY Teddington Lgc Middlesex | 213641530001 | |||||||
| PARSONS, Simon Lawrence | Sekretär | Queens Road Teddington TW11 0LY Middlesex | 155396600001 | |||||||
| RUSSELL, Keith John | Sekretär | Elsfield Crafts End Chilton OX11 0SA Didcot Oxfordshire | British | 44863460001 | ||||||
| STOCKDALE, Russell Eric | Sekretär | Linden Cottage Oxford Street Eddington RG17 0EU Hungerford Berkshire | British | 38688450001 | ||||||
| CLARKS NOMINEES LIMITED | Sekretär | One Forbury Square The Forbury RG1 3EB Reading | 38350670003 | |||||||
| ALEXANDER, Mark Charles Hugh Orkell | Geschäftsführer | Sherborne House Green Lane Uffington SN7 7SA Faringdon Oxfordshire | Uk | British | 75272090001 | |||||
| BALCHIN, Ian Henry | Geschäftsführer | Grovelands 22 Station Road OX10 9PT Cholsey Oxfordshire | England | British | 122493020001 | |||||
| BALL, Richard Gerald James | Geschäftsführer | The Birches High Street Fernham SN7 7NY Faringdon Oxfordshire | British | 77864160001 | ||||||
| BATTERSBY, Geoffrey Brian | Geschäftsführer | Lgc Queens Road TW11 0LY Teddington Middlesex | United Kingdom | British | 101764920001 | |||||
| GALLOP, Angela Mary Cecilia, Dr | Geschäftsführer | Lgc Queens Road TW11 0LY Teddington Middlesex | England | British | 107943190001 | |||||
| HUNT, Simon Anthony | Geschäftsführer | Apt 31 21 Sheldon Square Paddington Central W2 6DS London | British | 118771650001 | ||||||
| JAMIESON, Allan, Dr | Geschäftsführer | 5 Westerton Road G68 0FF Dullatur | Scotland | British | 76469300001 | |||||
| LAW, Nigel Carey, Dr | Geschäftsführer | Lgc Queens Road TW11 0LY Teddington Middlesex | British | 86509640004 | ||||||
| LINDSAY, David | Geschäftsführer | 92 Sandringham Road WD24 7BE Watford Hertfordshire | British | 78093740001 | ||||||
| MARSON, David John | Geschäftsführer | Langdale 5a Benett Close RG14 1PU Newbury Berkshire | England | British | 116010880002 | |||||
| MASON, John Philip, Dr | Geschäftsführer | L G C Queens Road TW11 0LY Teddington Middlesex | British | 107789130001 | ||||||
| NEWTON, Keith, Dr | Geschäftsführer | 26 North Avenue OX14 1QW Abingdon Oxfordshire | United Kingdom | United Kingdom | 76088110001 | |||||
| PALMER, Thomas Stapleton | Geschäftsführer | Albury House Berry Lane, East Hanney OX12 0JB Wantage Oxfordshire | British | 82499660001 | ||||||
| PARSONS, Simon Lawrence | Geschäftsführer | Queens Road TW11 0LY Teddington Lgc Limited Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | 155383010002 | |||||
| RAYBONE, David | Geschäftsführer | 1 Talbot Cottages Fosseway, Stow On The Wold GL54 1DW Cheltenham Gloucestershire | British | 70448790001 | ||||||
| RICHARDSON, David Gordon | Geschäftsführer | Lgc Queens Road TW11 0LY Teddington Middlesex | United Kingdom | British | 175080930001 | |||||
| ROBINSON, Timothy Michael | Geschäftsführer | Queens Road TW11 0LY Teddington Lgc Middlesex England | United Kingdom | British | 178620810001 | |||||
| RUSSELL, Keith John | Geschäftsführer | Elsfield Crafts End Chilton OX11 0SA Didcot Oxfordshire | British | 44863460001 | ||||||
| STOCKDALE, Russell Eric | Geschäftsführer | Linden Cottage Oxford Street Eddington RG17 0EU Hungerford Berkshire | British | 38688450001 | ||||||
| THOMAS, Robert Graham, Dr | Geschäftsführer | Freelyn The Cleave Harwell OX11 0EL Didcot Oxfordshire | British | 38423190001 | ||||||
| WORSWICK, Richard David, Dr | Geschäftsführer | Lgc Queens Road TW11 0LY Teddington Middlesex | United Kingdom | British | 47524980002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei FORENSIC ALLIANCE LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lgc Coleshill Limited | 30. Juni 2016 | Queens Road TW11 0LY Teddington Lgc England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat FORENSIC ALLIANCE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Security accession deed | Erstellt am 07. Okt. 2005 Geliefert am 14. Okt. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any security party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement dated | Erstellt am 16. Juni 2004 Geliefert am 18. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. Juni 2004 Geliefert am 18. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal assignment of keyman policies | Erstellt am 24. Dez. 2002 Geliefert am 07. Jan. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The policy, all sums assured by it and all bonuses and benefits which may arise under it and right title and interest present and future in the policy - scottish equitable PLC i/01/97754/622DY angela gallop £1,000,000. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Cross-guarantee and debenture | Erstellt am 31. Okt. 2002 Geliefert am 06. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Juni 1998 Geliefert am 08. Juli 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0