TRANSACSYS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | TRANSACSYS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03221130 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TRANSACSYS LIMITED?
- (7260) /
Wo befindet sich TRANSACSYS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Davidson House Gadbrook Park CW9 7TW Northwich Cheshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TRANSACSYS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| TRANSACSYS PLC | 06. Apr. 2000 | 06. Apr. 2000 |
| GIROVEND CASHLESS SYSTEMS PLC | 21. Feb. 1997 | 21. Feb. 1997 |
| ROBINBUY PLC | 05. Juli 1996 | 05. Juli 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TRANSACSYS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TRANSACSYS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Juli 2010 mit umfangreicher Liste der Aktionäre | 16 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2009 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Smyth als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
legacy | 8 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 8 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 8 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2008 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2007 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TRANSACSYS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOGAN, Brenda Mary | Sekretär | Sandyford View Simonsridge Blackglen Road Sandyford Dublin 18 Apartment 55, Ireland | Other | 130814140001 | ||||||
| EDWARDS, Mark Simon | Geschäftsführer | 2 Brook House Court Lakeside Road WA13 0GR Lymm Cheshire | British | 109659860001 | ||||||
| MALONEY, Michael John | Geschäftsführer | Beechwood Road Ranelagh 8 Dublin 6 Ireland | Ireland | Irish | 161364970001 | |||||
| FIETH, Robin Paul | Sekretär | Timbers Pyrton OX49 5AP Watlington Oxfordshire | British | 49907850002 | ||||||
| GREGSON, Robin Anthony | Sekretär | 2 Lakeside East Morton BD20 5UY Keighley West Yorkshire | English | 107835250001 | ||||||
| HARRINGTON, Michael | Sekretär | 28 Arlington Avenue N1 7AX London | British | 42936520001 | ||||||
| KATZ, Peter David | Sekretär | 20 Tudor Close IG8 0LF Woodford Green Essex | British | 64682050001 | ||||||
| LANIGAN, Philip Nicholas | Sekretär | 120 Buckingham Road SK4 4RG Stockport Cheshire | British | 42734310002 | ||||||
| NEUBAUER, Eirion Andrew Charles | Sekretär | Flat 11 Kingsley Lodge 13 New Cavendish Street W1G 9UG London | British | 116252510001 | ||||||
| PECK, Martin David | Sekretär | 30 Crofton Avenue Chiswick W4 3EW London | British | 78149370002 | ||||||
| WATERLOW SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003950001 | |||||||
| ALLEN, Matthew Charles | Geschäftsführer | 75 Park Road W4 3EY London | England | British | 37599910001 | |||||
| BEERLING, Kevin Michael | Geschäftsführer | 14 Firside Grove DA15 8WB Sidcup Kent | United Kingdom | British | 64677850002 | |||||
| BRIGHT, Keith, Sir | Geschäftsführer | 16 Westbourne Park Villas W2 5EA London | United Kingdom | British | 1770160001 | |||||
| CLARK, Ronald Thomson | Geschäftsführer | Gill House Runsell Green, Danbury CM3 4QZ Chelmsford Essex | British | 69705410001 | ||||||
| CLYDE, James Donald Laurence | Geschäftsführer | 12 Arundel Gardens W11 2LA London Greater London | British | 54439570001 | ||||||
| DITCHBURN, John Blackett Dennison | Geschäftsführer | The Laurels Frieth RG9 6PJ Henley On Thames Oxfordshire | British | 61233990002 | ||||||
| FIETH, Robin Paul | Geschäftsführer | Timbers Pyrton OX49 5AP Watlington Oxfordshire | England | British | 49907850002 | |||||
| GAHAGNON, Jacques Andre | Geschäftsführer | 92 Place Louvois Velizy 78140 France | French | 68163380001 | ||||||
| GOVETT, Nigel Jeremy Cloudesley | Geschäftsführer | 15 Tantallon Court Woodstone Village DH4 6TJ Houghton Le Spring County Durham | British | 89929500001 | ||||||
| GREGSON, Robin Anthony | Geschäftsführer | 2 Lakeside East Morton BD20 5UY Keighley West Yorkshire | England | English | 107835250001 | |||||
| LAING, Andrew Murray | Geschäftsführer | 14 Petley Road W6 9ST London | British | 28771390001 | ||||||
| LANIGAN, Philip Nicholas | Geschäftsführer | 120 Buckingham Road SK4 4RG Stockport Cheshire | England | British | 42734310002 | |||||
| MASSEY, Peter Derek | Geschäftsführer | Pullington House Pullington Cottages Benenden TN17 4EH Cranbrook Kent | British | 42440170003 | ||||||
| MCGRANE, Paul Steven | Geschäftsführer | 21 Stony Lane NR10 4QS Reepham Norwich | United Kingdom | British | 51004210002 | |||||
| MCNAIR, Iain | Geschäftsführer | 23 Mycenae Road SE3 7SF London Greater London | British | 85499250001 | ||||||
| MCNAIR, John | Geschäftsführer | 7 Westcombe Park Road SE3 7RE London | British | 61297520001 | ||||||
| MILLS, Mark Richard | Geschäftsführer | 55 Hove Road FY8 1XH Lytham St Annes Lancashire | British | 10402540005 | ||||||
| MURPHY, James Timmerman | Geschäftsführer | Park Ave #10c Nyc 1120 10728 New York Usa | American | 130237490001 | ||||||
| NEUBAUER, Eirion Andrew Charles | Geschäftsführer | Flat 11 Kingsley Lodge 13 New Cavendish Street W1G 9UG London | England | British | 116252510001 | |||||
| NEWMARCH, Michael George | Geschäftsführer | 7 The Bromptons Rose Square SW3 6RS London | British | 1109560005 | ||||||
| PECK, Martin David | Geschäftsführer | 30 Crofton Avenue Chiswick W4 3EW London | England | British | 78149370002 | |||||
| SALMON, Claire Louise | Geschäftsführer | Flat 2 47 Montagu Square W1H 1TH London | British | 70197550002 | ||||||
| SAXTON, Paul | Geschäftsführer | 19 Ashdale Close ST7 2EN Alsager Staffordshire | British | 121726830001 | ||||||
| SMART, Richard Ernest | Geschäftsführer | Oak House,Webbs Lane Beenham RG7 5LL Reading Berkshire | British | 7970090001 |
Hat TRANSACSYS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Accession deed to an intercreditor deed | Erstellt am 21. Feb. 2006 Geliefert am 07. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any member of the group to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By clause 5.1 (turnover: turnover obligations) of the deed until after the discharge date if the additional obligor receives or recovers any intra-group recoveries except for any permitted intra-group payments, it shall pay all such assets and monies received or recovered by it (the turnover receipts) to the chargee for application in accordance with clause 10 (application of recoveries) of the deed. Pending such payment to the chargee, the additional obligor shall hold the same on trust for the application by the chargee in accordance with clause 10 (application of recoveries) of the deed. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Syndicated debenture | Erstellt am 21. Feb. 2006 Geliefert am 07. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 12. Juli 2005 Geliefert am 15. Juli 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All land (other than the short l/h land) rights in atm equipment, all other plant, machinery, vehicles and other equipment used in a business, investments; any contract entered into after the date of the debenture which is designated as a key contract by moneybox PLC and the chargee, any account, all copyright, any monetary claim of any kind and goodwill and uncalled capital, floating charge the company's undertaking and all its present and future assets;. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 15. Okt. 1999 Geliefert am 27. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company (formerly known as girovend cashless systems PLC) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All rights, title and interest in the assigned cash (as defined in the rent deposit deed) and the debts represented by it. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 25. Feb. 1997 Geliefert am 11. März 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from all or any of the companies mentioned therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All f/h and l/h land in england and wales now vested in the company including (but not limited to) the property at unit 6 (formerly unit B4) progress business centre,whittle parkway,bath road,slough t/no.bk 266697. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0