MATCHING HAT LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMATCHING HAT LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03223680
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MATCHING HAT LIMITED?

    • Veröffentlichung von Verbraucher- und Wirtschaftszeitschriften und -periodika (58142) / Information und Kommunikation

    Wo befindet sich MATCHING HAT LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Haymarket House
    28-29 Haymarket
    SW1Y 4RX London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MATCHING HAT LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für MATCHING HAT LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    8 SeitenLIQ13

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    6 SeitenLIQ01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 28. Sept. 2018

    LRESSP

    Notification of Neal Moszkowski as a person with significant control on 13. Apr. 2017

    2 SeitenPSC01

    Bestätigungserklärung erstellt am 11. Juli 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Notification of Ramez Sousou as a person with significant control on 13. Apr. 2017

    2 SeitenPSC01

    Cessation of Infopro Digital Limited as a person with significant control on 13. Apr. 2017

    1 SeitenPSC07

    Bestätigungserklärung erstellt am 11. Juli 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Change of details for Incisive Media Limited as a person with significant control on 02. Juni 2017

    2 SeitenPSC05

    Beendigung der Bestellung von James Neil Campbell-Harris als Sekretär am 12. Apr. 2017

    2 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von James Neil Campbell-Harris als Geschäftsführer am 12. Apr. 2017

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Timothy Grainger Weller als Geschäftsführer am 12. Apr. 2017

    2 SeitenTM01

    Ernennung von Dr Julien Jacques Alexandre Elmaleh als Direktor am 12. Apr. 2017

    3 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Christophe Czajka als Direktor am 12. Apr. 2017

    3 SeitenAP01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    8 SeitenAA

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    8 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 032236800009 vollständig

    4 SeitenMR04

    Bestätigungserklärung erstellt am 11. Juli 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Juli 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital12. Aug. 2015

    Kapitalaufstellung am 12. Aug. 2015

    • Kapital: GBP 11
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Timothy Grainger Weller am 27. Juli 2015

    2 SeitenCH01

    Eintragung der Belastung 032236800009, erstellt am 17. Dez. 2014

    69 SeitenMR01

    Wer sind die Geschäftsführer von MATCHING HAT LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CZAJKA, Christophe
    Haymarket House
    28-29 Haymarket
    SW1Y 4RX London
    Geschäftsführer
    Haymarket House
    28-29 Haymarket
    SW1Y 4RX London
    United KingdomFrench215645850001
    ELMALEH, Julien Jacques Alexandre
    Haymarket House
    28-29 Haymarket
    SW1Y 4RX London
    Geschäftsführer
    Haymarket House
    28-29 Haymarket
    SW1Y 4RX London
    FranceFrench183645440001
    CAMPBELL-HARRIS, James Neil
    Field House Wormsley
    OX49 5HX Watlington
    Oxfordshire
    Sekretär
    Field House Wormsley
    OX49 5HX Watlington
    Oxfordshire
    British62282140001
    COCHRAN, Gerald Charles
    The Little House 10 Lime Avenue
    Abington
    NN3 2HB Northampton
    Sekretär
    The Little House 10 Lime Avenue
    Abington
    NN3 2HB Northampton
    British2432040001
    TUBBS, Daniel Hayden
    Pagehurst Cottage
    Stepneyford Lane
    TN17 4BW Benenden
    Kent
    Sekretär
    Pagehurst Cottage
    Stepneyford Lane
    TN17 4BW Benenden
    Kent
    British99135660001
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    BROADHURST, Luke
    15 Southgate Grove
    N1 5BP London
    Geschäftsführer
    15 Southgate Grove
    N1 5BP London
    British70458580002
    CAMPBELL-HARRIS, James Neil
    Field House Wormsley
    OX49 5HX Watlington
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Field House Wormsley
    OX49 5HX Watlington
    Oxfordshire
    EnglandBritish62282140001
    HANBURY, James Anthony Christopher
    West Ilsley
    RG20 7AR Newbury
    The Old Rectory
    Berkshire
    Geschäftsführer
    West Ilsley
    RG20 7AR Newbury
    The Old Rectory
    Berkshire
    United KingdomBritish42330180003
    HIGGINS, Paul James
    19 Fields Park Road
    NP9 5BA Newport
    Gwent
    Geschäftsführer
    19 Fields Park Road
    NP9 5BA Newport
    Gwent
    EnglandBritish22612650002
    MCKNIGHT, Kevin John
    Cobbett Hill Cottage
    Cobbett Hill Road
    GU3 2AA Normandy
    Surrey
    Geschäftsführer
    Cobbett Hill Cottage
    Cobbett Hill Road
    GU3 2AA Normandy
    Surrey
    British10915910004
    SAGAR, Sewak Bharat Singh
    137 Ember Lane
    KT10 8EH Esher
    Surrey
    Geschäftsführer
    137 Ember Lane
    KT10 8EH Esher
    Surrey
    British20561040002
    STIBBS, Christopher John
    14 Broxbournebury Mews
    White Stubbs Lane
    EN10 7JA Broxbourne
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    14 Broxbournebury Mews
    White Stubbs Lane
    EN10 7JA Broxbourne
    Hertfordshire
    British57797250002
    STUART, Andrew Peter
    102 Lyndhurst Grove
    SE15 5AH London
    Geschäftsführer
    102 Lyndhurst Grove
    SE15 5AH London
    British20561050002
    TOWARD, James
    156a Ferndale Road
    SW4 7SA London
    Geschäftsführer
    156a Ferndale Road
    SW4 7SA London
    British70458620001
    WELLER, Timothy Grainger
    Haymarket House
    28-29 Haymarket
    SW1Y 4RX London
    Geschäftsführer
    Haymarket House
    28-29 Haymarket
    SW1Y 4RX London
    EnglandBritish54854850005
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MATCHING HAT LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr Ramez Sousou
    St. James's Market
    SW1Y 4AH London
    Towerbrook Capital Partners (Uk) Llp
    England
    13. Apr. 2017
    St. James's Market
    SW1Y 4AH London
    Towerbrook Capital Partners (Uk) Llp
    England
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: United Kingdom
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.
    Mr Neal Moszkowski
    65 East 55th Street
    10022 New York City
    Towerbrook Capital Partners Lp
    New York
    United States
    13. Apr. 2017
    65 East 55th Street
    10022 New York City
    Towerbrook Capital Partners Lp
    New York
    United States
    Nein
    Nationalität: American
    Staatsangehörigkeit: United States
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.
    Infopro Digital Limited
    28-29 Haymarket
    SW1Y 4RX London
    Haymarket House
    England
    06. Apr. 2016
    28-29 Haymarket
    SW1Y 4RX London
    Haymarket House
    England
    Ja
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageEngland And Wales
    RegistrierungsortRegistrar Of Companies For England And Wales
    Registrierungsnummer4038503
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat MATCHING HAT LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 17. Dez. 2014
    Geliefert am 18. Dez. 2014
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 18. Dez. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 27. Juli 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite debenture
    Erstellt am 19. Dez. 2006
    Geliefert am 22. Dez. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Juli 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Supplemental deed to a debenture
    Erstellt am 06. Juli 2006
    Geliefert am 15. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group company to the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 15. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Jan. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite debenture
    Erstellt am 05. Sept. 2002
    Geliefert am 18. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group company to the security beneficiaries on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC(The Security Agent)
    Transaktionen
    • 18. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Jan. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of keyman life policies
    Erstellt am 10. Aug. 2001
    Geliefert am 16. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The policies all sums assured by them and all bonuses and benefits which may arise under them and the company's whole right,title and interest present and future in the policies.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 16. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Okt. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 10. Aug. 2001
    Geliefert am 16. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 16. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Okt. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment of life policies
    Erstellt am 20. Jan. 1997
    Geliefert am 25. Jan. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Scottish widows' fund and life assurance society,policy/no 5377554 in the name of sewak bharat sagar for £250,000 with all rights,benefits thereon.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 25. Jan. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment of life policies
    Erstellt am 20. Jan. 1997
    Geliefert am 25. Jan. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Scottish widows' fund and life assurance society policy/no 5377659 in the name of andrew peter stuart for £250,000 with all rights,benefits thereon.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 25. Jan. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 09. Okt. 1996
    Geliefert am 11. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat MATCHING HAT LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    28. Sept. 2018Beginn der Liquidation
    08. Jan. 2020Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Emma Cray
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praktiker
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0