INTERTEK FINANCE PLC
Überblick
Unternehmensname | INTERTEK FINANCE PLC |
---|---|
Unternehmensstatus | Aktiv |
Rechtsform | Aktiengesellschaft |
Unternehmensnummer | 03226960 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von INTERTEK FINANCE PLC?
- Finanzintermediation sonst. n.n.a. (64999) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich INTERTEK FINANCE PLC?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Academy Place 1-9 Brook Street CM14 5NQ Brentwood Essex |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von INTERTEK FINANCE PLC?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
ALNERY NO. 1579 LIMITED | 19. Juli 1996 | 19. Juli 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von INTERTEK FINANCE PLC?
Überfällig | Nein |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2024 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Juni 2025 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2023 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für INTERTEK FINANCE PLC?
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 03. Apr. 2025 |
---|---|
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 17. Apr. 2025 |
Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 03. Apr. 2024 |
Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für INTERTEK FINANCE PLC?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Änderung der Details des Direktors für Mrs Ida Maria Woodger am 17. Juli 2024 | 2 Seiten | CH01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2023 | 39 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Apr. 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Steven Eggleston als Geschäftsführer am 30. Nov. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mrs Laura Crespi als Direktor am 30. Nov. 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 37 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Apr. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Mrs Ida Maria Woodger als Direktor am 31. März 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Fiona Maria Evans als Geschäftsführer am 31. März 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr Colm Deasy als Direktor am 22. März 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Jonathan Timmis als Geschäftsführer am 22. März 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr Steven Eggleston als Direktor am 24. Nov. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Julia Hedley als Geschäftsführer am 24. Nov. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Jonathan Timmis am 01. Juni 2022 | 2 Seiten | CH01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 38 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Apr. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 37 Seiten | AA | ||
Ernennung von Julia Hedley als Direktor am 12. Apr. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mr Jonathan Timmis als Direktor am 12. Apr. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Nicholas Anthony Hare als Geschäftsführer am 12. Apr. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Ross Mccluskey als Geschäftsführer am 12. Apr. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Apr. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 37 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Apr. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 37 Seiten | AA | ||
Wer sind die Geschäftsführer von INTERTEK FINANCE PLC?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERTEK SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 1-9 Brook Street CM14 5NQ Brentwood Academy Place Essex England |
| 174785220001 | ||||||||||
CRESPI, Laura | Geschäftsführer | Cavendish Square W1G 0PS London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Manager | 316533670001 | ||||||||
DEASY, Colm | Geschäftsführer | 33 Cavendish Square W1G 0PS London C/O Intertek Group Plc United Kingdom | United Kingdom | Irish | Chief Financial Officer | 306920600001 | ||||||||
WOODGER, Ida Maria | Geschäftsführer | 33 Cavendish Square W1G 0PS London C/O Intertek Group Plc United Kingdom | United Kingdom | German | Group Company Secretary | 200529280003 | ||||||||
EVANS, Fiona Maria | Sekretär | 164 Duke Road Chiswick W4 2DF London | British | Group Company Secretary | 49259690004 | |||||||||
GOODRICH, Brian John | Sekretär | 17 West Hallowes Mottingham SE9 4EY London | British | 269830001 | ||||||||||
HALE, Sarah | Sekretär | 81 Burlington Rise EN4 8NN East Barnet Hertfordshire | British | 79558940001 | ||||||||||
HORNBUCKLE, Steven Colin | Sekretär | 19 Craven Avenue Ealing W5 2SY London | British | 73547870004 | ||||||||||
MELLOR, Margaret Louise | Sekretär | 51 Forest Side Chingford E4 6BA London | British | 80354780001 | ||||||||||
RICE, David Marcus John | Sekretär | 11 Shooters Hill Road SE3 7AR London | British | 78144340001 | ||||||||||
TURNER, David Charles | Sekretär | 13 Thorndales St Johns Avenue CM14 5DE Brentwood Essex | Other | 84007940001 | ||||||||||
WALMSLEY, Debbie | Sekretär | 1-9 Brook Street CM14 5NQ Brentwood Academy Place Essex England | 168054390001 | |||||||||||
ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 9 Cheapside EC2V 6AD London | 900002920001 | |||||||||||
BURGE, Julian Charles | Geschäftsführer | 1-9 Brook Street CM14 5NQ Brentwood Academy Place Essex England | England | British | Accountant | 193595270001 | ||||||||
EGGLESTON, Steven | Geschäftsführer | 1-9 Brook Street CM14 5NQ Brentwood Academy Place Essex England | United Kingdom | British | Group Head Of Tax & Treasury | 302608640001 | ||||||||
EVANS, Fiona Maria | Geschäftsführer | 33 Cavendish Square W1G 0PS London C/O Intertek Group Plc United Kingdom | United Kingdom | British | Group Company Secretary | 49259690006 | ||||||||
HARDY, Joanne Catherine Kennedy | Geschäftsführer | 3e St John's Hill TN13 3NX Sevenoaks Kennedy Towers Kent United Kingdom | England | British | Accountant | 94239790002 | ||||||||
HARE, Nicholas Anthony | Geschäftsführer | 1-9 Brook Street CM14 5NQ Brentwood Academy Place Essex England | United Kingdom | British | Deputy Group Financial Controller | 247025470002 | ||||||||
HAUSER, Wolfhart Gunnar, Dr | Geschäftsführer | Savile Row W1S 2ES London 25 England | United Kingdom | German | Chief Executive Officer | 85711980002 | ||||||||
HEDLEY, Julia | Geschäftsführer | 1-9 Brook Street CM14 5NQ Brentwood Academy Place Essex England | England | British | Group Director Of Financial Reporting | 282662230001 | ||||||||
LEIGH, Edward John Charles | Geschäftsführer | 1-9 Brook Street CM14 5NQ Brentwood Academy Place Essex England | United Kingdom | British | Finance Manager | 177785150001 | ||||||||
MCCLUSKEY, Ross | Geschäftsführer | 33 Cavendish Square W1G 0PS London C/O Intertek Group Plc United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 165677350040 | ||||||||
MOORE, Paul Anthony | Geschäftsführer | Savile Row W1S 2ES London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 194306140001 | ||||||||
NELSON, Richard Campbell | Geschäftsführer | 8 Pembridge Place W2 4XB London | United Kingdom | British | Chief Executive Officer | 11004600001 | ||||||||
PITCHFORD, Lloyd Mark | Geschäftsführer | 25 Savile Row W1S 2ES London C/O Intertek Group Plc United Kingdom | England | British | Chartered Accountant | 151278490001 | ||||||||
SKINNER, Matthew Paul | Geschäftsführer | 1-9 Brook Street CM14 5NQ Brentwood Academy Place Essex England | United Kingdom | British | Company Director | 169191000001 | ||||||||
SPENCER, William | Geschäftsführer | Savile Row W1S 2ES London 25 England | England | British | Finance Director | 44974830004 | ||||||||
TIMMIS, Jonathan Paul | Geschäftsführer | Cavendish Square W1G 0PS London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Financial Officer | 241371800006 | ||||||||
ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 9 Cheapside EC2V 6AD London | 900002920001 | |||||||||||
ALNERY INCORPORATIONS NO 2 LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 9 Cheapside EC2V 6AD London | 900002910001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei INTERTEK FINANCE PLC?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intertek Testing Services Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | 1-9 Brook Street CM14 5NQ Brentwood Academy Place Essex England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat INTERTEK FINANCE PLC Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 09. Apr. 2014 Geliefert am 11. Apr. 2014 | Ausstehend | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 27. Mai 2002 Geliefert am 06. Juni 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A second ranking debenture | Erstellt am 27. Juli 2001 Geliefert am 13. Aug. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other beneficiaries (as defined) in respect of the term c facility (as defined) under or pursuant to the senior facility documents (as defined),including this debenture, and including any liability in respect of any further advances made under the term c facility | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security assignment | Erstellt am 08. Nov. 1996 Geliefert am 27. Nov. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The payment in full of all sums from time to time due and payable from the company to the chargee under us$203,000,000 10 1/4% senior subordinated notes due 2006 (the "notes") issued by the company and an indenture under which the "notes" were issued dated 8TH november 1996 (as defined therein) (the "indenture") | |
Kurze Angaben All right title and interest in and to the entire benefit of the loan agreement dated 8TH november 1996 under which the company agreed to lend the amount of us$153,904,273 to testing holdings usa, inc and the loan agreement dated 8TH november under which the company agreed to lend the amount of us$41,115,257 to yickson enterprises limited. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 08. Nov. 1996 Geliefert am 20. Nov. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0