WALLHEAD NO.1 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | WALLHEAD NO.1 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03227465 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WALLHEAD NO.1 LIMITED?
- (7011) /
Wo befindet sich WALLHEAD NO.1 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 3 Hardman Street Spinningfields M3 3HF Manchester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von WALLHEAD NO.1 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ALNERY NO. 1602 LIMITED | 19. Juli 1996 | 19. Juli 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WALLHEAD NO.1 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2008 |
Welche sind die letzten Einreichungen für WALLHEAD NO.1 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Buckley Road Rochdale Lancashire OL12 9DT am 19. Jan. 2010 | 1 Seiten | AD01 | ||
Beendigung der Bestellung von Vincent Vaccaro als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 11 Seiten | AA | ||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Juni 2009 | 10 Seiten | AR01 | ||
Ernennung von Kenneth Clive Ramsey als Sekretär | 2 Seiten | AP03 | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 11 Seiten | AA | ||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 9 Seiten | AA | ||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005 | 9 Seiten | AA | ||
legacy | 3 Seiten | 403a | ||
legacy | 2 Seiten | 403a | ||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||
legacy | 2 Seiten | 403a | ||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2004 | 9 Seiten | AA | ||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2003 | 8 Seiten | AA | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2002 | 13 Seiten | AA | ||
Wer sind die Geschäftsführer von WALLHEAD NO.1 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMSEY, Kenneth Clive | Sekretär | Post Road PO BOX 457 Bernardsville 261 New Jersey 07924 United States | British | 147884580001 | ||||||
| RAMSEY, Kenneth Clive | Geschäftsführer | 261 Post Road PO BOX 457 Bernardsville New York Ny 07924 Usa | Canadian | 50997270001 | ||||||
| ADAMS, Paul Francis | Sekretär | 2 Mercer Court Rawlinson Lane Heath Charnock PR7 4EE Chorley Lancashire | British | 10466670002 | ||||||
| ROBINSON, Stephen Paul | Sekretär | 18 Greenway Appleton WA4 3AD Warrington Cheshire | British | 48947320002 | ||||||
| ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 9 Cheapside EC2V 6AD London | 900002920001 | |||||||
| ADAMS, Paul Francis | Geschäftsführer | 2 Mercer Court Rawlinson Lane Heath Charnock PR7 4EE Chorley Lancashire | British | 10466670002 | ||||||
| RICHARDSON, Keith Alan | Geschäftsführer | 15 Stonecross Drive Rainhill L35 6DD Prescot Merseyside | British | 63587450001 | ||||||
| RINK, Anthony Arnold | Geschäftsführer | Bhandar 20 Regent Road Lostock BL6 4DJ Bolton Lancashire | British | 8090460001 | ||||||
| RINK, Paul James Ernest | Geschäftsführer | 2 Warth Farm Cottages Coppice Lane White Coppice PR6 9DB Chorley Lancashire | England | British | 28006060003 | |||||
| ROBINSON, Stephen Paul | Geschäftsführer | 18 Greenway Appleton WA4 3AD Warrington Cheshire | United Kingdom | British | 48947320002 | |||||
| VACCARO, Vincent Joseph | Geschäftsführer | 57 Wagner Road Stockton New Jersey 08559 Usa | American | 63721610001 | ||||||
| ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 9 Cheapside EC2V 6AD London | 900002920001 | |||||||
| ALNERY INCORPORATIONS NO 2 LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 9 Cheapside EC2V 6AD London | 900002910001 |
Hat WALLHEAD NO.1 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 08. Apr. 1999 Geliefert am 20. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 17. Okt. 1997 Geliefert am 22. Okt. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this legal charge | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage f/h land and buildings on the east side of kingsway rochdale t/nos. GM745712 and GM752127. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed amending debenture relating to a debenture dated 10TH february 1997 issued by the company | Erstellt am 17. Okt. 1997 Geliefert am 22. Okt. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture and/or the amending deed | |
Kurze Angaben 1. by the insertion of the following words at the end of the second line in clause 3 of the debenture and after the words "by the company": "(subject to the proviso that the charges created by the clause 3 shall at all times and for all purposes exclude the property registered under titile numbers GM745712 and GM752127 which shall be and is hereby specifically excluded from the security created by this debenture)".. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 10. Feb. 1997 Geliefert am 19. Feb. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0