COX LEE & CO. LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCOX LEE & CO. LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03229129
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von COX LEE & CO. LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich COX LEE & CO. LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von COX LEE & CO. LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2017

    Welche sind die letzten Einreichungen für COX LEE & CO. LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Change of details for Cullum Capital Ventures Limited as a person with significant control on 14. Juli 2020

    2 SeitenPSC05

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    6 SeitenLIQ13

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Tower Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road Maidstone Kent ME14 3EN zum 15 Canada Square London E14 5GL am 18. Juli 2019

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 20. Juni 2019

    LRESSP

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. Juni 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Dean Clarke als Sekretär am 11. Dez. 2018

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Geoffrey Costerton Gouriet als Sekretär am 11. Dez. 2018

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    3 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Jacqueline Anne Gregory als Sekretär am 03. Aug. 2018

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mr Geoffrey Costerton Gouriet als Sekretär am 03. Aug. 2018

    2 SeitenAP03

    Erfüllung der Belastung 032291290006 vollständig

    1 SeitenMR04

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. Juni 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Mr Antonios Erotocritou als Direktor am 02. März 2018

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Mark Stephen Mugge als Geschäftsführer am 02. März 2018

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    3 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. Juni 2017 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Ernennung von Mr David Christopher Ross als Direktor am 20. Dez. 2016

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mrs Jacqueline Anne Gregory als Sekretär am 20. Dez. 2016

    2 SeitenAP03

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    3 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 24. Juli 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Jennifer Owens als Sekretär am 01. März 2016

    1 SeitenTM02

    Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Stephen Mugge am 25. Nov. 2015

    2 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von COX LEE & CO. LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CLARKE, Dean
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Sekretär
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    253940450001
    EROTOCRITOU, Antonios
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    United KingdomCypriot167795710001
    ROSS, David Christopher
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    United KingdomIrish222326970001
    CLARK, Samuel Thomas Budgen
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Sekretär
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    British117669700002
    GOURIET, Geoffrey Costerton
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    Sekretär
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    249087540001
    GREGORY, Jacqueline Anne
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    Sekretär
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    221976280001
    OWENS, Jennifer
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Sekretär
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    183324210001
    SMITH, Janet Mary
    15 Tower View Road
    Great Wyrley
    WS6 6HE Walsall
    West Midlands
    Sekretär
    15 Tower View Road
    Great Wyrley
    WS6 6HE Walsall
    West Midlands
    British41628820001
    C & M REGISTRARS LIMITED
    PO BOX 55
    7 Spa Road
    SE16 3QP London
    Bevollmächtigter Sekretär
    PO BOX 55
    7 Spa Road
    SE16 3QP London
    900007630001
    BARR, Graham Maxwell
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Geschäftsführer
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    United KingdomBritish125097020001
    BROWN, Roger Michael
    Staceys Street
    ME14 1ST Maidstone
    2 County Gate
    Kent
    Geschäftsführer
    Staceys Street
    ME14 1ST Maidstone
    2 County Gate
    Kent
    EnglandBritish134140540001
    BRUCE, David James
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Geschäftsführer
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    United KingdomBritish171398800001
    CLARK, Samuel Thomas Budgen
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Geschäftsführer
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    EnglandBritish149939610001
    COX, David John
    52 Park View Road
    B74 4PT Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    52 Park View Road
    B74 4PT Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritish66772550002
    COX, Trevor John
    Autumn Cottage
    Brook Lane Brocton
    ST17 0TZ Stafford
    Geschäftsführer
    Autumn Cottage
    Brook Lane Brocton
    ST17 0TZ Stafford
    Gb-EngBritish41628790002
    EGAN, Scott
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish170703910001
    HODGES, Mark Steven
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Geschäftsführer
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    United KingdomBritish58444370003
    JOHNSON, Timothy David
    The Green
    Westerham
    TN16 1AS Kent
    Nursery Cottage 3a
    Geschäftsführer
    The Green
    Westerham
    TN16 1AS Kent
    Nursery Cottage 3a
    EnglandBritish129538180001
    LEE, Bernard Harold
    New Lodge New Road
    Swindon
    DY3 4PP Dudley
    West Midlands
    Geschäftsführer
    New Lodge New Road
    Swindon
    DY3 4PP Dudley
    West Midlands
    United KingdomBritish10050510001
    LYONS, Alastair David
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    Geschäftsführer
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    EnglandBritish193697520001
    MUGGE, Mark Stephen
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    Geschäftsführer
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    EnglandBritish162920630005
    OLDHAM, Peter
    237 Whetstone Lane
    Aldridge
    WS9 0HH Walsall
    West Midlands
    Geschäftsführer
    237 Whetstone Lane
    Aldridge
    WS9 0HH Walsall
    West Midlands
    British14875400001
    PARK, Bryan
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish113694470002
    REA, Michael Peter
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Geschäftsführer
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    EnglandBritish147194830001
    ROBINSON, Peter James
    36 Old Eaton Road
    WS15 2HA Rugeley
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    36 Old Eaton Road
    WS15 2HA Rugeley
    Staffordshire
    British41628840001
    SMITH, Janet Mary
    15 Tower View Road
    Great Wyrley
    WS6 6HE Walsall
    West Midlands
    Geschäftsführer
    15 Tower View Road
    Great Wyrley
    WS6 6HE Walsall
    West Midlands
    British41628820001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei COX LEE & CO. LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Cullum Capital Ventures Limited
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformCompany Limited By Shares
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortCompanies House Cardiff
    Registrierungsnummer05587424
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat COX LEE & CO. LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 02. Apr. 2015
    Geliefert am 22. Apr. 2015
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Bank of New York Mellon, London Branch
    Transaktionen
    • 22. Apr. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 05. Juli 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 10. Mai 2013
    Geliefert am 21. Mai 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Pursuant to the charge:. The company charged by way of first fixed charge all its intellectual property (although no further details are specified in the charge for intellectual property owned by this company). For further detail, see clause 3.1(b)(vii) of the charge.. The company charged by way of first legal mortgage all its real property (although no further details are specified in the charge for real property owned by this company). For further detail, see clause 3.1(a) of the charge.. Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Mai 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 29. Apr. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Security accession deed
    Erstellt am 27. Juni 2012
    Geliefert am 07. Juli 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company or any other debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 07. Juli 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 23. Sept. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 27. Juni 2012
    Geliefert am 06. Juli 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company or any other debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Agent and Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The "Security Agent")
    Transaktionen
    • 06. Juli 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 23. Juli 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 14. Sept. 2010
    Geliefert am 18. Sept. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargors to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 18. Sept. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 06. Juli 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of accession
    Erstellt am 24. Juni 2008
    Geliefert am 09. Juli 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargors to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 09. Juli 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juli 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Hat COX LEE & CO. LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    20. Juni 2019Beginn der Liquidation
    28. Juli 2020Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Nicholas James Timpson
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praktiker
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praktiker
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0