COX LEE & CO. LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | COX LEE & CO. LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03229129 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von COX LEE & CO. LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich COX LEE & CO. LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 15 Canada Square E14 5GL London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von COX LEE & CO. LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für COX LEE & CO. LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Change of details for Cullum Capital Ventures Limited as a person with significant control on 14. Juli 2020 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 6 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Tower Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road Maidstone Kent ME14 3EN zum 15 Canada Square London E14 5GL am 18. Juli 2019 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Juni 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Dean Clarke als Sekretär am 11. Dez. 2018 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Geoffrey Costerton Gouriet als Sekretär am 11. Dez. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jacqueline Anne Gregory als Sekretär am 03. Aug. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Geoffrey Costerton Gouriet als Sekretär am 03. Aug. 2018 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 032291290006 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Juni 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Antonios Erotocritou als Direktor am 02. März 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Stephen Mugge als Geschäftsführer am 02. März 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Juni 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Christopher Ross als Direktor am 20. Dez. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Jacqueline Anne Gregory als Sekretär am 20. Dez. 2016 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Juli 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jennifer Owens als Sekretär am 01. März 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Stephen Mugge am 25. Nov. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von COX LEE & CO. LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLARKE, Dean | Sekretär | Canada Square E14 5GL London 15 | 253940450001 | |||||||
| EROTOCRITOU, Antonios | Geschäftsführer | Canada Square E14 5GL London 15 | United Kingdom | Cypriot | 167795710001 | |||||
| ROSS, David Christopher | Geschäftsführer | Canada Square E14 5GL London 15 | United Kingdom | Irish | 222326970001 | |||||
| CLARK, Samuel Thomas Budgen | Sekretär | Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent England | British | 117669700002 | ||||||
| GOURIET, Geoffrey Costerton | Sekretär | Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent | 249087540001 | |||||||
| GREGORY, Jacqueline Anne | Sekretär | Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent | 221976280001 | |||||||
| OWENS, Jennifer | Sekretär | Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent England | 183324210001 | |||||||
| SMITH, Janet Mary | Sekretär | 15 Tower View Road Great Wyrley WS6 6HE Walsall West Midlands | British | 41628820001 | ||||||
| C & M REGISTRARS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | PO BOX 55 7 Spa Road SE16 3QP London | 900007630001 | |||||||
| BARR, Graham Maxwell | Geschäftsführer | Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent England | United Kingdom | British | 125097020001 | |||||
| BROWN, Roger Michael | Geschäftsführer | Staceys Street ME14 1ST Maidstone 2 County Gate Kent | England | British | 134140540001 | |||||
| BRUCE, David James | Geschäftsführer | Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent England | United Kingdom | British | 171398800001 | |||||
| CLARK, Samuel Thomas Budgen | Geschäftsführer | Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent England | England | British | 149939610001 | |||||
| COX, David John | Geschäftsführer | 52 Park View Road B74 4PT Sutton Coldfield West Midlands | United Kingdom | British | 66772550002 | |||||
| COX, Trevor John | Geschäftsführer | Autumn Cottage Brook Lane Brocton ST17 0TZ Stafford | Gb-Eng | British | 41628790002 | |||||
| EGAN, Scott | Geschäftsführer | Gate House Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent United Kingdom | England | British | 170703910001 | |||||
| HODGES, Mark Steven | Geschäftsführer | Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent England | United Kingdom | British | 58444370003 | |||||
| JOHNSON, Timothy David | Geschäftsführer | The Green Westerham TN16 1AS Kent Nursery Cottage 3a | England | British | 129538180001 | |||||
| LEE, Bernard Harold | Geschäftsführer | New Lodge New Road Swindon DY3 4PP Dudley West Midlands | United Kingdom | British | 10050510001 | |||||
| LYONS, Alastair David | Geschäftsführer | Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent | England | British | 193697520001 | |||||
| MUGGE, Mark Stephen | Geschäftsführer | Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent | England | British | 162920630005 | |||||
| OLDHAM, Peter | Geschäftsführer | 237 Whetstone Lane Aldridge WS9 0HH Walsall West Midlands | British | 14875400001 | ||||||
| PARK, Bryan | Geschäftsführer | Gate House Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent United Kingdom | England | British | 113694470002 | |||||
| REA, Michael Peter | Geschäftsführer | Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent England | England | British | 147194830001 | |||||
| ROBINSON, Peter James | Geschäftsführer | 36 Old Eaton Road WS15 2HA Rugeley Staffordshire | British | 41628840001 | ||||||
| SMITH, Janet Mary | Geschäftsführer | 15 Tower View Road Great Wyrley WS6 6HE Walsall West Midlands | British | 41628820001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei COX LEE & CO. LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cullum Capital Ventures Limited | 06. Apr. 2016 | Minster Court Mincing Lane EC3R 7PD London 2 United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat COX LEE & CO. LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 02. Apr. 2015 Geliefert am 22. Apr. 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 10. Mai 2013 Geliefert am 21. Mai 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Pursuant to the charge:. The company charged by way of first fixed charge all its intellectual property (although no further details are specified in the charge for intellectual property owned by this company). For further detail, see clause 3.1(b)(vii) of the charge.. The company charged by way of first legal mortgage all its real property (although no further details are specified in the charge for real property owned by this company). For further detail, see clause 3.1(a) of the charge.. Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security accession deed | Erstellt am 27. Juni 2012 Geliefert am 07. Juli 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company or any other debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. Juni 2012 Geliefert am 06. Juli 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company or any other debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Sept. 2010 Geliefert am 18. Sept. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargors to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession | Erstellt am 24. Juni 2008 Geliefert am 09. Juli 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargors to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat COX LEE & CO. LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0