TOTTENHAM SOCCER CENTRE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | TOTTENHAM SOCCER CENTRE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03233465 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TOTTENHAM SOCCER CENTRE LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich TOTTENHAM SOCCER CENTRE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 172 Tottenham Court Road 2nd Floor W1T 7NS London England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TOTTENHAM SOCCER CENTRE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| TEESSIDE SOCCER CENTRE LTD | 02. Aug. 1996 | 02. Aug. 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TOTTENHAM SOCCER CENTRE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TOTTENHAM SOCCER CENTRE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Nov. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2022 | 3 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Dez. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2021 | 3 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Dez. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2020 | 3 Seiten | AA | ||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Juli 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Juli 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2019 | 2 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Juli 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2018 | 2 Seiten | AA | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Floor 11, North Wing, York House Empire Way Wembley HA9 0PA England zum 172 Tottenham Court Road 2nd Floor London W1T 7NS am 27. Jan. 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||
Beendigung der Bestellung von Stuart Scott Penman als Geschäftsführer am 15. Okt. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr Michael Anthony Cazel Evans als Direktor am 15. Okt. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Aug. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Andrew William Richard Hill als Geschäftsführer am 27. März 2018 | 2 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Rupert George Campbell als Geschäftsführer am 21. Mai 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
legacy | Seiten | ANNOTATION | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2017 | 2 Seiten | AA | ||
Ernennung von Mr Stuart Scott Penman als Direktor am 19. März 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von TOTTENHAM SOCCER CENTRE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVANS, Michael Anthony | Geschäftsführer | Tottenham Court Road 2nd Floor W1T 7NS London 172 England | United Kingdom | British | 133987920001 | |||||
| BECKWITH, Sheena Marion | Sekretär | Powerleague Mill Hill Pursley Road NW7 2BB London | British | 77381700002 | ||||||
| HALL, Jeremy Clive | Sekretär | 42 Newacres Newburgh WN8 7TU Wigan Lancashire | British | 35444860001 | ||||||
| ORMEROD, Warren David | Sekretär | 34 Old Oak Close WS9 8SE Aldridge West Midlands | British | 49052640001 | ||||||
| FIRST SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 72 New Bond Street W1S 1RR London | 900000780001 | |||||||
| BECKWITH, Sheena Marion | Geschäftsführer | Powerleague Mill Hill Pursley Road NW7 2BB London | Scotland | British | 77381700002 | |||||
| BUCHANAN, William Arthur Neil | Geschäftsführer | 3 Westerton Court Clarkston G76 8NG Glasgow Lanarkshire | United Kingdom | British | 67066450003 | |||||
| CAMPBELL, Rupert George | Geschäftsführer | Blackhall Street PA1 1TD Paisley Anchor Grounds Scotland | England | British | 196295940001 | |||||
| HALL, Jeremy Clive | Geschäftsführer | 42 Newacres Newburgh WN8 7TU Wigan Lancashire | England | British | 35444860001 | |||||
| HILL, Andrew William Richard | Geschäftsführer | Empire Way HA9 0PA Wembley Floor 11, North Wing, York House England | England | British | 56374680009 | |||||
| MOORE, Adrian Richard | Geschäftsführer | 1 Chaucer Close SL4 3ER Windsor Berkshire | Uk | British | 96121170001 | |||||
| ORMEROD, Warren David | Geschäftsführer | 34 Old Oak Close WS9 8SE Aldridge West Midlands | British | 49052640001 | ||||||
| PENMAN, Stuart Scott | Geschäftsführer | Empire Way HA9 0PA Wembley Floor 11, North Wing, York House England | Scotland | British | 244357970001 | |||||
| SELLERS, Philip Edward | Geschäftsführer | Yarrimba 31 Howards Thicket SL9 7NT Gerrards Cross Buckinghamshire | United Kingdom | British | 10598350001 | |||||
| TAYLOR, Alan Lewis | Geschäftsführer | 6 Heathside Close Moor Park HA6 2EQ Northwood Middlesex | British | 4947700001 | ||||||
| TRACEY, Sean Paul | Geschäftsführer | Powerleague Mill Hill Pursley Road NW7 2BB London | Scotland | British | 105080540001 | |||||
| FIRST DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 72 New Bond Street W1S 1RR London | 900000770001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei TOTTENHAM SOCCER CENTRE LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powerleague Fives Ltd | 06. Apr. 2016 | Bedford Row WC1R 4JS London 20-22 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat TOTTENHAM SOCCER CENTRE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 02. Dez. 1999 Geliefert am 16. Dez. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee acting for itself and as trustee on behalf of the investors (as defined) under the investment agreement of even date pursuant to the deed of guarantee of even date | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 02. Dez. 1999 Geliefert am 11. Dez. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 02. Aug. 1999 Geliefert am 12. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 15. Apr. 1999 Geliefert am 17. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The l/h property k/a fred knight sports centre willoughby lane tottenham. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. Apr. 1998 Geliefert am 02. Mai 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben Exluding the legally charged property and including stocks and shares acquired pursuant to scrip dividends and other than royalties and other sums payable in ESPCT6 of intellectual property rights. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0