TCC1 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | TCC1 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03235153 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TCC1 LIMITED?
- Tätigkeit anderer Holdinggesellschaften n.n.a. (64209) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich TCC1 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Church Bridge House Henry Street BB5 4EE Accrington United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TCC1 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| THE COTSWOLD COMPANY LIMITED | 07. Aug. 1996 | 07. Aug. 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TCC1 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 26. März 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TCC1 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt | 1 Seiten | DISS16(SOAS) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Cessation of Frasers Group Plc as a person with significant control on 24. Feb. 2022 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Notification of Studio Retail Group Plc as a person with significant control on 24. Feb. 2022 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Cessation of Studio Retail Group Plc as a person with significant control on 24. Feb. 2022 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Notification of Frasers Group Plc as a person with significant control on 24. Feb. 2022 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Michael Arnaouti als Direktor am 17. Dez. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Michael Arnaouti als Sekretär am 17. Dez. 2021 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Ashcroft als Sekretär am 16. Dez. 2021 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Ashcroft als Geschäftsführer am 16. Dez. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 26. März 2021 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Aug. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Philip Binns Maudsley als Geschäftsführer am 26. März 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Change of details for Findel Plc as a person with significant control on 26. Juli 2019 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 27. März 2020 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Aug. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 23 Seiten | MA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 29. März 2019 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Aug. 2019 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. März 2018 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Aug. 2018 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mark Ashcroft am 02. Apr. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TCC1 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARNAOUTI, Michael | Sekretär | Henry Street BB5 4EE Accrington Church Bridge House United Kingdom | 290653450001 | |||||||
| ARNAOUTI, Michael | Geschäftsführer | Henry Street BB5 4EE Accrington Church Bridge House United Kingdom | England | British | 539040004 | |||||
| CALDWELL, Stuart Murdoch | Geschäftsführer | Henry Street BB5 4EE Accrington Church Bridge House United Kingdom | United Kingdom | British | 229000880001 | |||||
| ASHCROFT, Mark | Sekretär | Gregory Street SK14 4TH Hyde 2 Cheshire United Kingdom | 165369100001 | |||||||
| BOLTON, Ivan Joseph, Dr | Sekretär | Gregory Street SK14 4TH Hyde 2 Cheshire England | British | 14333000007 | ||||||
| SHAPIN, Andrew | Sekretär | 99 Fairacres Road OX4 1TQ Oxford Oxfordshire | American | 51716960003 | ||||||
| SHAPIN, Andrew | Sekretär | 99 Fairacres Road OX4 1TQ Oxford Oxfordshire | American | 51716960003 | ||||||
| VAUGHAN, Margaret Sheila | Sekretär | 7 Ryeworth Road Charlton Kings GL52 6LG Cheltenham Gloucestershire | British | 49098670001 | ||||||
| WALSH HILL, Steven Philip | Sekretär | 37 Woodford Mill Mill Street OX28 6DE Witney Oxfordshire | British | 97767780001 | ||||||
| HALLMARK SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 120 East Road N1 6AA London | 900004100001 | |||||||
| ASHCROFT, Mark | Geschäftsführer | Henry Street BB5 4EE Accrington Church Bridge House United Kingdom | United Kingdom | British | 113691350001 | |||||
| BOLTON, Ivan Joseph, Dr | Geschäftsführer | Gregory Street SK14 4TH Hyde 2 Cheshire England | United Kingdom | British | 14333000007 | |||||
| CHAPMAN, Keith | Geschäftsführer | Flasby BD23 3PX Skipton Flasby Hall North Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 143093130001 | |||||
| DUTTON, David Brian | Geschäftsführer | Gregory Street SK14 4TH Hyde 2 Cheshire England | United Kingdom | British | 153319990001 | |||||
| DUTTON, David Brian | Geschäftsführer | Marsden Old Vicarage 20 Station Road HD7 6DG Marsden West Yorkshire | United Kingdom | British | 153319990001 | |||||
| GOMMES, John Claude Yves Patrick | Geschäftsführer | 21 Eaton Place SW1X 8BP London | British | 7057360003 | ||||||
| HINTON, Christopher David | Geschäftsführer | 31 Elm Road Didsbury M20 6XD Manchester | England | British | 68474940001 | |||||
| JOLLY, Patrick Edmund | Geschäftsführer | Hill Top Farm Hill Top Lane Skipton Road, BB18 6JN Earby Lancashire | England | British | 75327660001 | |||||
| KEVE, Robert Hamilton | Geschäftsführer | Flat 1 Upper Kingswell 58-62 Heath Street NW3 1EN London | British | 64293640001 | ||||||
| KLEIN, Robin Matthew | Geschäftsführer | 5 Upper Terrace Hampstead NW3 6RH London | England | British | 56477530001 | |||||
| KOWALSKI, Timothy John | Geschäftsführer | Gregory Street SK14 4TH Hyde 2 Cheshire England | Uk | British | 153335190003 | |||||
| MAUDSLEY, Philip Binns | Geschäftsführer | Henry Street BB5 4EE Accrington Church Bridge House United Kingdom | United Kingdom | British | 15967010001 | |||||
| PEIN, Tanya Deborah | Geschäftsführer | 83 Balmoral Road NW2 5BH London | England | United Kingdom | 41913190002 | |||||
| SAYERS, David Michael | Geschäftsführer | 9 Little Tangley Kings Road Wonersh Common GU5 0FW Guildford Surrey | United Kingdom | British | 89664290002 | |||||
| SHAPIN, Andrew | Geschäftsführer | 99 Fairacres Road OX4 1TQ Oxford Oxfordshire | American | 51716960003 | ||||||
| SIDDLE, Roger William John | Geschäftsführer | Gregory Street SK14 4TH Hyde 2 Cheshire England | England | British | 46903210001 | |||||
| VAUGHAN, Ian Paul | Geschäftsführer | 3 Nethercot Farm Drive Bourton On The Water GL54 2PQ Cheltenham Gloucestershire | British | 49098630004 | ||||||
| WALSH HILL, Steven Philip | Geschäftsführer | 37 Woodford Mill Mill Street OX28 6DE Witney Oxfordshire | British | 97767780001 | ||||||
| HALLMARK REGISTRARS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 120 East Road N1 6AA London | 900004090001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei TCC1 LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frasers Group Plc | 24. Feb. 2022 | Brook Park East, NG20 8RY Shirebrook, Unit A, United Kingdom | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Studio Retail Group Plc | 24. Feb. 2022 | Henry Street BB5 4EE Accrington Church Bridge House United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Studio Retail Group Plc | 06. Apr. 2016 | Henry Street BB5 4EE Accrington Church Bridge House United Kingdom | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat TCC1 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 21. Jan. 2015 Geliefert am 30. Jan. 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A security agreement | Erstellt am 24. Juli 2009 Geliefert am 04. Aug. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First fixed charge land investments plant and machinery credit balances insurances other contracts intellectual property its goodwill its uncalled capital floating charge all of its assets see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Juni 2004 Geliefert am 22. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Erstellt am 21. Dez. 1998 Geliefert am 06. Jan. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Account number 30770957. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Depsoit agreement to secure own liabilities | Erstellt am 05. März 1998 Geliefert am 14. März 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Monies in deposit account number 7125598. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deposit agreement to secure own liabilities | Erstellt am 21. Nov. 1997 Geliefert am 28. Nov. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All such rights to the repayment of the deposit as the company then had under the terms upon which the deposit was made and the provisions contained in the agreement. Account number 7480576. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deposit agreement to secure own liabilities | Erstellt am 07. Juli 1997 Geliefert am 17. Juli 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the company's right title and interest in and to the acount with the bank AT5 its montpellier branch in the name of lloyds bank PLC re;-the cotswold company limited denominted in sterling designated premier interest account now numbered 702878 and any account replacing thereto. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat TCC1 LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA) |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0