EPOS COMPUTING SERVICES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | EPOS COMPUTING SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03241146 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von EPOS COMPUTING SERVICES LIMITED?
- (7260) /
Wo befindet sich EPOS COMPUTING SERVICES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Torex Houghton Hall Park Houghton Regis LU5 5YG Dunstable Bedfordshire United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EPOS COMPUTING SERVICES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für EPOS COMPUTING SERVICES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2010 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Aug. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2009 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kirk Isaacson als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kirk Isaacson als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2008 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 88(2) | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2007 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
Verschiedenes Section 394 | 1 Seiten | MISC | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von EPOS COMPUTING SERVICES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRADDEN, Amanda Jane | Geschäftsführer | Flat 2 10a Market Mews W1J 7BZ London | England | British | 77425910003 | |||||
| AUSTEN, Samantha Jane | Sekretär | Vista Quebrada, Portal 1, 2a Urb. Nueva Torre Quebrada Benalmadena Costa Malaga 29630 Spain | British | 73845060001 | ||||||
| FITTON, John Anthony | Sekretär | 6 Gig Lane Heath & Reach LU7 0BQ Leighton Buzzard Bedfordshire | British | 49355380001 | ||||||
| HORN, Nigel David | Sekretär | Featherbow House Ratley OX15 6DS Banbury Oxfordshire | British | 109926660001 | ||||||
| ISAACSON, Kirk Jeffrey, Mr. | Sekretär | 1110 Fox Glen Drive St Charles Illinois 60174 Usa | Other | 123425810001 | ||||||
| JOHNSON, Robin Simon | Sekretär | 25 Thirlmere Road Muswell Hill N10 2DL London | British | 11498320001 | ||||||
| LEEK, Marcus | Sekretär | 7 Gloster Drive CV8 2TU Kenilworth Warwickshire | British | 115960470001 | ||||||
| TWINE, Jane Eleanor | Sekretär | Claremont Ivy Lane MK17 9AH Great Brickhill Buckinghamshire | British | 80950370001 | ||||||
| PARAMOUNT COMPANY SEARCHES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 229 Nether Street N3 1NT London | 900001530001 | |||||||
| COOKSLEY, Graeme | Geschäftsführer | 19 Charmer Fussweg Zug 6300 Switzerland | New Zealander | 122786180001 | ||||||
| EARHART, Stephen | Geschäftsführer | Brittens Lane Salford MK17 8BE Milton Keynes 1 Buckinghamshire United Kingdom | United States | 133153450001 | ||||||
| FORD, Christopher Mark | Geschäftsführer | 69 Sillswood MK46 5PN Olney Buckinghamshire | England | British | 116469010001 | |||||
| FRIERY, Nigel Robert | Geschäftsführer | Flat 6 Captains Mill West End OX28 1QL Witney Oxfordshire | British | 97728060001 | ||||||
| GREENOUGH, Michael | Geschäftsführer | 711 Pintail Court Granbury Texas 76049 Usa | Canadian | 123427350001 | ||||||
| HORN, Nigel David | Geschäftsführer | Featherbow House Ratley OX15 6DS Banbury Oxfordshire | British | 109926660001 | ||||||
| HUGHES, David Brian | Geschäftsführer | 10 Metcalfe Grove Blakelands MK14 5JY Milton Keynes | British | 81034920001 | ||||||
| ISAACSON, Kirk Jeffrey, Mr. | Geschäftsführer | 1110 Fox Glen Drive St Charles Illinois 60174 Usa | Usa | Other | 123425810001 | |||||
| LEEK, Marcus | Geschäftsführer | 7 Gloster Drive CV8 2TU Kenilworth Warwickshire | British | 115960470001 | ||||||
| MITCHELL, Robert Neil Whyte | Geschäftsführer | 50 Leckford Road Jericho OX2 6HY Oxford Oxfordshire | British | 116745740001 | ||||||
| PEARMAN, Mark Chalice | Geschäftsführer | The Old Rectory Honiley CV8 1NP Kenilworth Warwickshire | United Kingdom | British | 57516220003 | |||||
| PRINCE, Peter | Geschäftsführer | 8 The Chase SL5 7UJ Ascot Berkshire | United States Of America | British | 125228870001 | |||||
| TAYLOR, Keith Wilhall | Geschäftsführer | Dove Cottage Sly Corner Lee Common HP16 9LD Great Missenden Bucks | England | British | 119095470001 | |||||
| PARAMOUNT PROPERTIES (UK) LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 229 Nether Street N3 1NT London | 900001520001 |
Hat EPOS COMPUTING SERVICES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 23. Aug. 2002 Geliefert am 10. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Apr. 1998 Geliefert am 06. Mai 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0