ROWDEN REALISATIONS 3 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ROWDEN REALISATIONS 3 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03242996 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ROWDEN REALISATIONS 3 LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich ROWDEN REALISATIONS 3 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Hydrex House, Serbert Way Portishead BS20 7GD Bristol |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ROWDEN REALISATIONS 3 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| HYDREX GROUP LIMITED | 14. März 1997 | 14. März 1997 |
| FILBUK 416 LIMITED | 28. Aug. 1996 | 28. Aug. 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ROWDEN REALISATIONS 3 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ROWDEN REALISATIONS 3 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Aug. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Carl Mark D'ammassa am 28. Aug. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Alan James Jordan am 28. Aug. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2010 bis 30. Juni 2011 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Aug. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Alan James Jordan als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Wood als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Wood als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
legacy | 35 Seiten | MG01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Carl Mark D'ammassa als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Simcox als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Aug. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288c | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 12 Seiten | MA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ROWDEN REALISATIONS 3 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D'AMMASSA, Carl Mark | Geschäftsführer | Hydrex House, Serbert Way Portishead BS20 7GD Bristol | United Kingdom | British | 147037660007 | |||||
| JORDAN, Alan James | Geschäftsführer | Hydrex House, Serbert Way Portishead BS20 7GD Bristol | England | Irish | 150320720001 | |||||
| BOYD, Steven Clive | Sekretär | Martins Nest West Kington SN14 7JE Chippenham Wiltshire | British | 70337230001 | ||||||
| DAVIES, Irona Wendy | Sekretär | Woodbridge Beachley Road Tutshill NP6 7DL Chepstow Gwent | British | 2207330001 | ||||||
| SEYMOUR, Paul Richard | Sekretär | 14 Campanula Drive Meadow Brook NP10 9JG Rogerstone Newport | British | 75293670002 | ||||||
| WOOD, Andrew Simon | Sekretär | Shaplands Stoke Bishop BS9 1AY Bristol 5 Avon United Kingdom | British | 33951380003 | ||||||
| FILBUK (SECRETARIES) LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Fitzalan House Fitzalan Road CF2 1XZ Cardiff South Glamorgan | 900004990001 | |||||||
| BOYD, Steven Clive | Geschäftsführer | Martins Nest West Kington SN14 7JE Chippenham Wiltshire | British | 70337230001 | ||||||
| DAVIES, Brian Thomas | Geschäftsführer | Woodbridge Rockvilla Lane Beachley Road NP6 2DR Chepstow Gwent | United Kingdom | British | 39854170001 | |||||
| GADOROS, Bela | Geschäftsführer | 63 Gaston Bridge Road TW17 8HF Shepperton Middlesex | British | 20061270001 | ||||||
| GREENALL, Andrew Mclaren | Geschäftsführer | 4 Greenway SG6 3UG Letchworth Garden City Hertfordshire | U.K | British | 108417750003 | |||||
| ROBY, Stephen Alec | Geschäftsführer | 7 Brook Lane Catcott TA7 9HG Bridgwater Greenacres Somerset United Kingdom | England | British | 64440220002 | |||||
| ROGERS, Douglas Ernest | Geschäftsführer | Kiln House 5 Kiln Lane Shirley B90 1SF Solihull West Midlands | British | 32445690008 | ||||||
| SIMCOX, Andrew James | Geschäftsführer | Ashley Drive South Ashley Heath BH24 2JP Ringwood 53 Hampshire United Kingdom | England | British | 41023640002 | |||||
| WOOD, Andrew Simon | Geschäftsführer | Shaplands Stoke Bishop BS9 1AY Bristol 5 Avon United Kingdom | United Kingdom | British | 33951380003 | |||||
| FILBUK NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Fitzalan House Fitzalan Road CF2 1XZ Cardiff South Glamorgan | 900004980001 |
Hat ROWDEN REALISATIONS 3 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 24. Juni 2010 Geliefert am 08. Juli 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. März 2006 Geliefert am 23. März 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 03. März 2005 Geliefert am 17. März 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Second supplemental agreement in respect of debenture dated 12 march 2002 | Erstellt am 06. Mai 2003 Geliefert am 09. Mai 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the hydrex limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The words "and as further amended by way of supplemental agreement dated 6 may 2003 shall be inserted at the end of the definition of "intercreditor deed". See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental agreement in respect of debenture dated 12 march 2002 | Erstellt am 21. Feb. 2003 Geliefert am 13. März 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The following amendments shall be made to the debenture the words "as amended by way of a side letter produced by osborne clarke dated 20 february 2003" shall be inserted at the end of the definition of "intercreditor deed" save as amended above the terms of the debenture shall remain in full force and effect. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 12. März 2002 Geliefert am 20. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattels mortgage | Erstellt am 12. März 2002 Geliefert am 20. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to becomne due from the company, hydrex limited and any of their subsidiaries to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the following assets and rights :- the equipment, the contracts, conditions warranties and agreements, documents, all insurances and any monies payable. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 12. März 2002 Geliefert am 20. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 25. Feb. 1997 Geliefert am 11. März 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of the company formerly known as filbuk 416 limited or any of the borrowers to the chargee and/or pursuant to any of the financing documents (the secured obligations) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 25. Feb. 1997 Geliefert am 17. März 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0