BRITISH CERAMIC TILE LIMITED
Überblick
Unternehmensname | BRITISH CERAMIC TILE LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03244910 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BRITISH CERAMIC TILE LIMITED?
- Herstellung von Keramikfliesen und -platten (23310) / Verarbeitendes Gewerbe
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich BRITISH CERAMIC TILE LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 2nd Floor 110 Cannon Street EC4N 6EU London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BRITISH CERAMIC TILE LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
BCT LIMITED | 17. Apr. 1998 | 17. Apr. 1998 |
G B C T LIMITED | 02. Sept. 1996 | 02. Sept. 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BRITISH CERAMIC TILE LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BRITISH CERAMIC TILE LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 42 Seiten | AM10 | ||
Mitteilung über das automatische Ende der Verwaltung | 34 Seiten | AM20 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 17 Seiten | AM10 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 34 Seiten | AM10 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 34 Seiten | AM10 | ||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 4 Seiten | AM19 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 27 Seiten | AM10 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 31 Seiten | AM10 | ||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 4 Seiten | AM19 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 43 Seiten | AM10 | ||
Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 29. Dez. 2018 bis 31. März 2018 | 1 Seiten | AA01 | ||
Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge | 4 Seiten | AM06 | ||
Vorschlag des Verwalters | 48 Seiten | AM03 | ||
Vermögensübersicht mit Formular AM02SOA | 16 Seiten | AM02 | ||
Beendigung der Bestellung von Anthony John Taylor als Geschäftsführer am 19. Feb. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Heathfield Newton Abbot Devon TQ12 6RF zum 2nd Floor 110 Cannon Street London EC4N 6EU am 18. Feb. 2019 | 2 Seiten | AD01 | ||
Ernennung eines Verwalters | 4 Seiten | AM01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Matthew Jonathan Rhys David am 17. Jan. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||
Beendigung der Bestellung von Alexander Maculan als Geschäftsführer am 17. Jan. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 30. Dez. 2017 bis 29. Dez. 2017 | 1 Seiten | AA01 | ||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Dez. 2017 bis 30. Dez. 2017 | 1 Seiten | AA01 | ||
Beendigung der Bestellung von Shaun David Holmes als Geschäftsführer am 22. Aug. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Juli 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von BRITISH CERAMIC TILE LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID, Matthew Jonathan Rhys | Sekretär | 110 Cannon Street EC4N 6EU London 2nd Floor | 197175330001 | |||||||
DAVID, Matthew Jonathan Rhys | Geschäftsführer | 110 Cannon Street EC4N 6EU London 2nd Floor | England | British | Certified Accountant | 176243330002 | ||||
KEELING, Natalie Kaye | Geschäftsführer | 110 Cannon Street EC4N 6EU London 2nd Floor | England | British | Human Resources Director | 205720980002 | ||||
STAFFORD-DEITSCH, Andrew | Geschäftsführer | 1 Pembroke Gardens Close W8 6HR London | England | British | Company Director | 153790440001 | ||||
WEVILL, Richard Mark, Dr | Geschäftsführer | Court Wood Newton Ferrers PL8 1BW Plymouth Heron's Reach Devon United Kingdom | England | British | Non Executive Director | 120100570002 | ||||
BIRD, Michael Thomas | Sekretär | 115 Crabtree Lane AL5 5RQ Harpenden Hertfordshire | British | Accountant | 437220001 | |||||
CHRISTOPHER, Allan John | Sekretär | Briarfield 5 Kittle Green Kittle SA3 3JX Swansea West Glamorgan | British | 38193030002 | ||||||
CLARKSON, James | Sekretär | Heathfield Newton Abbot TQ12 6RF Devon | 167891010001 | |||||||
CORDES, Madeleine Ann | Sekretär | Moor View The Street, Roxwell CM1 4PA Chelmsford Essex | British | 18098540003 | ||||||
CORKETT, David Alex | Sekretär | Heathfield Newton Abbot TQ12 6RF Devon | 169925060001 | |||||||
GAZZARD, Matthew | Sekretär | 1 Pearldene Folly Gate EX20 3AQ Okehampton Devon | British | 90685060002 | ||||||
EDIS-BATES SECRETARIES LIMITED | Sekretär | The Croft Chalfont Lane WD3 5PP Chorleywood Hertfordshire | 72611540001 | |||||||
WATERLOW SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003950001 | |||||||
BANTON, David | Geschäftsführer | Heathfield Newton Abbot TQ12 6RF Devon | England | British | Manufacturing Director | 172386890002 | ||||
BECHER WICKES, James Nicholas | Geschäftsführer | 65 Pelhams Walk KT10 8QA Esher Surrey | England | British | Company Director | 110374340001 | ||||
BIRD, Michael Thomas | Geschäftsführer | 115 Crabtree Lane AL5 5RQ Harpenden Hertfordshire | United Kingdom | British | Accountant | 437220001 | ||||
CHATER, John James | Geschäftsführer | Heathfield Newton Abbot TQ12 6RF Devon | England | British | Commercial Director | 128854450001 | ||||
CHRISTOPHER, Allan John | Geschäftsf ührer | Briarfield 5 Kittle Green Kittle SA3 3JX Swansea West Glamorgan | Wales | British | Accountant | 38193030002 | ||||
CLARKSON, James Norman | Geschäftsführer | Heathfield Newton Abbot TQ12 6RF Devon | England | British | Director | 108928820001 | ||||
CORKETT, David Alex | Geschäftsführer | Heathfield Newton Abbot TQ12 6RF Devon | United Kingdom | British | Director | 103010720002 | ||||
DAVISON, Jeremy Robert | Geschäftsführer | 73 Waterside EX2 8GY Exeter Devon | British | Ch Accountant | 65096740005 | |||||
EVANS, Carl | Geschäftsführer | 7 Fountain Court Abbey Road TQ13 9AD Bovey Tracey Devon | British | Director | 84974070001 | |||||
EVITT, Timothy Strevens | Geschäftsführer | 15 Barton Close Exton EX3 0PE Exeter | British | Designer | 61756050005 | |||||
GOESS-SAURAU, Johannes | Geschäftsführer | Schlossberg 1 Neumarket A-838 Austria | Austria | Austrian | Director | 134737600002 | ||||
GOESS-SAURAU, Konrad Johann, Dr | Geschäftsführer | Temple Farm Rockley SN8 1RU Marlborough Wiltshire | United Kingdom | Austrian | Company Director | 7229970002 | ||||
HODGE, Ralph Noel | Geschäftsführer | Anstye Place Anstye RH17 5AJ Haywards Heath West Sussex | British | Director | 37679770001 | |||||
HOLMES, Shaun David | Geschäftsführer | 36-38 Cornhill EC3V 3NG London Stephens Europe England | England | British | Investment Banker | 109823620001 | ||||
LEARMOND, Peter Alexander | Geschäftsführer | Anvil Cottage Conford GU30 7QW Liphook Hampshire | British | Company Director | 35551270001 | |||||
LEEB, Alexander, Dr | Geschäftsführer | Gamshof Frohn Leiten A-8130 Austria | Austrian | Consultant | 117195010001 | |||||
MACULAN, Alexander | Geschäftsführer | Cranmore Lane Shipton Moyne GL8 8PU Tetbury Lower Cranmore England | England | Austrian | Self Employed | 225413740001 | ||||
MEIER, Dieter | Geschäftsführer | Wohllebgasse 6 Zurich Ch 8001 FOREIGN Switzerland | Swiss | Director | 64083970001 | |||||
SMITH, Stephen Michael | Geschäftsführer | Heathfield Newton Abbot TQ12 6RF Devon | England | British | Operations Director | 240446760001 | ||||
TAYLOR, Anthony John | Geschäftsführer | 110 Cannon Street EC4N 6EU London 2nd Floor | England | British | Director | 98415430002 | ||||
WALSH, Mike | Geschäftsführer | Heathfield Newton Abbot TQ12 6RF Devon | England | British | Non - Executive Director | 156674030001 | ||||
WEST, Andrew Thomas | Geschäftsführer | 4 Filkins Hall Filkins GL7 3JJ Lechdale Gloucestershire | United Kingdom | British | Financial Advisor | 79568920001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei BRITISH CERAMIC TILE LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
---|---|---|---|
Mr Warren Stephens | 06. Apr. 2016 | Little Rock 72201 Arkansas 111 Center Street United States | Nein |
Nationalität: American Staatsangehörigkeit: United States | |||
Arten der Kontrolle
|
Hat BRITISH CERAMIC TILE LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 24. Okt. 2016 Geliefert am 25. Okt. 2016 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung The freehold land known as british ceramic tile LTD, old newton road, heathfield, newton abbot TQ12 6RF (title number DN306642).. For further information please refer to the certified copy instrument. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 10. Okt. 2014 Geliefert am 21. Okt. 2014 | Ausstehend | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 09. Okt. 2013 Geliefert am 17. Okt. 2013 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung F/H heathfield newton abbot t/n DN306642. F/h land and buildings on north east side of old newton road heathfield bovey tracey t/n DN412580. Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 01. Aug. 2013 Geliefert am 09. Aug. 2013 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 30. März 2012 Geliefert am 03. Apr. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deposit agreement to secure own liabilities | Erstellt am 21. März 2012 Geliefert am 22. März 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated lloyds tsb bank PLC re british ceramic tile limited and numbered 03097251 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division in the name of the bank re the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 14. Apr. 2008 Geliefert am 23. Apr. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £35,520.25 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Rent deposit see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 03. Okt. 2007 Geliefert am 12. Okt. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H heathfield newton abbot devon t/nos DN306642 and DN412580 by way of fixed charge the goodwill and by way of assignment the insurance policy. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Chattels mortgage | Erstellt am 02. Okt. 2007 Geliefert am 05. Okt. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The mortgaged chattels being all or any part of the furniture fixtures and chattels and other equipment described in the second schedule to the chattels mortgage together with any part or parts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
All assets debenture | Erstellt am 02. Okt. 2007 Geliefert am 05. Okt. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 02. Aug. 2007 Geliefert am 04. Aug. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Heathfield newton abbot devon t/nos DN306642 and 412580 and all buildings and fixtures all monies from time to time payable under or pursuant to the insurances and by assignment all rights title and interest in all rents profits income fees adn other sums. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge supplemental to a debenture | Erstellt am 11. Dez. 2003 Geliefert am 18. Dez. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of fixed charge all securities all receivables and all other debts the benefit of all instruments guarantees charges pledges and other security by way of floating charge all its assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental charge over chattels | Erstellt am 22. Mai 2002 Geliefert am 24. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The stocks by way of floating charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental charge over chattels | Erstellt am 07. Dez. 2001 Geliefert am 17. Dez. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben With full title guarantee charged the chattels to the bank by way of first fixed charge and assigned the assigned rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental charge of patents trade marks trade names and goodwill | Erstellt am 21. Dez. 1999 Geliefert am 10. Jan. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture | |
Kurze Angaben All patents and trade marks goodwill and benefit of all licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 20. Dez. 1999 Geliefert am 29. Dez. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 20. Dez. 1999 Geliefert am 29. Dez. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and premises at heathfield, bovey tracey, teignbridge, devon t/n dn 306642. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 22. Apr. 1999 Geliefert am 28. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever whether or not the chargee was an original party to the relevant transaction | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage all f/h and l/h property including heathfield bovey tracey teignbridge devon t/no DN306642, byway of fixed charge all other land now at the date of the debenture or thereafter becoming the property of the company,all such interest in or over land or inor to the proceeds of sale of land and all licences, fixed charge all chattels attached to any land, chattels being allplant and equipment of the company now or in the future, all chattels as described in part vi of the form M395, all rental and other income and all debts and claims in connection with any lease, agreement or licence relating to land, all contracts therein held now or in the future and policies of insurance and assurance and all rights and interests therein;by way of floating charge all assets being all land and chattels of the company. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat BRITISH CERAMIC TILE LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| In Verwaltung |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0