ENERGY SUPPLIES UK LIMITED
Überblick
Unternehmensname | ENERGY SUPPLIES UK LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03245301 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ENERGY SUPPLIES UK LIMITED?
- Handel mit Elektrizität (35140) / Versorgung mit Elektrizität, Gas, Dampf und klimatisierten Luft
Wo befindet sich ENERGY SUPPLIES UK LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Severn Trent Centre St. Johns Street CV1 2LZ Coventry England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ENERGY SUPPLIES UK LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
LOWLOADER LIMITED | 03. Sept. 1996 | 03. Sept. 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ENERGY SUPPLIES UK LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2023 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ENERGY SUPPLIES UK LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2023 | 4 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Juni 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2022 | 4 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Juni 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2021 | 4 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Juni 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Mr Adam Peter Stephens als Direktor am 31. März 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von John Anthony Jackson als Geschäftsführer am 31. März 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2020 | 4 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Juni 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2019 | 4 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Juni 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2018 | 4 Seiten | AA | ||
Change of details for Dee Valley Limited as a person with significant control on 31. Okt. 2018 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Okt. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Change of details for Dee Valley Plc as a person with significant control on 01. Feb. 2018 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift Severn Trent Centre St. Johns Street Coventry CV1 2LZ verlegt | 1 Seiten | AD04 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Packsaddle Wrexham Road Rhostyllen Wrexham LL14 4EH zum Severn Trent Centre St. Johns Street Coventry CV1 2LZ am 27. Feb. 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2017 | 4 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von Mark James Dovey als Geschäftsführer am 14. Dez. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse 2 st. Johns Street Coventry CV1 2LZ verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von ENERGY SUPPLIES UK LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGLE, Gemma Louise | Sekretär | St. Johns Street CV1 2LZ Coventry 2 England | 227679200001 | |||||||
MCPHEELY, Robert Craig | Geschäftsführer | St. Johns Street CV1 2LZ Coventry 2 England | England | British | Accountant | 104273610001 | ||||
STEPHENS, Adam Peter | Geschäftsführer | 2 St John’S Street CV1 2LZ Coventry Severn Trent Centre United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 281599070001 | ||||
BAILEY, John | Sekretär | 21 The Croft Kirby Hill YO51 9YA Boroughbridge North Yorkshire | British | Company Director | 58501700001 | |||||
BICKERTON, Andrew Alan | Sekretär | Packsaddle Wrexham Road Rhostyllen LL14 4EH Wrexham | 187483530001 | |||||||
BRAGG, Tracy Elaine | Sekretär | Packsaddle Wrexham Road Rhostyllen LL14 4EH Wrexham | 222113920001 | |||||||
GUEST, David James | Sekretär | 3 Harvey Avenue CW5 6LE Nantwich Cheshire | British | Company Director | 6573790001 | |||||
MILNOR, Lisa Rachael | Sekretär | Goal Farm Hellifield BD23 4JR Skipton North Yorkshire | British | Financial Director | 53306760001 | |||||
STANFORD, Thomas Martin | Sekretär | 127 Arthurs Avenue HG2 0EH Harrogate North Yorkshire | British | 40126480003 | ||||||
STRAHAN, David Edward | Sekretär | Packsaddle Wrexham Road Rhostyllen LL14 4EH Wrexham | 174729470001 | |||||||
YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000880001 | |||||||
BAILEY, John | Geschäftsführer | 21 The Croft Kirby Hill YO51 9YA Boroughbridge North Yorkshire | British | Company Director | 58501700001 | |||||
BELLIS, Brynley | Geschäftsführer | Erw Fran Llandyrnog LL16 4LY Denbigh | British | Engineer | 33428580002 | |||||
BICKERTON, Andrew Alan | Geschäftsführer | Packsaddle Wrexham Road Rhostyllen LL14 4EH Wrexham | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 187480330001 | ||||
CARLSON, Carl Sidney | Geschäftsführer | Becks Barn School Road Hanbury WR9 7EA Droitwich Worcestershire | United Kingdom | British | Company Director | 36366460002 | ||||
DOVEY, Mark James, Mr. | Geschäftsführer | St. Johns Street CV1 2LZ Coventry 2 England | England | British | Company Director | 166254070001 | ||||
GUEST, David James | Geschäftsführer | 3 Harvey Avenue CW5 6LE Nantwich Cheshire | England | British | Company Director | 6573790001 | ||||
HOLLADAY, Norman Charles | Geschäftsführer | Packsaddle Wrexham Road Rhostyllen LL14 4EH Wrexham | United Kingdom | British | Engineer | 136424810001 | ||||
HOWARTH, Stuart Belton, Dr | Geschäftsführer | Chapel House Threapwood SY14 7AX Malpas Cheshire | United Kingdom | British | Ma | 37875800001 | ||||
ILLINGWORTH, David Stephen | Geschäftsführer | Woodside Greystone Plain Lane Hampsthwaite HG3 2HT Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 13110120001 | ||||
ILLINGWORTH, Howard Seth | Geschäftsführer | Ashcroft Rowden Lane Hampsthwaite HG3 2HR Harrogate North Yorkshire | England | British | Company Director | 13110110001 | ||||
ILLINGWORTH, Mark Richard | Geschäftsführer | Hampsthwaite Head Hampsthwaite HG3 2HT Harrogate North Yorkshire | British | Company Director | 13110130002 | |||||
JACKSON, John Anthony | Geschäftsführer | St. Johns Street CV1 2LZ Coventry 2 England | United Kingdom | Irish | Company Director | 190509470001 | ||||
JENKINS, Brian Stuart | Geschäftsführer | Beeston House CW6 9ST Tarporley Cheshire | British | Chartered Accountant | 14981320001 | |||||
MILNOR, Lisa Rachael | Geschäftsführer | Goal Farm Hellifield BD23 4JR Skipton North Yorkshire | United Kingdom | British | Financial Director | 53306760001 | ||||
PLENDERLEITH, Ian John Alexander | Geschäftsführer | Packsaddle Wrexham Road Rhostyllen LL14 4EH Wrexham | England | British | Chief Executive | 130393790001 | ||||
SMITH, Jeremy | Geschäftsführer | The Hollies Coronation Road Little Crakehall DL8 1HZ Bedale North Yorkshire | British | Company Director | 50016180001 | |||||
STRAHAN, David Edward | Geschäftsführer | Packsaddle Wrexham Road Rhostyllen LL14 4EH Wrexham | Northern Ireland | British | Finance Director | 145588240001 | ||||
YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000870001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ENERGY SUPPLIES UK LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dee Valley Limited | 06. Apr. 2016 | Wrexham Road Rhostyllen LL14 4EH Wrexham Packsaddle Clwyd Wales | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für ENERGY SUPPLIES UK LIMITED?
Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
---|---|---|
03. Sept. 2016 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es eine registrierungspflichtige Person in Bezug auf das Unternehmen gibt, hat diese jedoch nicht identifiziert. |
Hat ENERGY SUPPLIES UK LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Fixed charge | Erstellt am 24. Dez. 1999 Geliefert am 04. Jan. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The assets as detailed in the schedule to the form 395 and the proceeds and products thereof the benefit of all policies of insurance warranties guarantees and other contracts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed charge | Erstellt am 22. Apr. 1999 Geliefert am 28. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The property as per attached schedule to form 395 and the proceeds and products thereof and the benefit of all policies of insurance warranties and other contracts now in force or during the currency of this security entered into in respect of the property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 29. Mai 1997 Geliefert am 06. Juni 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0