2020 FRANCHISING LTD
Überblick
| Unternehmensname | 2020 FRANCHISING LTD |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03248728 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von 2020 FRANCHISING LTD?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich 2020 FRANCHISING LTD?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 4th Floor 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von 2020 FRANCHISING LTD?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CHEM-DRY CHARLIE LIMITED | 11. Sept. 1996 | 11. Sept. 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von 2020 FRANCHISING LTD?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Apr. 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für 2020 FRANCHISING LTD?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||
Change of details for Independent Group (Uk) Limited as a person with significant control on 06. Jan. 2023 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Ernennung von Cossey Cosec Services Limited als Sekretär am 25. Jan. 2023 | 2 Seiten | AP04 | ||
Beendigung der Bestellung von Rjp Secretaries Limited als Sekretär am 25. Jan. 2023 | 1 Seiten | TM02 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Ground Floor, Egerton House 68 Baker Street Weybridge Surrey KT13 8AL United Kingdom zum 4th Floor 24 Old Bond Street Mayfair London W1S 4AW am 06. Jan. 2023 | 1 Seiten | AD01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Sept. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Cessation of Chem-Dry U.K.Limited as a person with significant control on 31. Okt. 2022 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Notification of Independent Group (Uk) Limited as a person with significant control on 31. Okt. 2022 | 2 Seiten | PSC02 | ||
Change of details for Gold Round Limited as a person with significant control on 25. Juli 2022 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Änderung der Details des Direktors für Gold Round Limited am 25. Juli 2022 | 1 Seiten | CH02 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2021 | 6 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Sept. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Stuart Pace am 21. Juli 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2020 | 7 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von Alan Albert Horton als Geschäftsführer am 30. Juni 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Sept. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Change of details for Gold Round Limited as a person with significant control on 18. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Stuart Pace am 29. Juni 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2019 | 7 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Sept. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Change of details for Chem-Dry U.K.Limited as a person with significant control on 09. Aug. 2019 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 2 a C Court High Street Thames Ditton Surrey KT7 0SR England zum Ground Floor, Egerton House 68 Baker Street Weybridge Surrey KT13 8AL am 12. Aug. 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||
Änderung der Details des Sekretärs für Rjp Secretaries Limited am 09. Aug. 2019 | 1 Seiten | CH04 | ||
Erfüllung der Belastung 11 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von 2020 FRANCHISING LTD?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSSEY COSEC SERVICES LIMITED | Sekretär | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 4th Floor United Kingdom |
| 302964180001 | ||||||||||
| PACE, Stuart | Geschäftsführer | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 4th Floor United Kingdom | England | British | 207506130003 | |||||||||
| GOLD ROUND LIMITED | Geschäftsführer | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 4th Floor United Kingdom |
| 149588400001 | ||||||||||
| MAUGHAN, Anna | Sekretär | 404 Chester Road Boldmere B73 5BS Sutton Coldfield | British | 53071850001 | ||||||||||
| TAYLOR, Mark Andrew | Sekretär | Springhill 45 Woodland View Barnetby Le Wold DN38 6FE Brigg Lincolnshire | British | 95264700001 | ||||||||||
| THOMAS, Caroline Emma Roberts | Sekretär | 5 Broomsleigh Street NW6 1QQ London | British | 154322040001 | ||||||||||
| CORPORATE ADMINISTRATION SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Falcon House 24 North John Street L2 9RP Liverpool Merseyside | 900006800001 | |||||||||||
| RJP SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 68 Baker Street KT13 8AL Weybridge Ground Floor, Egerton House Surrey United Kingdom |
| 61999120002 | ||||||||||
| BELK, Andrew John | Geschäftsführer | Pen Plannau Moelfre SY10 7QL Llansilin North Wales | British | 65603000003 | ||||||||||
| BELL, Jonathan | Geschäftsführer | Swinemoor Lane HU17 0LS Beverley Colonial House East Yorkshire United Kingdom | England | British | 123082590001 | |||||||||
| DICKINSON, Louise | Geschäftsführer | Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Fulwood Park Lancashire | England | British | 139480580001 | |||||||||
| HORTON, Alan Albert | Geschäftsführer | 68 Baker Street KT13 8AL Weybridge Ground Floor, Egerton House Surrey United Kingdom | England | British | 182208240001 | |||||||||
| JOHNSTON, Iain | Geschäftsführer | 3 Scholes Park Road YO12 6RE Scarborough North Yorkshire | United Kingdom | Uk | 702270001 | |||||||||
| LEE, Peter Francis | Geschäftsführer | Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Fulwood Park Lancashire | England | British | 207608120001 | |||||||||
| LEES, Stuart | Geschäftsführer | Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Fulwood Park Lancashire | England | British | 70032700001 | |||||||||
| LLOYD-JONES, Andrew Mark | Geschäftsführer | Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Fulwood Park Lancashire | England | British | 149155620001 | |||||||||
| ROCKETT, Matthew Ian | Geschäftsführer | Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Fulwood Park Lancashire | British | British | 146169560001 | |||||||||
| ROCKETT, Matthew Ian | Geschäftsführer | Trent Walk Welton Grange HU15 1GF Brough 7 East Yorkshire | British | British | 146169560001 | |||||||||
| SMITH, Andrew John | Geschäftsführer | High Street KT7 0SR Thames Ditton 2 A C Court Surrey England | United Kingdom | British | 207506140001 | |||||||||
| SMITH, Andrew John | Geschäftsführer | Swinemoor Lane HU17 0LS Beverley Colonial House East Yorkshire | Uk | British | 149018750001 | |||||||||
| TAYLOR, Ian | Geschäftsführer | 4 Parkfield Avenue HU14 3AL North Ferriby East Yorkshirede | England | British | 6673550003 | |||||||||
| TAYLOR, Mark Andrew | Geschäftsführer | Westlands Queensgate HU17 8NE Beverley | United Kingdom | British | 95264700003 | |||||||||
| TAYLOR, Mark Andrew | Geschäftsführer | Springhill 45 Woodland View Barnetby Le Wold DN38 6FE Brigg Lincolnshire | British | 95264700001 | ||||||||||
| CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Falcon House 24 North John Street L2 9RP Liverpool Merseyside | 900006790001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei 2020 FRANCHISING LTD?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Independent Group (Uk) Limited | 31. Okt. 2022 | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 4th Floor United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Gold Round Limited | 18. Apr. 2016 | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 4th Floor United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Chem-Dry U.K.Limited | 06. Apr. 2016 | 68 Baker Street KT13 8AL Weybridge Ground Floor, Egerton House Surrey United Kingdom | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat 2020 FRANCHISING LTD Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 01. Sept. 2016 Geliefert am 13. Sept. 2016 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 03. Juni 2016 Geliefert am 16. Juni 2016 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A composite guarantee and debenture | Erstellt am 31. Jan. 2011 Geliefert am 08. Feb. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of accession to a composite guarantee and debenture dated 26 june 2009 | Erstellt am 31. Jan. 2011 Geliefert am 08. Feb. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. Jan. 2011 Geliefert am 03. Feb. 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A composite guarantee and debenture | Erstellt am 31. Juli 2010 Geliefert am 07. Aug. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 30. Juli 2010 Geliefert am 10. Aug. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargor to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Juli 2010 Geliefert am 05. Aug. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 24. Sept. 2009 Geliefert am 14. Okt. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from ingleby (1823) limited to the noteholders on any account whatsoever and all other monies due or to become due from any charging company under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the property and assets, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debentures | Erstellt am 24. Sept. 2009 Geliefert am 02. Okt. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the note issuer to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. Sept. 2009 Geliefert am 03. Okt. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 15. Dez. 2000 Geliefert am 05. Jan. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The property 22 park street hull. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 01. Dez. 2000 Geliefert am 15. Dez. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0