WORLDWIDE SNAKEBOARD MARKETING LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | WORLDWIDE SNAKEBOARD MARKETING LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03249436 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WORLDWIDE SNAKEBOARD MARKETING LIMITED?
- (9999) /
Wo befindet sich WORLDWIDE SNAKEBOARD MARKETING LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 35 Tameside Drive Castle Vale B35 7AG Birmingham United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von WORLDWIDE SNAKEBOARD MARKETING LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| MV SPORTS (HK) LIMITED | 07. März 2000 | 07. März 2000 |
| WORLDWIDE SNAKEBOARD MARKETING LIMITED | 13. Nov. 1996 | 13. Nov. 1996 |
| WOODPEN LIMITED | 13. Sept. 1996 | 13. Sept. 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WORLDWIDE SNAKEBOARD MARKETING LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Jan. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für WORLDWIDE SNAKEBOARD MARKETING LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Jan. 2012 bis 31. Dez. 2011 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Erklärung der Unternehmensgegenstände | 2 Seiten | CC04 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 12 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 09. Dez. 2010
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Geänderte Konten eines kleinen Unternehmens mit voller Befreiung erstellt bis 31. Jan. 2010 | 1 Seiten | AAMD | ||||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Jan. 2010 | 1 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Aug. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr James Charles Shears als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mervyn Keene als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Gurvinder Kaur am 17. Nov. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Stephen James Grant am 17. Nov. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mervyn Peter John Keene am 17. Nov. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr James Charles Shears am 17. Nov. 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Aug. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2009 | 1 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2008 | 1 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2007 | 1 Seiten | AA | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von WORLDWIDE SNAKEBOARD MARKETING LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEARS, James Charles | Sekretär | Tameside Drive Castle Vale B35 7AG Birmingham 35 United Kingdom | British | Group Financial Controller | 72228840001 | |||||
| GRANT, Stephen James | Geschäftsführer | Tameside Drive Castle Vale B35 7AG Birmingham 35 United Kingdom | England | British | Company Director | 60161650002 | ||||
| KAUR, Gurvinder | Geschäftsführer | Tameside Drive Castle Vale B35 7AG Birmingham 35 United Kingdom | England | British | Director | 68265540001 | ||||
| SHEARS, James Charles | Geschäftsführer | Tameside Drive Castle Vale B35 7AG Birmingham 35 United Kingdom | England | English | Director | 152168520001 | ||||
| DOWNS, Kevin | Sekretär | 21 Gleneagles Drive Stretton DE13 0YG Burton On Trent Staffordshire | British | Accountant | 14395290001 | |||||
| HANDS, Stephen James | Sekretär | 41 Sandy Hill Road Shirley B90 2ET Solihull West Midlands | British | Director | 68658850001 | |||||
| KEENE, Mervyn Peter John | Sekretär | 5 Broadway Crowland PE6 0BJ Peterborough | British | Accountant | 984450001 | |||||
| LLOYD, Cheryl Ann | Sekretär | 15 Kington Close WV12 5YW Willenhall West Midlands | British | Chief Accountant Company Secre | 72610320001 | |||||
| ODELL, Timothy Earnleigh | Sekretär | 19 Spring Court Road EN2 8JP Enfield Middlesex | Irish | Director | 57015200001 | |||||
| WING, Clifford Donald | Sekretär | 253 Bury Street West Edmonton N9 9JN London | British | 38279030001 | ||||||
| DOWNS, Kevin | Geschäftsführer | 21 Gleneagles Drive Stretton DE13 0YG Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | Director | 14395290001 | ||||
| FRENCH, Christopher Francis | Geschäftsführer | Post Box Cottage Rectory Road Streatley RG8 9QE Reading Berkshire | United Kingdom | British | Company Director | 30614040002 | ||||
| HANDS, Stephen James | Geschäftsführer | 41 Sandy Hill Road Shirley B90 2ET Solihull West Midlands | British | Director | 68658850001 | |||||
| KEENE, Mervyn Peter John | Geschäftsführer | Tameside Drive Castle Vale B35 7AG Birmingham 35 United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 984450001 | ||||
| LLOYD, David | Geschäftsführer | 12 Leys Road Oxshott KT22 0QA Leatherhead Surrey | British | Director | 50552570001 | |||||
| MACLEOD SMITH, Nicholas Marc | Geschäftsführer | 35 Hurlingham Square Peterborough Road SW6 3DZ Parsons Green London | Austrian | Director | 50032130001 | |||||
| ODELL, Timothy Earnleigh | Geschäftsführer | 19 Spring Court Road EN2 8JP Enfield Middlesex | Irish | Company Director | 57015200001 | |||||
| ODELL, Timothy Earnleigh | Geschäftsführer | 19 Spring Court Road EN2 8JP Enfield Middlesex | Irish | Irish | 57015200001 | |||||
| VICARY, Albert Paul | Geschäftsführer | Woodlands 88 Atlantic Way EX39 1JG Westward Ho Devon | British | Director | 30066960002 | |||||
| BONUSWORTH LIMITED | Geschäftsführer | Regis House 134 Percival Road EN1 1QU Enfield Middlesex | 39406570001 |
Hat WORLDWIDE SNAKEBOARD MARKETING LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of debenture made between mv sports group PLC,the company and the other companies as chargors (as defined) and burdale financial limited ("burdale") | Erstellt am 14. Sept. 2001 Geliefert am 28. Sept. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies, obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 03. Sept. 1998 Geliefert am 10. Sept. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Erstellt am 28. Apr. 1998 Geliefert am 11. Mai 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 53209100. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Erstellt am 27. Mai 1997 Geliefert am 02. Juni 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Barclays bank PLC re worldwide snakeboard marketing limited business premium account number 10500135. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0