CHATHAM MARITIME J3 DEVELOPMENTS LIMITED

CHATHAM MARITIME J3 DEVELOPMENTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCHATHAM MARITIME J3 DEVELOPMENTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03254715
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CHATHAM MARITIME J3 DEVELOPMENTS LIMITED?

    • (7011) /

    Wo befindet sich CHATHAM MARITIME J3 DEVELOPMENTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O Kroll Limited
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CHATHAM MARITIME J3 DEVELOPMENTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2005

    Welche sind die letzten Einreichungen für CHATHAM MARITIME J3 DEVELOPMENTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Hinweis auf den Abschlussbericht vor der Auflösung

    1 Seiten4.43

    Hinweis auf die Gründung des Liquidationsausschusses

    2 Seiten4.48

    Ernennung eines Liquidators

    1 Seiten4.31

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    1 SeitenCOCOMP

    legacy

    1 Seiten287

    Verschiedenes

    Form 4.15A - appt of prov liq
    6 SeitenMISC

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2005

    19 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    7 Seiten363s

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    7 Seiten363s

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2004

    14 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    7 Seiten363s

    legacy

    1 Seiten287

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2003

    14 SeitenAA

    legacy

    7 Seiten363s

    legacy

    1 Seiten288c

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2002

    13 SeitenAA

    legacy

    7 Seiten363s

    Wer sind die Geschäftsführer von CHATHAM MARITIME J3 DEVELOPMENTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HEWITT, Janet Helen
    32 Barlows Road
    Edgbaston
    B15 2PL Birmingham
    Sekretär
    32 Barlows Road
    Edgbaston
    B15 2PL Birmingham
    British61585200002
    HEWITT, Michael Richard Goodwin
    32 Barlows Road
    Edgbaston
    B15 2PL Birmingham
    Geschäftsführer
    32 Barlows Road
    Edgbaston
    B15 2PL Birmingham
    British39109560002
    REEVES, Steven Keith
    Colleyfelle
    Buckland Road
    RH2 9JP Reigate
    Surrey
    Geschäftsführer
    Colleyfelle
    Buckland Road
    RH2 9JP Reigate
    Surrey
    United KingdomBritish33796110002
    HEWITT, Michael Richard Goodwin
    32 Barlows Road
    Edgbaston
    B15 2PL Birmingham
    Sekretär
    32 Barlows Road
    Edgbaston
    B15 2PL Birmingham
    British39109560002
    REEVES, Steven Keith
    Colleyfelle
    Buckland Road
    RH2 9JP Reigate
    Surrey
    Sekretär
    Colleyfelle
    Buckland Road
    RH2 9JP Reigate
    Surrey
    British33796110002
    TUCKER, David
    The Spinney
    Highview Lane, Ridgewood
    TN22 5SY Uckfield
    East Sussex
    Sekretär
    The Spinney
    Highview Lane, Ridgewood
    TN22 5SY Uckfield
    East Sussex
    British64093660001
    WEAR, Michael
    20 Holderness Road
    Heaton
    NE6 5RH Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Sekretär
    20 Holderness Road
    Heaton
    NE6 5RH Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British36618580001
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Bevollmächtigter Sekretär
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    ELCOMBE, Justin Charles
    10a Elm Court Road
    Tulse Hill
    SE27 9BZ London
    Geschäftsführer
    10a Elm Court Road
    Tulse Hill
    SE27 9BZ London
    British33132260002
    HEWITT, Janet Helen
    32 Barlows Road
    Edgbaston
    B15 2PL Birmingham
    Geschäftsführer
    32 Barlows Road
    Edgbaston
    B15 2PL Birmingham
    United KingdomBritish61585200002
    HEWITT, Michael Richard Goodwin
    32 Barlows Road
    Edgbaston
    B15 2PL Birmingham
    Geschäftsführer
    32 Barlows Road
    Edgbaston
    B15 2PL Birmingham
    British39109560002
    HUDSON, Paul David
    66 Langdale Rise
    ME16 0EX Maidstone
    Kent
    Geschäftsführer
    66 Langdale Rise
    ME16 0EX Maidstone
    Kent
    EnglandBritish50355490001
    LUCK, Ralph David
    Flat 53 Java Wharf 16 Shad Thames
    SE1 2LY London
    Geschäftsführer
    Flat 53 Java Wharf 16 Shad Thames
    SE1 2LY London
    EnglandBritish20001570001
    SHELTON, David Keith
    5 Parkwood Close
    WA13 0NQ Lymm
    Cheshire
    Geschäftsführer
    5 Parkwood Close
    WA13 0NQ Lymm
    Cheshire
    EnglandBritish48868580002
    YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000870001

    Hat CHATHAM MARITIME J3 DEVELOPMENTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Lease rental deposit charge
    Erstellt am 05. Apr. 2001
    Geliefert am 18. Apr. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the developer's lease to pay the rent firstly reserved by the developer's lease
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge the account and the full credit balance therein and all rights and benefits accruing to or arising in connection therewith and by way of first floating all its undertaking assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royal & Sun Alliance Trust Company (Channel Islands) Limitedas Trustees of the Matrix Chatham Maritime Syndicate Trust (the Chargee)
    Transaktionen
    • 18. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Planning payment account charge
    Erstellt am 05. Apr. 2001
    Geliefert am 18. Apr. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 7.1.4(e) of the purchase and development agreement
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge the account and the full credit balance therein and all rights and benefits accruing to or arising in connection therewith and by way of first floating all its undertaking assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royal & Sun Alliance Trust Company (Channel Islands) Limitedas Trustees of the Matrix Chatham Maritime Syndicate Trust (the Chargee)
    Transaktionen
    • 18. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Tenant's account charge
    Erstellt am 05. Apr. 2001
    Geliefert am 18. Apr. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 12.6 of the purchase and development agreement
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge the account and the full credit balance therein and all rights and benefits accruing to or arising in connection therewith and by way of first floating all its undertaking assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royal & Sun Alliance Trust Company (Channel Islands) Limitedas Trustees of the Matrix Chatham Maritime Syndicate Trust (the Chargee)
    Transaktionen
    • 18. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Contractor's charge assignment
    Erstellt am 05. Apr. 2001
    Geliefert am 18. Apr. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the trustees pursuant to the purchase and development agreement
    Kurze Angaben
    By way of assignment by the developer to the trustee all the developer's right, title and interest in and under the charge over deposit and the benefits of all powers and remedies for enforcing the same, by way of first floating charge to the trustee all the developer's assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royal & Sun Alliance Trust Company (Channel Islands) Limitedas Trustees of the Matrix Chatham Maritime Syndicate Trust (the "Trustees")
    Transaktionen
    • 18. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Apr. 2001
    Geliefert am 10. Apr. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All of the company's liabilities to the chargee (whether at the time of the creation of the deed or future actual of contingent) under the development agreement and the boiler shop lease
    Kurze Angaben
    Property k/a site J3 chatham maritime or its proceeds of sale.
    Berechtigte Personen
    • The South East England Development Agency
    Transaktionen
    • 10. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)

    Hat CHATHAM MARITIME J3 DEVELOPMENTS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    09. Dez. 2010Aufgelöst am
    04. Mai 2007Antragsdatum
    11. Aug. 2010Abschluss der Liquidation
    25. Juli 2007Beginn der Liquidation
    Zwangsliquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Neil Hunter Cooper
    Kroll Limited
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    Kroll Limited
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Alastair Paul Beveridge
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    Praktiker
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0