CHATHAM MARITIME J3 DEVELOPMENTS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CHATHAM MARITIME J3 DEVELOPMENTS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03254715 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CHATHAM MARITIME J3 DEVELOPMENTS LIMITED?
- (7011) /
Wo befindet sich CHATHAM MARITIME J3 DEVELOPMENTS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Kroll Limited 10 Fleet Place EC4M 7RB London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CHATHAM MARITIME J3 DEVELOPMENTS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2005 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CHATHAM MARITIME J3 DEVELOPMENTS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Hinweis auf den Abschlussbericht vor der Auflösung | 1 Seiten | 4.43 | ||
Hinweis auf die Gründung des Liquidationsausschusses | 2 Seiten | 4.48 | ||
Ernennung eines Liquidators | 1 Seiten | 4.31 | ||
Gerichtsbeschluss zur Liquidation | 1 Seiten | COCOMP | ||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||
Verschiedenes Form 4.15A - appt of prov liq | 6 Seiten | MISC | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2005 | 19 Seiten | AA | ||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2004 | 14 Seiten | AA | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2003 | 14 Seiten | AA | ||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2002 | 13 Seiten | AA | ||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||
Wer sind die Geschäftsführer von CHATHAM MARITIME J3 DEVELOPMENTS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEWITT, Janet Helen | Sekretär | 32 Barlows Road Edgbaston B15 2PL Birmingham | British | 61585200002 | ||||||
| HEWITT, Michael Richard Goodwin | Geschäftsführer | 32 Barlows Road Edgbaston B15 2PL Birmingham | British | 39109560002 | ||||||
| REEVES, Steven Keith | Geschäftsführer | Colleyfelle Buckland Road RH2 9JP Reigate Surrey | United Kingdom | British | 33796110002 | |||||
| HEWITT, Michael Richard Goodwin | Sekretär | 32 Barlows Road Edgbaston B15 2PL Birmingham | British | 39109560002 | ||||||
| REEVES, Steven Keith | Sekretär | Colleyfelle Buckland Road RH2 9JP Reigate Surrey | British | 33796110002 | ||||||
| TUCKER, David | Sekretär | The Spinney Highview Lane, Ridgewood TN22 5SY Uckfield East Sussex | British | 64093660001 | ||||||
| WEAR, Michael | Sekretär | 20 Holderness Road Heaton NE6 5RH Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 36618580001 | ||||||
| YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000880001 | |||||||
| ELCOMBE, Justin Charles | Geschäftsführer | 10a Elm Court Road Tulse Hill SE27 9BZ London | British | 33132260002 | ||||||
| HEWITT, Janet Helen | Geschäftsführer | 32 Barlows Road Edgbaston B15 2PL Birmingham | United Kingdom | British | 61585200002 | |||||
| HEWITT, Michael Richard Goodwin | Geschäftsführer | 32 Barlows Road Edgbaston B15 2PL Birmingham | British | 39109560002 | ||||||
| HUDSON, Paul David | Geschäftsführer | 66 Langdale Rise ME16 0EX Maidstone Kent | England | British | 50355490001 | |||||
| LUCK, Ralph David | Geschäftsführer | Flat 53 Java Wharf 16 Shad Thames SE1 2LY London | England | British | 20001570001 | |||||
| SHELTON, David Keith | Geschäftsführer | 5 Parkwood Close WA13 0NQ Lymm Cheshire | England | British | 48868580002 | |||||
| YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000870001 |
Hat CHATHAM MARITIME J3 DEVELOPMENTS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Lease rental deposit charge | Erstellt am 05. Apr. 2001 Geliefert am 18. Apr. 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the developer's lease to pay the rent firstly reserved by the developer's lease | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge the account and the full credit balance therein and all rights and benefits accruing to or arising in connection therewith and by way of first floating all its undertaking assets and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Planning payment account charge | Erstellt am 05. Apr. 2001 Geliefert am 18. Apr. 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 7.1.4(e) of the purchase and development agreement | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge the account and the full credit balance therein and all rights and benefits accruing to or arising in connection therewith and by way of first floating all its undertaking assets and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Tenant's account charge | Erstellt am 05. Apr. 2001 Geliefert am 18. Apr. 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 12.6 of the purchase and development agreement | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge the account and the full credit balance therein and all rights and benefits accruing to or arising in connection therewith and by way of first floating all its undertaking assets and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Contractor's charge assignment | Erstellt am 05. Apr. 2001 Geliefert am 18. Apr. 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the trustees pursuant to the purchase and development agreement | |
Kurze Angaben By way of assignment by the developer to the trustee all the developer's right, title and interest in and under the charge over deposit and the benefits of all powers and remedies for enforcing the same, by way of first floating charge to the trustee all the developer's assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 05. Apr. 2001 Geliefert am 10. Apr. 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All of the company's liabilities to the chargee (whether at the time of the creation of the deed or future actual of contingent) under the development agreement and the boiler shop lease | |
Kurze Angaben Property k/a site J3 chatham maritime or its proceeds of sale. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat CHATHAM MARITIME J3 DEVELOPMENTS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Zwangsliquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0