CHATHAM MARITIME B2 DEVELOPMENTS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | CHATHAM MARITIME B2 DEVELOPMENTS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03254727 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CHATHAM MARITIME B2 DEVELOPMENTS LIMITED?
- (4521) /
Wo befindet sich CHATHAM MARITIME B2 DEVELOPMENTS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 8 Salisbury Square EC4Y 8BB London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CHATHAM MARITIME B2 DEVELOPMENTS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2008 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CHATHAM MARITIME B2 DEVELOPMENTS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 4 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 07. Juli 2011 | 5 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 07. Jan. 2011 | 5 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Miller Construction (Uk) Limited 1 Charter Point Way Ashby Business Park Ashby De La Zouch LE65 1NF am 18. Jan. 2010 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2005 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2004 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 8 Seiten | 363s |
Wer sind die Geschäftsführer von CHATHAM MARITIME B2 DEVELOPMENTS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMYTH, Pamela June | Sekretär | 53 East Craigs Wynd EH12 8HJ Edinburgh | British | 65057960002 | ||||||
BROWN, Alan Rodney | Geschäftsführer | Foxdown House Yew Tree Close Willoughby Waterleys LE8 6BU Leicester | England | British | Director | 36034750001 | ||||
MCVEY, Philip | Geschäftsführer | 11 Birrell Gardens EH54 9LF Livingston | United Kingdom | British | Surveyor | 99001530002 | ||||
SCOTT, Alan Philip | Geschäftsführer | Harlaw Bank Balerno EH14 7HR Edinburgh 2 | Scotland | British | Chartered Accountant | 182952430001 | ||||
BROWN, Alan Rodney | Sekretär | Foxdown House Yew Tree Close Willoughby Waterleys LE8 6BU Leicester | British | Director | 36034750001 | |||||
DONALDSON, Euan James | Sekretär | 28 Trainers Brae EH39 4NR North Berwick East Lothian | British | 41273760002 | ||||||
MACKINNON, Iain Lachlan | Sekretär | 1 Hermitage Drive EH10 6DE Edinburgh | British | 66282570001 | ||||||
TUCKER, David | Sekretär | The Spinney Highview Lane, Ridgewood TN22 5SY Uckfield East Sussex | British | Financial Director | 64093660001 | |||||
WEAR, Michael | Sekretär | 20 Holderness Road Heaton NE6 5RH Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 36618580001 | ||||||
YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000880001 | |||||||
BREMNER, Alexander George | Geschäftsführer | Inch Avenue Aberdour KY3 0TF Burntisland 3 Fife | Scotland | British | Head Of Public Private Partner | 152806580001 | ||||
BROWN, Alan Rodney | Geschäftsführer | Foxdown House Yew Tree Close Willoughby Waterleys LE8 6BU Leicester | England | British | Director | 36034750001 | ||||
ELCOMBE, Justin Charles | Geschäftsführer | 10a Elm Court Road Tulse Hill SE27 9BZ London | British | Surveyor | 33132260002 | |||||
HUDSON, Paul David | Geschäftsführer | 66 Langdale Rise ME16 0EX Maidstone Kent | England | British | Director Of South East England | 50355490001 | ||||
LUCK, Ralph David | Geschäftsführer | Flat 53 Java Wharf 16 Shad Thames SE1 2LY London | England | British | Deveopment Director | 20001570001 | ||||
MCEWAN, Michael William | Geschäftsführer | 46 Learmonth Grove EH4 1BN Edinburgh | British | Finance Director | 59545340001 | |||||
SHELTON, David Keith | Geschäftsführer | 5 Parkwood Close WA13 0NQ Lymm Cheshire | England | British | Projects Director | 48868580002 | ||||
YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000870001 |
Hat CHATHAM MARITIME B2 DEVELOPMENTS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Land deposit charge | Erstellt am 28. Feb. 2000 Geliefert am 16. März 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag The covenants given by the company as set out in the clause headed "charge" in the land deposit charge in favour of the chargee | |
Kurze Angaben The account (as defined in the charge). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Service charge and insurance deposit second charge | Erstellt am 28. Feb. 2000 Geliefert am 16. März 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag The covenants given by the company as set out in the clause headed "charge" in the service charge and insurance deposit second charge in favour of the chargee | |
Kurze Angaben The deposit accounts and the deposit balance (as defined in the charge). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Construction cost charge | Erstellt am 28. Feb. 2000 Geliefert am 10. März 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a purchase and development agreement of even date | |
Kurze Angaben An interest bearing account numbered 00165464 known as chatham maritime construction cost deposit account with the initial deposit of £10,145,000 together with all rights and benefits. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 28. Feb. 2000 Geliefert am 10. März 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a purchase and development agreement of even date | |
Kurze Angaben Undertaking and all property and assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent account charge | Erstellt am 28. Feb. 2000 Geliefert am 10. März 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the non-occupational lease or any occupational lease in accordance with the provisions of a purchase and development agreement entered into on 28 february 2000 | |
Kurze Angaben An interest bearing account numbered 038511 including all sums for the time being held therein pursuant to the rent account charge including all interest credited to the account from time to time the initial deposit being £7,293,681.51 the full credit balance all rights and benefits accruing to or arising in connection with the account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Syndicate expenses deposit charge | Erstellt am 28. Feb. 2000 Geliefert am 10. März 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed of even date | |
Kurze Angaben An interest bearing account designated "chatham maritime syndicate expenses account" opened with the governor and company of the bank of scotland of the mound edinburgh under account number 00165384 the initial deposit being £150,000. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Service charge and insurance deposit charge | Erstellt am 28. Feb. 2000 Geliefert am 10. März 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed of even date | |
Kurze Angaben An interest bearing account designated "chatham maritime service charge fixed rate account" opened with bank of scotland treasury services PLC of 224 ingram street, glasgow G1 1DR under account number 039407 the initial deposit being £786,618.49. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat CHATHAM MARITIME B2 DEVELOPMENTS LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0