CHATHAM MARITIME B3 DEVELOPMENTS LIMITED

CHATHAM MARITIME B3 DEVELOPMENTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCHATHAM MARITIME B3 DEVELOPMENTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03254732
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CHATHAM MARITIME B3 DEVELOPMENTS LIMITED?

    • (4521) /

    Wo befindet sich CHATHAM MARITIME B3 DEVELOPMENTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O Miller Construction (Uk)
    Limited 1 Charter Point Way
    LE65 1NF Ashby Business Park
    Ashby De La Zouch
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CHATHAM MARITIME B3 DEVELOPMENTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für CHATHAM MARITIME B3 DEVELOPMENTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 14. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital04. Dez. 2009

    Kapitalaufstellung am 04. Dez. 2009

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    1 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    1 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    1 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005

    1 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2004

    1 SeitenAA

    legacy

    6 Seiten363a

    legacy

    3 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    3 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten287

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2003

    1 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von CHATHAM MARITIME B3 DEVELOPMENTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SMYTH, Pamela June
    53 East Craigs Wynd
    EH12 8HJ Edinburgh
    Sekretär
    53 East Craigs Wynd
    EH12 8HJ Edinburgh
    British65057960002
    BROWN, Alan Rodney
    Foxdown House
    Yew Tree Close Willoughby Waterleys
    LE8 6BU Leicester
    Geschäftsführer
    Foxdown House
    Yew Tree Close Willoughby Waterleys
    LE8 6BU Leicester
    EnglandBritish36034750001
    MCVEY, Philip
    11 Birrell Gardens
    EH54 9LF Livingston
    Geschäftsführer
    11 Birrell Gardens
    EH54 9LF Livingston
    United KingdomBritish99001530002
    SCOTT, Alan Philip
    Harlaw Bank
    Balerno
    EH14 7HR Edinburgh
    2
    Geschäftsführer
    Harlaw Bank
    Balerno
    EH14 7HR Edinburgh
    2
    ScotlandBritish182952430001
    BROWN, Alan Rodney
    Foxdown House
    Yew Tree Close Willoughby Waterleys
    LE8 6BU Leicester
    Sekretär
    Foxdown House
    Yew Tree Close Willoughby Waterleys
    LE8 6BU Leicester
    British36034750001
    DONALDSON, Euan James
    28 Trainers Brae
    EH39 4NR North Berwick
    East Lothian
    Sekretär
    28 Trainers Brae
    EH39 4NR North Berwick
    East Lothian
    British41273760002
    MACKINNON, Iain Lachlan
    1 Hermitage Drive
    EH10 6DE Edinburgh
    Sekretär
    1 Hermitage Drive
    EH10 6DE Edinburgh
    British66282570001
    TUCKER, David
    The Spinney
    Highview Lane, Ridgewood
    TN22 5SY Uckfield
    East Sussex
    Sekretär
    The Spinney
    Highview Lane, Ridgewood
    TN22 5SY Uckfield
    East Sussex
    British64093660001
    WEAR, Michael
    20 Holderness Road
    Heaton
    NE6 5RH Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Sekretär
    20 Holderness Road
    Heaton
    NE6 5RH Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British36618580001
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Bevollmächtigter Sekretär
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    BREMNER, Alexander George
    Inch Avenue
    Aberdour
    KY3 0TF Burntisland
    3
    Fife
    Geschäftsführer
    Inch Avenue
    Aberdour
    KY3 0TF Burntisland
    3
    Fife
    ScotlandBritish152806580001
    BROWN, Alan Rodney
    Foxdown House
    Yew Tree Close Willoughby Waterleys
    LE8 6BU Leicester
    Geschäftsführer
    Foxdown House
    Yew Tree Close Willoughby Waterleys
    LE8 6BU Leicester
    EnglandBritish36034750001
    ELCOMBE, Justin Charles
    10a Elm Court Road
    Tulse Hill
    SE27 9BZ London
    Geschäftsführer
    10a Elm Court Road
    Tulse Hill
    SE27 9BZ London
    British33132260002
    HUDSON, Paul David
    66 Langdale Rise
    ME16 0EX Maidstone
    Kent
    Geschäftsführer
    66 Langdale Rise
    ME16 0EX Maidstone
    Kent
    EnglandBritish50355490001
    LUCK, Ralph David
    Flat 53 Java Wharf 16 Shad Thames
    SE1 2LY London
    Geschäftsführer
    Flat 53 Java Wharf 16 Shad Thames
    SE1 2LY London
    EnglandBritish20001570001
    MCEWAN, Michael William
    46 Learmonth Grove
    EH4 1BN Edinburgh
    Geschäftsführer
    46 Learmonth Grove
    EH4 1BN Edinburgh
    British59545340001
    SHELTON, David Keith
    5 Parkwood Close
    WA13 0NQ Lymm
    Cheshire
    Geschäftsführer
    5 Parkwood Close
    WA13 0NQ Lymm
    Cheshire
    EnglandBritish48868580002
    YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000870001

    Hat CHATHAM MARITIME B3 DEVELOPMENTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Land deposit charge
    Erstellt am 28. Feb. 2000
    Geliefert am 16. März 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    The covenants given by the company as set out in the clause headed "charge" in the land deposit charge in favour of the chargee
    Kurze Angaben
    The account (as defined in the charge).
    Berechtigte Personen
    • South East England Development Agency
    Transaktionen
    • 16. März 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Service charge and insurance deposit second charge
    Erstellt am 28. Feb. 2000
    Geliefert am 16. März 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    The covenants given by the company as set out in the clause headed "charge" in the service charge and insurance deposit second charge in favour of the chargee
    Kurze Angaben
    The deposit accounts and the deposit balance (as defined in the charge).
    Berechtigte Personen
    • South East England Development Agency
    Transaktionen
    • 16. März 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Construction cost charge
    Erstellt am 28. Feb. 2000
    Geliefert am 10. März 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a purchase and development agreement of even date
    Kurze Angaben
    An interest bearing account numbered 00165464 known as chatham maritime construction cost deposit account with the initial deposit of £10,145,000 together with all rights and benefits.
    Berechtigte Personen
    • Robert Lo Philip Elwyn Buggins and Stephen Fenton as Trustees of the Chatham Maritime Syndicate
    Transaktionen
    • 10. März 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 28. Feb. 2000
    Geliefert am 10. März 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a purchase and development agreement of even date
    Kurze Angaben
    Undertaking and all property and assets.
    Berechtigte Personen
    • Robert Lo Philip Elwyn Buggins and Stephen Fenton as Trustees of the Chatham Maritime Syndicate
    Transaktionen
    • 10. März 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Rent account charge
    Erstellt am 28. Feb. 2000
    Geliefert am 10. März 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the non-occupational lease or any occupational lease in accordance with the provisions of a purchase and development agreement entered into on 28 february 2000
    Kurze Angaben
    An interest bearing account numbered 038511 including all sums for the time being held therein pursuant to the rent account charge including all interest credited to the account from time to time the initial deposit being £7,293,681.51 the full credit balance all rights and benefits accruing to or arising in connection with the account.
    Berechtigte Personen
    • Robert Lo Philip Elwyn Buggins and Stephen Fenton as Trustees of the Chatham Maritime Syndicate
    Transaktionen
    • 10. März 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Syndicate expenses deposit charge
    Erstellt am 28. Feb. 2000
    Geliefert am 10. März 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed of even date
    Kurze Angaben
    An interest bearing account designated "chatham maritime syndicate expenses account" opened with the governor and company of the bank of scotland of the mound edinburgh account number 00165384 the initial deposit being £150,000. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Rogert Lo, Philip Elwyn Buggins and Stephen Fenton (As Trustees of the Chatham Maritimesyndicate)
    Transaktionen
    • 10. März 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Service charge and insurance deposit charge
    Erstellt am 28. Feb. 2000
    Geliefert am 10. März 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed of even date
    Kurze Angaben
    An interest bearing account designated "chatham maritime service charge fixed rate account" opened with bank of scotland treasury services PLC of 224 ingram street, glasgow G1 1DR under account number 039407 the initial deposit being £786,618.49. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Rogert Lo, Philip Elwyn Buggins and Stephen Fenton (As Trustees of the Chatham Maritimesyndicate)
    Transaktionen
    • 10. März 2000Registrierung einer Belastung (395)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0