PRODRIVE AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (OVERSEAS HOLDINGS) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PRODRIVE AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (OVERSEAS HOLDINGS) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03255718 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PRODRIVE AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (OVERSEAS HOLDINGS) LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich PRODRIVE AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (OVERSEAS HOLDINGS) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Prodrive Headquarters Chalker Way OX16 4XD Banbury Oxfordshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PRODRIVE AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (OVERSEAS HOLDINGS) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| TICKFORD (OVERSEAS HOLDINGS) LIMITED | 02. Mai 1997 | 02. Mai 1997 |
| INGLEBY (941) LIMITED | 27. Sept. 1996 | 27. Sept. 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PRODRIVE AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (OVERSEAS HOLDINGS) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für PRODRIVE AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (OVERSEAS HOLDINGS) LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für PRODRIVE AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (OVERSEAS HOLDINGS) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Tim Mark Colchester als Direktor am 16. Dez. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Dominic Owen Cartwright als Geschäftsführer am 16. Dez. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Nov. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Acorn Way Banbury Oxfordshire OX16 3ER zum Prodrive Headquarters Chalker Way Banbury Oxfordshire OX16 4XD am 20. Apr. 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Dominic Owen Cartwright am 05. Feb. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Nov. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Dominic Cartwright als Direktor am 26. Sept. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Anthony Butcher als Geschäftsführer am 18. Sept. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Anthony Butcher am 25. Nov. 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Timothy Carew Bailey am 25. Nov. 2013 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Okt. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PRODRIVE AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (OVERSEAS HOLDINGS) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAILEY, Timothy Carew | Sekretär | Chalker Way OX16 4XD Banbury Prodrive Headquarters Oxfordshire England | British | 122203180001 | ||||||
| COLCHESTER, Tim Mark | Geschäftsführer | Chalker Way OX16 4XD Banbury Prodrive Headquarters Oxfordshire | England | British | 184641070001 | |||||
| HALL, David | Sekretär | Ash Tree House Leys Lane Preston Bissett MK18 4LX Buckingham Bucks | British | 24273020001 | ||||||
| HORSLEY, Richard Geoffrey Courtenay | Sekretär | Elliotts Farmhouse Adstone NN12 8DY Towcester Northamptonshire | British | 83097700001 | ||||||
| LAWRENCE, Mark | Sekretär | 41 Highbury Lane MK9 4AQ Central Milton Keynes | British | 82730880002 | ||||||
| INGLEBY NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 55 Colmore Row B3 2AS Birmingham | 900007860001 | |||||||
| BUTCHER, Anthony James | Geschäftsführer | Banbury OX16 3ER Oxfordshire Acorn Way | England | British | 192406620001 | |||||
| CARTWRIGHT, Dominic Owen | Geschäftsführer | Chalker Way OX16 4XD Banbury Prodrive Headquarters Oxfordshire England | England | British | 191286570002 | |||||
| FRY, Nicholas Richard | Geschäftsführer | 41 Hobson Road Summertown OX2 7JU Oxford Oxfordshire | British | 95886760001 | ||||||
| HALL, David | Geschäftsführer | Ash Tree House Leys Lane Preston Bissett MK18 4LX Buckingham Bucks | British | 24273020001 | ||||||
| HORSLEY, Richard Geoffrey Courtenay | Geschäftsführer | Elliotts Farmhouse Adstone NN12 8DY Towcester Northamptonshire | England | British | 83097700001 | |||||
| TEMPEST, Andrew George | Geschäftsführer | Montbretia Cottage Pottergate Street Aslacton NR15 2JU Norwich Norfolk | England | British | 17414010001 | |||||
| THURSTON, John | Geschäftsführer | Grange Farm Hatch Lane NN7 2AR Horton Northamptonshire | British | 5658990003 | ||||||
| INGLEBY HOLDINGS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 55 Colmore Row B3 2AS Birmingham | 900007850001 |
Hat PRODRIVE AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (OVERSEAS HOLDINGS) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Pledge agreement | Erstellt am 17. Mai 2001 Geliefert am 01. Juni 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or the pledgor to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All shares of the capital stock of the us subsidiary, and the certificates representing the shares of such capital stock, all options and warrants for the purchase of shares of the capital stock of the us subsidiary as at 17 may 2001. all dividends, cash, instruments and other property from time to time received, receivable or otherwise. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Intellectual property charge | Erstellt am 17. Mai 2001 Geliefert am 01. Juni 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All intellectual property rights (as defined) all right title and interest throughout the world in all those third party rights together with the entire benefit of the third party rights and all proceeds money and other rights and benefits in respect of the exercise of such intellectual property rights and/or third party rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession to a composite guarantee and debenture | Erstellt am 17. Mai 2001 Geliefert am 01. Juni 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0