ISOCO 1 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameISOCO 1 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03256072
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ISOCO 1 LIMITED?

    • Sonstige Herstellung n.e.c. (32990) / Verarbeitendes Gewerbe

    Wo befindet sich ISOCO 1 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    21 Highfield Road
    DA1 2JS Dartford
    Kent
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ISOCO 1 LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CLEANTEC INNOVATION LIMITED23. Juni 201023. Juni 2010
    DRIZONE TECHNOLOGIES LIMITED16. Juni 201016. Juni 2010
    CARPET MAINTENANCE SPECIALISTS LIMITED03. Dez. 199603. Dez. 1996
    CONFIGURATIVE SYSTEMS LIMITED27. Sept. 199627. Sept. 1996

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ISOCO 1 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für ISOCO 1 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Mitteilung über das Ende der Verwaltung

    23 SeitenAM21

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    3 SeitenAM19

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    3 SeitenAM19

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    22 SeitenAM10

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    3 SeitenAM19

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    24 SeitenAM10

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    46 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    9 Seiten2.16B

    Ernennung eines Verwalters

    3 Seiten2.12B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 21 Highfield Road Dartford DA1 2JS England zum 21 Highfield Road Dartford Kent DA1 2JS am 13. März 2017

    2 SeitenAD01

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name07. März 2017

    Namensänderung durch Beschluss

    NM01
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 24. Feb. 2017

    RES15

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Building 356 Cleantec House, Wharf Road Discovery Park, Ramsgate Road Sandwich Kent zum 21 Highfield Road Dartford DA1 2JS am 07. März 2017

    1 SeitenAD01

    Bestätigungserklärung erstellt am 19. Sept. 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2015

    8 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Kevin Richard Fleischer als Geschäftsführer am 04. Dez. 2015

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital01. Okt. 2015

    Kapitalaufstellung am 01. Okt. 2015

    • Kapital: GBP 500,100
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2014

    6 SeitenAA

    Eintragung der Belastung 032560720010, erstellt am 19. Mai 2015

    34 SeitenMR01

    Erfüllung der Belastung 032560720005 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 032560720009 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    1 SeitenMR04

    Wer sind die Geschäftsführer von ISOCO 1 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    OSBORN, Lorna
    Highfield Road
    DA1 2JS Dartford
    21
    Kent
    Sekretär
    Highfield Road
    DA1 2JS Dartford
    21
    Kent
    192675530001
    HAMILTON, Gillian
    Highfield Road
    DA1 2JS Dartford
    21
    Kent
    Geschäftsführer
    Highfield Road
    DA1 2JS Dartford
    21
    Kent
    United KingdomBritishCompany Director19650530005
    ALEXANDRE, Richard Graham
    Providence Cottage
    Saint Peters Lane, Bickenhill
    B92 0DP Solihull
    West Midlands
    Sekretär
    Providence Cottage
    Saint Peters Lane, Bickenhill
    B92 0DP Solihull
    West Midlands
    South Africa74710020001
    HARRIS, David Douglas
    94 Kingsgate Avenue
    Kingsgate
    CT10 3LW Broadstairs
    Kent
    Sekretär
    94 Kingsgate Avenue
    Kingsgate
    CT10 3LW Broadstairs
    Kent
    EnglishDirector48467030002
    LAWRENCE, Wendy Michelle
    Cleantec House, Wharf Road
    Discovery Park, Ramsgate Road
    Sandwich
    Building 356
    Kent
    United Kingdom
    Sekretär
    Cleantec House, Wharf Road
    Discovery Park, Ramsgate Road
    Sandwich
    Building 356
    Kent
    United Kingdom
    151566370001
    PARTOVI, Amy
    269 Dover Road
    CT19 6NT Folkestone
    Kent
    Sekretär
    269 Dover Road
    CT19 6NT Folkestone
    Kent
    BritishFinance Manager121134210001
    PHILLIPS, Gillian
    9 Westwood Road
    CT10 2LB Broadstairs
    Kent
    Sekretär
    9 Westwood Road
    CT10 2LB Broadstairs
    Kent
    British19650530003
    TRIANTAFILOU, Lindsay Phillippa
    8 Chestnut Drive
    Sturry
    CT2 0NB Canterbury
    Kent
    Sekretär
    8 Chestnut Drive
    Sturry
    CT2 0NB Canterbury
    Kent
    British100158770001
    WANTENAAR, Lance
    46a Dudley Court Lower Road
    HA2 0DH South Harrow
    Middlesex
    Sekretär
    46a Dudley Court Lower Road
    HA2 0DH South Harrow
    Middlesex
    British50586530001
    WARNER, Nicola Susan Rosemarie
    158 Botany Road
    CT10 3SE Broadstairs
    Kent
    Sekretär
    158 Botany Road
    CT10 3SE Broadstairs
    Kent
    British80168410002
    HARBEN REGISTRARS LIMITED
    37 Warren Street
    W1T 6AD London
    Sekretär
    37 Warren Street
    W1T 6AD London
    76506900001
    HARBEN REGISTRARS LIMITED
    37 Warren Street
    W1P 5PD London
    Bevollmächtigter Sekretär
    37 Warren Street
    W1P 5PD London
    900001570001
    ALDER, Nicholas John
    Rivendell, 9 Oakland Court
    Cliffsend
    CT12 5JY Ramsgate
    Kent
    Geschäftsführer
    Rivendell, 9 Oakland Court
    Cliffsend
    CT12 5JY Ramsgate
    Kent
    EnglandEnglishChartered Accountant141408750001
    ALEXANDER, Christopher James
    Pickford House
    Cottage Green Lane Allesley
    CV5 9AP Coventry
    Geschäftsführer
    Pickford House
    Cottage Green Lane Allesley
    CV5 9AP Coventry
    BritishCompany Director80955840001
    BODDY, Nicholas Andrew, Mr.
    Cleantec House, Wharf Road
    Discovery Park, Ramsgate Road
    Sandwich
    Building 356
    Kent
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Cleantec House, Wharf Road
    Discovery Park, Ramsgate Road
    Sandwich
    Building 356
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritishConsultant94569090001
    BOWER, Mark
    21 Norwich Avenue
    OL11 5JZ Rochdale
    Lancashire
    Geschäftsführer
    21 Norwich Avenue
    OL11 5JZ Rochdale
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector17950460003
    COCKERHAM, Sallianne Helen
    Southampton Row
    London
    31
    Geschäftsführer
    Southampton Row
    London
    31
    United KingdomBritishSolicitor152223300001
    FLEISCHER, Kevin Richard
    Cleantec House, Wharf Road
    Discovery Park, Ramsgate Road
    Sandwich
    Building 356
    Kent
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Cleantec House, Wharf Road
    Discovery Park, Ramsgate Road
    Sandwich
    Building 356
    Kent
    United Kingdom
    South AfricaPortugueseFinancial Director192085370001
    FLEISCHER, Kevin Richard
    Cleantec House, Wharf Road
    Discovery Park, Ramsgate Road
    Sandwich
    Building 356
    Kent
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Cleantec House, Wharf Road
    Discovery Park, Ramsgate Road
    Sandwich
    Building 356
    Kent
    United Kingdom
    South AfricaPortugueseDirector192085370001
    HARRIS, David Douglas
    94 Kingsgate Avenue
    Kingsgate
    CT10 3LW Broadstairs
    Kent
    Geschäftsführer
    94 Kingsgate Avenue
    Kingsgate
    CT10 3LW Broadstairs
    Kent
    EnglandEnglishEngineer48467030002
    PHILLIPS, Craig John Thomas
    The Lodge
    North Foreland Road
    CT10 3FA Broadstairs
    Geschäftsführer
    The Lodge
    North Foreland Road
    CT10 3FA Broadstairs
    BritishSales And Marketing68812270002
    PHILLIPS, Craig John Thomas
    The Lodge
    North Foreland Road
    CT10 3FA Broadstairs
    Geschäftsführer
    The Lodge
    North Foreland Road
    CT10 3FA Broadstairs
    BritishSales And Marketing68812270002
    SPELMAN, Fiona Maria
    38 Horsenden Lane South
    UB6 8AD Perivale
    Middlesex
    Geschäftsführer
    38 Horsenden Lane South
    UB6 8AD Perivale
    Middlesex
    IrishCompany Director50586490001
    HARBEN NOMINEES LIMITED
    37 Warren Street
    W1P 5PD London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    37 Warren Street
    W1P 5PD London
    900001560001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ISOCO 1 LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mrs Gillian Hamilton
    Highfield Road
    DA1 2JS Dartford
    21
    Kent
    06. Apr. 2016
    Highfield Road
    DA1 2JS Dartford
    21
    Kent
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: United Kingdom
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat ISOCO 1 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 19. Mai 2015
    Geliefert am 21. Mai 2015
    Ausstehend
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Kent County Council
    Transaktionen
    • 21. Mai 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 01. Feb. 2015
    Geliefert am 03. Feb. 2015
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    39 gladstone road broadstairs title number K245881.
    Berechtigte Personen
    • Neil Brooks
    Transaktionen
    • 03. Feb. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 13. März 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 20. Nov. 2014
    Geliefert am 24. Nov. 2014
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    All monetary and all obligations and liabilities whether actual or contingent now or hereafter due owing or incurred by the company to or in favour of ultimate invoice finance limited, present or future, actual or contingent, liquidated or unliquidated, whether arising in or by contract, tort, restitution, assignment or breach of statutory duty and whether arising under the factoring agreement between ultimate invoice finance limited and the company or otherwise including (without prejudice to that generality) any such liability of the company by virtue of any assignment to ultimate invoice finance limited of any indebtedness incurred or to be incurred by the company for any supply of any goods or services to or any hiring by the company.. 1. by way of first fixed charge:. A) the freehold and leasehold property of the company both present and future and all trade fixtures and fittings and all plant and machinery from time to time in or on any such land or buildings;. B) all goodwill and unpaid/and/or uncalled capital of the company;. C) all stocks shares and securities and documents evidencing title to or the right to possession of any property at any time deposited with ultimate invoice finance limited and the property mentioned in such documents;. D) all intellectual property now owned or at any time hereafter to be owned by the company;. E) any debt (purchased or purported to be purchased by ultimate invoice finance limited pursuant to the factoring agreement between ultimate invoice finance limited and the company), of which the ownership fails to vest absolutely and effectively in ultimate invoice finance limited for any reason, together with the related rights pertaining to such debt and the proceeds of it;. F) all amounts of indebtedness now or at any time hereafter owing or becoming due to the company on any account whatsoever (together with their proceeds and the related rights pertaining thereto);. G) all amounts now or hereafter owing or becoming due to the company by ultimate invoice finance limited including (but not limited to) any amount retained by ultimate invoice finance limited under any provision of the factoring agreement between ultimate invoice finance limited and the company.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Ultimate Invoice Finance LTD
    Transaktionen
    • 24. Nov. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 20. Nov. 2014
    Geliefert am 21. Nov. 2014
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    All monetary and all obligations and liabilities whether actual or contingent now or hereafter due owing or incurred by the company to or in favour of ultimate invoice finance limited, present or future, actual or contingent, liquidated or unliquidated, whether arising in or by contract, tort, restitution, assignment or breach of statutory duty and whether arising under the factoring agreement between ultimate invoice finance limited and the company or otherwise including (without prejudice to that generality) any such liability of the company by virtue of any assignment to ultimate invoice finance limited of any indebtedness incurred or to be incurred by the company for any supply of any goods or services to or any hiring by the company.. 1. by way of first fixed charge:. A) the freehold and leasehold property of the company both present and future and all trade fixtures and fittings and all plant and machinery from time to time in or on any such land or buildings;. B) all goodwill and unpaid/and/or uncalled capital of the company;. C) all stocks shares and securities and documents evidencing title to or the right to possession of any property at any time deposited with ultimate invoice finance limited and the property mentioned in such documents;. D) all intellectual property now owned or at any time hereafter to be owned by the company;. E) any debt (purchased or purported to be purchased by ultimate invoice finance limited pursuant to the factoring agreement between ultimate invoice finance limited and the company), of which the ownership fails to vest absolutely and effectively in ultimate invoice finance limited for any reason, together with the related rights pertaining to such debt and the proceeds of it;. F) all amounts of indebtedness now or at any time hereafter owing or becoming due to the company on any account whatsoever (together with their proceeds and the related rights pertaining thereto);. G) all amounts now or hereafter owing or becoming due to the company by ultimate invoice finance limited including (but not limited to) any amount retained by ultimate invoice finance limited under any provision of the factoring agreement between ultimate invoice finance limited and the company. 2. by way of first floating charge:. All undertaking and all the property rights and assets of the company, whosoever and wheresoever, both present and future, including the company's stock in trade and its uncalled capital and the proceeds of such property rights and assets other than such of the same as shall for the time being be subject to the fixed charge created by clause 3.1 of the debenture.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Ultimate Invoice Finance Limited
    Transaktionen
    • 21. Nov. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 06. März 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 24. Sept. 2014
    Geliefert am 26. Sept. 2014
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    33 st peters road, margate t/no K466570.
    Berechtigte Personen
    • Neil Brooks
    Transaktionen
    • 26. Sept. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 13. März 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 17. Feb. 2014
    Geliefert am 18. Feb. 2014
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transaktionen
    • 18. Feb. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 13. März 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    All assets debenture
    Erstellt am 22. März 2004
    Geliefert am 03. Apr. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 03. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 18. Jan. 2002
    Geliefert am 05. Feb. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. März 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 10. Juli 2000
    Geliefert am 22. Juli 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 07. Juni 2000
    Geliefert am 09. Juni 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and whether arising under the agreement or otherwise
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge all of the company's invoices which do not vest absolutely and effectively in alf under the agreement and all book and other debts; floating charge all proceeds of other debts.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited Trading as Alex.Lawrie Factors
    Transaktionen
    • 09. Juni 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat ISOCO 1 LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    24. Feb. 2017Beginn der Verwaltung
    22. Aug. 2018Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Isobel Brett
    21 Highfield Road
    DA1 2JS Dartford
    Kent
    Praktiker
    21 Highfield Road
    DA1 2JS Dartford
    Kent

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0