MISYS INTERNATIONAL BANKING SYSTEMS (CIS) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MISYS INTERNATIONAL BANKING SYSTEMS (CIS) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03259295 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MISYS INTERNATIONAL BANKING SYSTEMS (CIS) LIMITED?
- Sonstige Software-Veröffentlichungen (58290) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich MISYS INTERNATIONAL BANKING SYSTEMS (CIS) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | One Kingdom Street Paddington W2 6BL London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MISYS INTERNATIONAL BANKING SYSTEMS (CIS) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL (CIS) LIMITED | 24. Dez. 1996 | 24. Dez. 1996 |
| ENGAGEBEAM LIMITED | 04. Okt. 1996 | 04. Okt. 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MISYS INTERNATIONAL BANKING SYSTEMS (CIS) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Mai 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MISYS INTERNATIONAL BANKING SYSTEMS (CIS) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Change of details for a person with significant control | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 31. Mai 2017
| 8 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 31 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Johannes Jacobus Olivier am 01. Dez. 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Mai 2016 | 13 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 60 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Sept. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||||||||||||||
Ernennung von Thomas Edward Kilroy als Direktor am 21. März 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Mai 2015 | 10 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||||||||||||||
legacy | 60 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Ernennung von Mr Johannes Jacobus Olivier als Direktor am 20. Juli 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Paul Woodward als Geschäftsführer am 20. Juli 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2014 | 13 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Ernennung von Mr Andrew Paul Woodward als Direktor am 05. Sept. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Sanjay Patel als Geschäftsführer am 28. Aug. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MISYS INTERNATIONAL BANKING SYSTEMS (CIS) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARKEN, John Van | Geschäftsführer | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | United Kingdom | American | 183654340001 | |||||||||
| HOMER, Thomas Edward Timothy | Geschäftsführer | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | England | British | 146605570001 | |||||||||
| KILROY, Thomas Edward | Geschäftsführer | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street | England | British | 166580200001 | |||||||||
| OLIVIER, Johannes Jacobus | Geschäftsführer | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | England | South African | 199516920002 | |||||||||
| BRAIN, Sarah Elizabeth Highton | Sekretär | Portwood Cottage The Street Warninglid RH17 5SZ Haywards Heath No 1 West Sussex England | 146638030001 | |||||||||||
| DURRANT, Zoe Vivienne | Sekretär | Beehive Cottage Radford Road, Rous Lench WR11 4UL Evesham Worcestershire | British | 68141090001 | ||||||||||
| GRAY, Elizabeth Andrea | Sekretär | 16 Broad Street CV34 4LT Warwick Warwickshire | British | 98035800001 | ||||||||||
| HAM, Richard Laurence | Sekretär | High Street Welford-On-Avon CV37 8EA Stratford-Upon-Avon Avon House Warwickshire England | British | 136433670001 | ||||||||||
| WATERS, Paul Christopher | Sekretär | The Old Vicarage High Street B50 4BQ Bidford On Avon Warwickshire | British | 67435560001 | ||||||||||
| WILSON, Kevin Michael | Sekretär | Strauss Road Chiswick W4 1DL London 10 | Other | 138835080001 | ||||||||||
| MISYS CORPORATE SECRETARY LIMITED | Sekretär | Kingdom Street Paddington W2 6BL London One United Kingdom |
| 170449330001 | ||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| COLLINS, Elizabeth Mary | Geschäftsführer | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | United Kingdom | British | 180406780001 | |||||||||
| DARBY, Andrew Hamish | Geschäftsführer | 9a Oatlands Chase KT13 9RF Weybridge Surrey | England | British | 114800800001 | |||||||||
| FARRIMOND, Nicholas Brian | Geschäftsführer | The Avenue Watford WD17 4NU Hertfordshire 51 England England | England | British | 75357260001 | |||||||||
| GRAHAM, Ross King | Geschäftsführer | Stourton Farm House Stourton CV36 5HG Shipston On Stour Warwickshire | United Kingdom | British | 61733920001 | |||||||||
| HAWKES, Joanna Marageret | Geschäftsführer | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | England | British | 136214800001 | |||||||||
| HELSBY, Frank Peter | Geschäftsführer | 27 Park Green Great Bookham KT23 3NL Leatherhead Surrey | England | British | 34237710003 | |||||||||
| HUGHES, Kevin Gerard | Geschäftsführer | 31 Cromwell Avenue Billericay CM12 OAG Essex | United Kingdom | British | 173214140001 | |||||||||
| PATEL, Bijal Mahendra | Geschäftsführer | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street | United Kingdom | British | 161424380001 | |||||||||
| PATEL, Sanjay Surendra | Geschäftsführer | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | United Kingdom | British | 147221810001 | |||||||||
| SUSSENS, John Gilbert | Geschäftsführer | Blythe House 10 Grange Road Bidford On Avon B50 4BY Alcester Warwickshire | England | British | 1442450002 | |||||||||
| TAYLOR, David | Geschäftsführer | Honeywood Atch Lench Road Church Lench WR11 4UG Evesham Worcestershire | British | 1439590001 | ||||||||||
| WHITE, Andrew Ian | Geschäftsführer | Hillcott Perrotts Brook GL7 7BN Cirencester Glos | United Kingdom | British | 93602410001 | |||||||||
| WOODWARD, Andrew Paul | Geschäftsführer | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | United Kingdom | British | 100885620001 | |||||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 | |||||||||||
| MISYS CORPORATE DIRECTOR LIMITED | Geschäftsführer | Kingdom Street Paddington W2 6BL London 1 | 82836510002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MISYS INTERNATIONAL BANKING SYSTEMS (CIS) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misys Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat MISYS INTERNATIONAL BANKING SYSTEMS (CIS) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A deed of admission to an omnibus letter of set-off (olso) dated 3RD july 1995 | Erstellt am 19. Dez. 2006 Geliefert am 29. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995 | Erstellt am 17. Sept. 2003 Geliefert am 01. Okt. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3 july 1995 | Erstellt am 11. Sept. 2003 Geliefert am 24. Sept. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 and | Erstellt am 29. Juli 2003 Geliefert am 12. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995 (the letter) | Erstellt am 23. Okt. 2002 Geliefert am 13. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 and | Erstellt am 09. Mai 2002 Geliefert am 25. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future accounts of the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0