QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED

QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameQUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03260375
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED?

    • Sonstige menschliche Gesundheitsaktivitäten (86900) / Gesundheits- und Sozialwesen

    Wo befindet sich QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Asticus Building 2nd Floor
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    HUDSON HOMES LIMITED08. Okt. 199608. Okt. 1996

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2017

    Welche sind die letzten Einreichungen für QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 11. Sept. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    2 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 11. Sept. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    2 SeitenAA

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    2 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 11. Sept. 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital01. Okt. 2015

    Kapitalaufstellung am 01. Okt. 2015

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Sanne Group Secretaries (Uk) Limited am 20. Juli 2015

    1 SeitenCH04

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    2 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Sanne Group 2nd Floor Pollen House 10 Cork Street London W1S 3NP zum Asticus Building 2nd Floor 21 Palmer Street London SW1H 0AD am 05. Aug. 2015

    1 SeitenAD01

    Ernennung von Jonathan David Farkas als Direktor am 27. Jan. 2015

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Mathieu Streiff als Geschäftsführer am 27. Jan. 2015

    1 SeitenTM01

    legacy

    28 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT1

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE1

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital18. Sept. 2014

    Kapitalaufstellung am 18. Sept. 2014

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Mathieu Streiff am 31. März 2014

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Sanne Group Secretaries (Uk) Limited am 31. März 2014

    1 SeitenCH04

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Sanne Group 1 Berkeley Street London W1J 8DJ United Kingdom* am 07. Apr. 2014

    1 SeitenAD01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. März 2014 bis 31. Dez. 2013

    3 SeitenAA01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2013

    10 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Sept. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital07. Okt. 2013

    Kapitalaufstellung am 07. Okt. 2013

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Wer sind die Geschäftsführer von QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SANNE GROUP SECRETARIES (UK) LIMITED
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    England
    Sekretär
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    England
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer8334728
    175738460001
    FARKAS, Jonathan David
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    Geschäftsführer
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    LuxembourgAmerican193539990001
    SAUNDERS, Clare
    The Pound
    67 High Street
    SN6 8AW Shrivenham Swindon
    Wiltshire
    Sekretär
    The Pound
    67 High Street
    SN6 8AW Shrivenham Swindon
    Wiltshire
    British155548170001
    SCHOFIELD, Nigel Bennett
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Sekretär
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    British52338530002
    CO FORM (SECRETARIES) LIMITED
    Dominions House North
    Queen Street
    CF1 4AR Cardiff
    Bevollmächtigter Sekretär
    Dominions House North
    Queen Street
    CF1 4AR Cardiff
    900001870001
    HILL, Peter Martin
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Geschäftsführer
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    EnglandBritish130983750002
    JEFFERY, Paul Anthony Keith
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Geschäftsführer
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    United KingdomBritish119804090001
    SAUNDERS, Clare
    The Pound
    67 High Street
    SN6 8AW Shrivenham Swindon
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    The Pound
    67 High Street
    SN6 8AW Shrivenham Swindon
    Wiltshire
    EnglandBritish155548170001
    SAUNDERS, Peter Michael, Cllr
    67 High Street
    Shrivenham
    SN6 8AW Swindon
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    67 High Street
    Shrivenham
    SN6 8AW Swindon
    Wiltshire
    EnglandBritish65642810001
    SCHOFIELD, Nigel Bennett
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Geschäftsführer
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    United KingdomBritish148139420001
    STREIFF, Mathieu Bernard
    c/o Sanne Group
    10 Cork Street
    W1S 3NP London
    2nd Floor Pollen House
    Geschäftsführer
    c/o Sanne Group
    10 Cork Street
    W1S 3NP London
    2nd Floor Pollen House
    United StatesAmerican200529310001
    TRANTER, Wilfred
    Wayside
    Townsend Road
    SN6 8HR Shrivenham
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Wayside
    Townsend Road
    SN6 8HR Shrivenham
    Oxfordshire
    British18193010002
    WHITE, Ian James
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Geschäftsführer
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    EnglandBritish133383410003
    CO FORM (NOMINEES) LIMITED
    Dominions House North
    Queen Street
    CF1 4AR Cardiff
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Dominions House North
    Queen Street
    CF1 4AR Cardiff
    900001860001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    England
    06. Apr. 2016
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RegistrierungslandUk
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer04258255
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.

    Hat QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 28. Juli 2010
    Geliefert am 06. Aug. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee and to all or any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. For details of property charged please refer to form MG01.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transaktionen
    • 06. Aug. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 19. Sept. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 16. Nov. 2007
    Geliefert am 27. Nov. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee for the secured finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Ascot house 28 wingrove road fenham,34 and 36 wingrove road newcastle upon tynet/no's TY221509 and TY52154,bradbury house bradbury house new street braintree t/no ESX647090, cheshire house 22 st mary's road ashton on mersey t/no GM54543 (for details of further properties charged. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 27. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Sept. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Juni 2007
    Geliefert am 19. Juni 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H miranda house high street wooton bassett swindon wiltshire t/no WT139689. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Sept. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Juni 2007
    Geliefert am 19. Juni 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H the old presbytery high street wooton bassett swindon wiltshire t/no WT131191. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Sept. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 13. Juni 2007
    Geliefert am 19. Juni 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 19. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Sept. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage
    Erstellt am 03. Nov. 1999
    Geliefert am 24. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property known as the old presbytery 77 high street, wootton bassett wilts title number WT131191. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Apr. 1997
    Geliefert am 19. Apr. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a miranda house nursing home high street wootton bassett t/no: WT139689.
    Berechtigte Personen
    • Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 03. Apr. 1997
    Geliefert am 19. Apr. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0