QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03260375 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED?
- Sonstige menschliche Gesundheitsaktivitäten (86900) / Gesundheits- und Sozialwesen
Wo befindet sich QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Asticus Building 2nd Floor 21 Palmer Street SW1H 0AD London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| HUDSON HOMES LIMITED | 08. Okt. 1996 | 08. Okt. 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Sept. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Sept. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Sept. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Sanne Group Secretaries (Uk) Limited am 20. Juli 2015 | 1 Seiten | CH04 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Sanne Group 2nd Floor Pollen House 10 Cork Street London W1S 3NP zum Asticus Building 2nd Floor 21 Palmer Street London SW1H 0AD am 05. Aug. 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung von Jonathan David Farkas als Direktor am 27. Jan. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mathieu Streiff als Geschäftsführer am 27. Jan. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
legacy | 28 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE1 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Mathieu Streiff am 31. März 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Sanne Group Secretaries (Uk) Limited am 31. März 2014 | 1 Seiten | CH04 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Sanne Group 1 Berkeley Street London W1J 8DJ United Kingdom* am 07. Apr. 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. März 2014 bis 31. Dez. 2013 | 3 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2013 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Sept. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANNE GROUP SECRETARIES (UK) LIMITED | Sekretär | 21 Palmer Street SW1H 0AD London Asticus Building 2nd Floor England |
| 175738460001 | ||||||||||
| FARKAS, Jonathan David | Geschäftsführer | 21 Palmer Street SW1H 0AD London Asticus Building 2nd Floor | Luxembourg | American | 193539990001 | |||||||||
| SAUNDERS, Clare | Sekretär | The Pound 67 High Street SN6 8AW Shrivenham Swindon Wiltshire | British | 155548170001 | ||||||||||
| SCHOFIELD, Nigel Bennett | Sekretär | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | British | 52338530002 | ||||||||||
| CO FORM (SECRETARIES) LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Dominions House North Queen Street CF1 4AR Cardiff | 900001870001 | |||||||||||
| HILL, Peter Martin | Geschäftsführer | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | England | British | 130983750002 | |||||||||
| JEFFERY, Paul Anthony Keith | Geschäftsführer | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | United Kingdom | British | 119804090001 | |||||||||
| SAUNDERS, Clare | Geschäftsführer | The Pound 67 High Street SN6 8AW Shrivenham Swindon Wiltshire | England | British | 155548170001 | |||||||||
| SAUNDERS, Peter Michael, Cllr | Geschäftsführer | 67 High Street Shrivenham SN6 8AW Swindon Wiltshire | England | British | 65642810001 | |||||||||
| SCHOFIELD, Nigel Bennett | Geschäftsführer | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | United Kingdom | British | 148139420001 | |||||||||
| STREIFF, Mathieu Bernard | Geschäftsführer | c/o Sanne Group 10 Cork Street W1S 3NP London 2nd Floor Pollen House | United States | American | 200529310001 | |||||||||
| TRANTER, Wilfred | Geschäftsführer | Wayside Townsend Road SN6 8HR Shrivenham Oxfordshire | British | 18193010002 | ||||||||||
| WHITE, Ian James | Geschäftsführer | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | England | British | 133383410003 | |||||||||
| CO FORM (NOMINEES) LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Dominions House North Queen Street CF1 4AR Cardiff | 900001860001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ga Hc Reit Ch Uk Senior Housing Portfolio Limted | 06. Apr. 2016 | 21 Palmer Street SW1H 0AD London Asticus Building 2nd Floor England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 28. Juli 2010 Geliefert am 06. Aug. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each chargor to the chargee and to all or any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. For details of property charged please refer to form MG01. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. Nov. 2007 Geliefert am 27. Nov. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargors to the chargee for the secured finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Ascot house 28 wingrove road fenham,34 and 36 wingrove road newcastle upon tynet/no's TY221509 and TY52154,bradbury house bradbury house new street braintree t/no ESX647090, cheshire house 22 st mary's road ashton on mersey t/no GM54543 (for details of further properties charged. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 13. Juni 2007 Geliefert am 19. Juni 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H miranda house high street wooton bassett swindon wiltshire t/no WT139689. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 13. Juni 2007 Geliefert am 19. Juni 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H the old presbytery high street wooton bassett swindon wiltshire t/no WT131191. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 13. Juni 2007 Geliefert am 19. Juni 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 03. Nov. 1999 Geliefert am 24. Nov. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The freehold property known as the old presbytery 77 high street, wootton bassett wilts title number WT131191. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 03. Apr. 1997 Geliefert am 19. Apr. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a miranda house nursing home high street wootton bassett t/no: WT139689. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 03. Apr. 1997 Geliefert am 19. Apr. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0