WINDOWSTYLE UK LTD
Überblick
| Unternehmensname | WINDOWSTYLE UK LTD |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03263838 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WINDOWSTYLE UK LTD?
- Sonstige Herstellung n.e.c. (32990) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich WINDOWSTYLE UK LTD?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Style House Eldon Place BD1 3AZ Bradford West Yorkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WINDOWSTYLE UK LTD?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 02. Jan. 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für WINDOWSTYLE UK LTD?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Okt. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Phil Joyner als Direktor am 31. März 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Michelle Williams als Direktor am 31. März 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mike Gallacher als Geschäftsführer am 14. Dez. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Okt. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 02. Jan. 2022 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Okt. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Okt. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Okt. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Okt. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen John Birmingham als Geschäftsführer am 13. Sept. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Rob Neale als Direktor am 16. Juli 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Mike Gallacher als Direktor am 01. Mai 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Okt. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Stephen John Birmingham am 01. Dez. 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Okt. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von WINDOWSTYLE UK LTD?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHORT, Richard Kenneth | Sekretär | Style House Eldon Place BD1 3AZ Bradford West Yorkshire | British | 119070280001 | ||||||
| JOYNER, Phil | Geschäftsführer | Style House Eldon Place BD1 3AZ Bradford West Yorkshire | England | British | 307741130001 | |||||
| NEALE, Rob James | Geschäftsführer | Style House Eldon Place BD1 3AZ Bradford West Yorkshire | United Kingdom | British | 249525240001 | |||||
| WILLIAMS, Michelle | Geschäftsführer | Style House Eldon Place BD1 3AZ Bradford West Yorkshire | England | British | 307659100001 | |||||
| FAULKNER, Paul Thomas | Sekretär | 13 Bentley Road Chapeltown S35 1RH Sheffield South Yorkshire | British | 58322510001 | ||||||
| HAIGH, Peter | Sekretär | 16 Marldon Road Northowram HX3 7BP Halifax West Yorkshire | British | 50352100001 | ||||||
| HARTLEY, Christine Diane | Sekretär | 3 Rowland Road Wilthorpe S75 2PQ Barnsley South Yorkshire | British | 58322480001 | ||||||
| SELLERS, Martin John | Sekretär | Sonora Nook The Hawthorns 415 Penistone Road Shelley HD8 8JB Huddersfield West Yorkshire | British | 53020080001 | ||||||
| THOMPSON, Allan | Sekretär | 2 Fairways Upper Hopton WF14 8PY Mirfield West Yorkshire | British | 126826560001 | ||||||
| THURLEY, Ian Michael | Sekretär | Highview 36a Richmond Road Upton WF9 1HP Pontefract West Yorkshire | British | 125719050001 | ||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 | |||||||
| BIRMINGHAM, Stephen John | Geschäftsführer | Style House Eldon Place BD1 3AZ Bradford West Yorkshire | England | British | 80742950003 | |||||
| BIRMINGHAM, Stephen John | Geschäftsführer | 31 Holcombe Lee Holcombe Brook BL0 9QR Ramsbottom Bury Lancashire | British | 80742950001 | ||||||
| FAULKNER, Paul Thomas | Geschäftsführer | 13 Bentley Road Chapeltown S35 1RH Sheffield South Yorkshire | England | British | 58322510001 | |||||
| GALLACHER, Mike | Geschäftsführer | Style House Eldon Place BD1 3AZ Bradford West Yorkshire | England | British | 196594210001 | |||||
| GRIFFIN, Gary | Geschäftsführer | 115 Worsbrough Road Birdwell S70 5RF Barnsley South Yorkshire | England | British | 69888600001 | |||||
| LILBURN, Nicholas Thomas | Geschäftsführer | 25 Eastfield Crescent Woodlesford LS26 8SG Leeds West Yorkshire | England | British | 77833360002 | |||||
| LOCKWOOD, Edward | Geschäftsführer | The Vicarage, Haigh Lane Hoylandswaine S30 6JJ Sheffield South Yorkshire | British | 78166500002 | ||||||
| MCCAMBRIDGE, Brendan | Geschäftsführer | 19 Chepston Place BA14 9TA Trowbridge Wiltshire | England | British | 94063860001 | |||||
| MISRA, Mitu | Geschäftsführer | Fountain Street M2 2FB Manchester Fountain Court 68 England | England | Indian | 70784770001 | |||||
| ROSS, John Stewart | Geschäftsführer | Becca Hall Becca Park LS25 3BQ Leeds West Yorkshire | Uk | British | 112102800001 | |||||
| ROSS, John Stewart | Geschäftsführer | Becca Hall Becca Park LS25 3BQ Leeds West Yorkshire | Uk | British | 112102800001 | |||||
| YOUEL, Alan | Geschäftsführer | Beacon Lodge Beacon Hill Silkstone Common S75 4QE Barnsley South Yorkshire | British | 6856400001 | ||||||
| COMBINED NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NA London | 900000090001 | |||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei WINDOWSTYLE UK LTD?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Style Group Uk Limited | 07. Apr. 2016 | Eldon Place BD1 3AZ Bradford Style House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat WINDOWSTYLE UK LTD Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal mortgage | Erstellt am 02. Feb. 2010 Geliefert am 09. Feb. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H land k/a land at valley road and land on the north west side of station road wombwell barnsley t/no SYK533000 and SYK533166 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 20. Mai 2005 Geliefert am 28. Mai 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Apr. 2001 Geliefert am 24. Apr. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Okt. 1998 Geliefert am 16. Okt. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0