J.N. & L. FORSTER LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | J.N. & L. FORSTER LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03264039 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von J.N. & L. FORSTER LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich J.N. & L. FORSTER LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 Thane Road West NG2 3AA Nottingham |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von J.N. & L. FORSTER LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für J.N. & L. FORSTER LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2010 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Okt. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von David Charles Geoffrey Foster als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von David Charles Geoffrey Foster als Sekretär | 3 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Muller als Sekretär | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Patricia Kennerley als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Aylward als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Muller als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Christopher James Giles als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Francis Muller am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Christopher David Aylward am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Mark Francis Muller am 01. Okt. 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Okt. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Francis Muller am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Christopher David Aylward am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Mark Francis Muller am 01. Okt. 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 28. März 2008 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 225 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von J.N. & L. FORSTER LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOSTER, David Charles Geoffrey | Sekretär | 1 Thane Road West NG90 1BS Nottingham D90 | British | 150401750001 | ||||||
| FOSTER, David Charles Geoffrey | Geschäftsführer | 1 Thane Road West NG90 1BS Nottingham D90 | England | British | 52040210004 | |||||
| GILES, Christopher James | Geschäftsführer | 1 Thane Road West NG90 1BS Nottingham D90 | England | British | 149729660001 | |||||
| FORSTER, Jeffrey Nicholas | Sekretär | Highfield House Bolton CA16 6AW Appleby In Westmorland Cumbria | British | 156136450001 | ||||||
| MULLER, Mark Francis, Mr. | Sekretär | Thane Road West NG2 3AA Nottingham 1 | British | 63620010002 | ||||||
| TEMPLE SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001120001 | |||||||
| AYLWARD, Christopher David | Geschäftsführer | Thane Road West NG2 3AA Nottingham 1 | United Kingdom | British | 59741430002 | |||||
| FORSTER, Jeffrey Nicholas | Geschäftsführer | Highfield House Bolton CA16 6AW Appleby In Westmorland Cumbria | England | British | 156136450001 | |||||
| FORSTER, Lorraine | Geschäftsführer | Highfield House Bolton CA16 6AW Appleby In Westmorland Cumbria | England | British | 156136610001 | |||||
| KENNERLEY, Patricia Diane | Geschäftsführer | D90 1 Thane Road West NG90 1BS Nottingham | Great Britain | British | 110727230002 | |||||
| MULLER, Mark Francis, Mr. | Geschäftsführer | Thane Road West NG2 3AA Nottingham 1 | United Kingdom | British | 63620010002 | |||||
| COMPANY DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001110001 |
Hat J.N. & L. FORSTER LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 04. Okt. 2006 Geliefert am 05. Okt. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Property k/a 6 petteril bank, carlisle, 56 king st, aspatria, 6/8 main street, frizington, springwell house, aspatria, 48/50 main st, sedbergh. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage deed | Erstellt am 01. Nov. 2004 Geliefert am 09. Nov. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Property 46/50 main street knights sedbergh t/n CU86624 and CU36548. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage deed | Erstellt am 06. Sept. 2002 Geliefert am 24. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The l/h property known as or being 41 main street sedbergh cumbria. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 01. Juli 1998 Geliefert am 18. Juli 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a 6 petteril bank road harraby cumbria. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 03. Feb. 1997 Geliefert am 08. Feb. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a springwell house, aspatria cumbria. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 03. Feb. 1997 Geliefert am 08. Feb. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a 6/7/8 main street frizington cumbria. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 03. Feb. 1997 Geliefert am 08. Feb. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 03. Feb. 1997 Geliefert am 08. Feb. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a 56 king street aspatria cumbria. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0