DEVELOPMENT SECURITIES (NO.1) LIMITED

DEVELOPMENT SECURITIES (NO.1) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameDEVELOPMENT SECURITIES (NO.1) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03266774
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von DEVELOPMENT SECURITIES (NO.1) LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich DEVELOPMENT SECURITIES (NO.1) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    7a Howick Place
    SW1P 1DZ London
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von DEVELOPMENT SECURITIES (NO.1) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    HACKREMCO (NO.1182) LIMITED22. Okt. 199622. Okt. 1996

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DEVELOPMENT SECURITIES (NO.1) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis28. Feb. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für DEVELOPMENT SECURITIES (NO.1) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    4 SeitenDS01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 28. Feb. 2019 bis 31. März 2019

    1 SeitenAA01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 28. Feb. 2018

    17 SeitenAA

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 28. Feb. 2017

    19 SeitenAA

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss

    3 SeitenAC92

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    4 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 25. Nov. 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 29. Feb. 2016

    23 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Charles Julian Barwick als Geschäftsführer am 07. Sept. 2016

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Michael Henry Marx als Geschäftsführer am 29. Feb. 2016

    1 SeitenTM01

    Erfüllung der Belastung 18 vollständig

    5 SeitenMR04

    Ein Teil des Eigentums oder Unternehmens wurde entlassen und ist nicht mehr Teil der Belastung 19

    6 SeitenMR05

    Ernennung von Mr Richard Upton als Direktor am 08. Feb. 2016

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Bradley David Cassels als Direktor am 08. Feb. 2016

    2 SeitenAP01

    Ernennung von James Simon Hesketh als Direktor am 29. Jan. 2016

    2 SeitenAP01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Charles Julian Barwick am 09. Nov. 2015

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Michael Henry Marx am 09. Nov. 2015

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Matthew Simon Weiner am 09. Nov. 2015

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Marcus Owen Shepherd am 09. Nov. 2015

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr Chris Barton am 09. Nov. 2015

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Development Securities Estates Plc am 11. Nov. 2015

    1 SeitenCH02

    Wer sind die Geschäftsführer von DEVELOPMENT SECURITIES (NO.1) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BARTON, Chris
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Sekretär
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    193874050001
    CASSELS, Bradley David
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    United KingdomBritish130724370005
    HESKETH, James Simon
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    United KingdomBritish124650200001
    SHEPHERD, Marcus Owen
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    United KingdomBritish41925000005
    UPTON, Richard
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    EnglandBritish204950320001
    WEINER, Matthew Simon
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    United KingdomBritish72888710002
    DEVELOPMENT SECURITIES ESTATES PLC
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer657311
    53858600001
    LANES, Stephen Alec
    Thorpe House 105 Mycenae Road
    Blackheath
    SE3 7RX London
    Sekretär
    Thorpe House 105 Mycenae Road
    Blackheath
    SE3 7RX London
    British1266100003
    RATSEY, Helen Maria
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    England
    Sekretär
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    England
    British158461000001
    SHEPHERD, Marcus Owen
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    England
    England
    Sekretär
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    England
    England
    190660010001
    HACKWOOD SECRETARIES LIMITED
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    900004790001
    BARWICK, Charles Julian
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    EnglandBritish3818640003
    BODIE, Anthony Ellyah
    112 Clifton Hill
    NW8 OJS London
    Geschäftsführer
    112 Clifton Hill
    NW8 OJS London
    British34902790002
    CORDEREY, Neil Sinclair
    5 Barton Road
    AL4 8QG Wheathampstead
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    5 Barton Road
    AL4 8QG Wheathampstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritish74024640001
    MARX, Michael Henry
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    United KingdomBritish35019090001
    PROTHERO, Graham
    Bracken Lane
    RH20 3HR Storrington
    Three Gables
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Bracken Lane
    RH20 3HR Storrington
    Three Gables
    West Sussex
    United KingdomBritish134427450001
    ROSE, William Marcus Henderson
    11 Patten Road
    SW18 3RH London
    Geschäftsführer
    11 Patten Road
    SW18 3RH London
    United KingdomBritish9127840001
    HACKWOOD DIRECTORS LIMITED
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    900004840001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei DEVELOPMENT SECURITIES (NO.1) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformPublic Limited Company
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageUnited Kingdom
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer00701787
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat DEVELOPMENT SECURITIES (NO.1) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of legal charge
    Erstellt am 12. März 2010
    Geliefert am 25. März 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from development securities PLC and any company and any subsidiary to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a the former pricebusters building, bank hey street, blackpool t/no LA507736 and f/h land k/a millenium house being land on the south side of chester road, bretton, broughton, flintshire t/no WA727235 including all buildings, erections and fixtures and fittings, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Aviva Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 25. März 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 01. März 2016Ein Teil des Grundstücks oder Unternehmens wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    Deed of assignment
    Erstellt am 12. März 2010
    Geliefert am 25. März 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from development securities PLC and any company and any subsidiary to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the rights, titles, benefits and interests of the company to all moneys (the assigned rights) see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Aviva Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 25. März 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 01. März 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 07. März 2006
    Geliefert am 15. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. März 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 17. März 2005
    Geliefert am 18. März 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    F/Hold property known as carpetworld unit,caroline st,wigan WN3 4EL; GM173947. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. März 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 17. März 2005
    Geliefert am 18. März 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    F/Hold and l/hold property known as carpetworld unit,adlington house,adlington st,burnley BB1 2SQ; LA484720 and LA656398. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. März 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Sept. 2003
    Geliefert am 20. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land and buildings on the east side of north phoebe street, salford, greater manchester t/no. GM428830. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. März 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Sept. 2003
    Geliefert am 20. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land and buildings on the south side of etruria road, hanley, stoke on trent t/no. SF243934. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. März 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 27. Juni 2003
    Geliefert am 01. Juli 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 01. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. März 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Juni 2003
    Geliefert am 01. Juli 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a 71 laird street birkenhead t/n MS30500 MS230696 and CH86975. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 01. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. März 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Juni 2003
    Geliefert am 01. Juli 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a land and buildings on the south side of sylvester street sheffield t/n syk 249823 and all estate right and interest in the land k/a porter brook bridge sheffield. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 01. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. März 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Juni 2003
    Geliefert am 01. Juli 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a west side of caroline street wigan t/n GM173947. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 01. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. März 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Juni 2003
    Geliefert am 01. Juli 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a land on the east side of macclesfield road hazel grove cum bramhall stockport t/n GM220630. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 01. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. März 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Juni 2003
    Geliefert am 01. Juli 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The part f/h and part l/h property k/a oldham road newton heath manchester t/n LA180101 (f/h) and GM309140 (l/h). Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 01. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. März 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Juni 2003
    Geliefert am 01. Juli 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a land on the south side of parr street st helens merseyside t/n MS469558. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 01. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. März 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Dez. 2002
    Geliefert am 31. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The freehold property known as millennium house chester road bretton chester title number WA727235.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 31. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. März 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 14 january 1999 and
    Erstellt am 23. Dez. 1998
    Geliefert am 15. Jan. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in the terms of a personal bond by the company dated 23 december 1998
    Kurze Angaben
    Property on the west ide of old bridge street ayr consisting of ground floor, first floor and second floor premises k/a 9 and 9 and a half old bridge street ayr.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. März 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 14 january 1999 and
    Erstellt am 23. Dez. 1998
    Geliefert am 15. Jan. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in the terms of a personal bond by the company dated 23 december 1998
    Kurze Angaben
    48 and 48A frederick street edinburgh.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Jan. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Dez. 1998
    Geliefert am 06. Jan. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Leasehold property k/a 22-24 watergate row chester t/n CH182372 & CH182373, freehold property k/a 7-9 & 11-13 market street holyhead t/n WA701328 for further properties charged please refer to schedule attatched to form 395. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. März 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0