MANDARIN ORIENTAL HYDE PARK (INVESTMENT) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | MANDARIN ORIENTAL HYDE PARK (INVESTMENT) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aktiv |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03269393 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MANDARIN ORIENTAL HYDE PARK (INVESTMENT) LIMITED?
- Hotels und ähnliche Unterkünfte (55100) / Gastgewerbe
Wo befindet sich MANDARIN ORIENTAL HYDE PARK (INVESTMENT) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 5th Floor 110 High Holborn WC1V 6JS London England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MANDARIN ORIENTAL HYDE PARK (INVESTMENT) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
MANDARIN ORIENTAL HYDE PARK LIMITED | 12. Nov. 1996 | 12. Nov. 1996 |
HACKREMCO (NO.1180) LIMITED | 25. Okt. 1996 | 25. Okt. 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MANDARIN ORIENTAL HYDE PARK (INVESTMENT) LIMITED?
Überfällig | Nein |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2024 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Sept. 2025 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2023 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für MANDARIN ORIENTAL HYDE PARK (INVESTMENT) LIMITED?
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 01. Mai 2025 |
---|---|
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 15. Mai 2025 |
Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 01. Mai 2024 |
Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für MANDARIN ORIENTAL HYDE PARK (INVESTMENT) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Mai 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2023 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 032693930006 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 032693930007 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Mai 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Mai 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alexander Nicholas Kwok Wing Li als Geschäftsführer am 28. Feb. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Zweite Einreichung für die Abberufung von Jillian Margaret Kluge als Geschäftsführer | 5 Seiten | RP04TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Torsten Magne Van Dullemen als Direktor am 01. Nov. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Lesley Amanda Hyndman als Geschäftsführer am 01. Nov. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Alasdair David Murray als Direktor am 01. Okt. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Syung Hwa Matthew David Bishop als Direktor am 01. Sept. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Alexander Nicholas Kwok Wing Li am 13. Sept. 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Craig Alan Beattie als Geschäftsführer am 31. Aug. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jillian Margaret Kluge als Geschäftsführer am 31. Juli 2021 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Mai 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mandarin Oriental Hotel Group Limited als Sekretär am 14. Dez. 2020 | 2 Seiten | AP04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 3 Lombard Street London EC3V 9AQ zum 5th Floor 110 High Holborn London WC1V 6JS am 14. Dez. 2020 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MANDARIN ORIENTAL HYDE PARK (INVESTMENT) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDARIN ORIENTAL HOTEL GROUP LIMITED | Sekretär | 18 Westlands Road Quarry Bay 8th Floor, One Island East, Taikoo Place Hong Kong |
| 282355550001 | ||||||||||||||
BISHOP, Syung Hwa Matthew David | Geschäftsführer | 110 High Holborn WC1V 6JS London 5th Floor England | Hong Kong | British | Chief Financial Officer | 287182380001 | ||||||||||||
MURRAY, Alasdair David | Geschäftsführer | 110 High Holborn WC1V 6JS London 5th Floor England | Switzerland | New Zealander | Legal Counsel | 287919950001 | ||||||||||||
VAN DULLEMEN, Torsten Magne | Geschäftsführer | 110 High Holborn WC1V 6JS London 5th Floor England | United Kingdom | Dutch | General Manager | 289385540001 | ||||||||||||
HACKWOOD SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | One Silk Street EC2Y 8HQ London | 900004790001 | |||||||||||||||
MATHESON & CO LIMITED | Sekretär | Lombard Street EC3V 9AQ London 3 United Kingdom |
| 1947590001 | ||||||||||||||
BEATTIE, Craig Alan | Geschäftsführer | 110 High Holborn WC1V 6JS London 5th Floor England | Hong Kong | British | Chief Financial Officer | 252438700002 | ||||||||||||
BEATTIE, Craig Alan | Geschäftsführer | 3 Lombard Street London EC3V 9AQ | China | British | Company Director | 152706450001 | ||||||||||||
BURNETT, Stuart Mathieson | Geschäftsführer | 3rd Floor Apt 32 Raceview Mansions 46 Stubbs Road FOREIGN Hong Kong | British | Finance Director | 70352440001 | |||||||||||||
CHECOURY, Michel | Geschäftsführer | Rue Rousseau, 38 1201 Geneva Mandarin Oriental Sa Switzerland | France | French | Director Of Finance | 134705220011 | ||||||||||||
CHECOURY, Michel | Geschäftsführer | 11 Holland Park Avenue W11 3RL London 35 Linton House | French | Director Of Finance | 134705220001 | |||||||||||||
COWERN, Peter Richard | Geschäftsführer | Apart 2307 Towers 1 & 2 Hong Kong Parkview Suite 88 Tai Tam Reservoir FOREIGN Hong Kong Hong Kong | Canadian | Finance Director | 66346490001 | |||||||||||||
DICKIE, Charles Stuart | Geschäftsführer | 3 Lombard Street London EC3V 9AQ | Hong Kong | British | Company Director | 121061750002 | ||||||||||||
DODDS, Richard John | Geschäftsführer | 127 Queen Alexandra Mansions Tonbridge Street WC1H 9DW London | Uk | British | Company Director | 120077640001 | ||||||||||||
HALE, Jacqueline Frances | Geschäftsführer | Old Police House St Mary Bourne SP11 6AR Andover Hampshire | British | Financial Controller | 50948520001 | |||||||||||||
HYNDMAN, Lesley Amanda | Geschäftsführer | 110 High Holborn WC1V 6JS London 5th Floor England | Scotland | British | Hotelier | 248735020001 | ||||||||||||
KLUGE, Jillian Margaret | Geschäftsführer | 110 High Holborn WC1V 6JS London 5th Floor England | England | British | Group Director Of Brand Communications | 252462890001 | ||||||||||||
LAMBERT, Liam Roderick | Geschäftsführer | 2 Macaulay Road Clapham Common SW4 0QX London | Canadian/Irish | Hotelier | 68214150002 | |||||||||||||
LI, Alexander Nicholas Kwok Wing | Geschäftsführer | 110 High Holborn WC1V 6JS London 5th Floor England | Hong Kong | British | Director | 248733350002 | ||||||||||||
MARES, Christoph | Geschäftsführer | 3 Lombard Street London EC3V 9AQ | China | German | Company Director | 120638730008 | ||||||||||||
PROTTO, Philippe Alexandre | Geschäftsführer | 3 Lombard Street London EC3V 9AQ | England | French | Regional Director Of Finance | 185795350002 | ||||||||||||
RILEY, Robert Earl | Geschäftsführer | 15 Shek O Hong Kong | United States Citizen | Hotel Executive | 50375490001 | |||||||||||||
ROSS, Hamish Andrew | Geschäftsführer | 3 Lombard Street London EC3V 9AQ | Hong Kong | Australian | Financial Director | 176831550007 | ||||||||||||
WILLIAMS, Brian Edward | Geschäftsführer | 5 Holmbush Road SW15 3LE London | England | British | Hotel General Manager | 110602640001 | ||||||||||||
WITT, John Raymond | Geschäftsführer | 1/F, 10 Tungshan Terrace FOREIGN Hong Kong China | Canadian | Director Of Corporate Finance | 60769460004 | |||||||||||||
HACKWOOD DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | One Silk Street EC2Y 8HQ London | 900004840001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MANDARIN ORIENTAL HYDE PARK (INVESTMENT) LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandarin Oriental International Limited | 06. Apr. 2016 | Reid Street Hamilton 33-35 Bermuda | Nein | ||||
| |||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat MANDARIN ORIENTAL HYDE PARK (INVESTMENT) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 15. Apr. 2019 Geliefert am 18. Apr. 2019 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung N/A. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 29. Mai 2014 Geliefert am 09. Juni 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Subordination and assignment deed | Erstellt am 29. Juni 2007 Geliefert am 12. Juli 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All its rights title and interest in and to the present and future junior finance documents and all moneys payable to the junior creditor. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Share charge | Erstellt am 29. Juni 2007 Geliefert am 12. Juli 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First fixed charge all its present and future shares and dividends. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A second supplemental deed dated 24 november 1999 to a composite guarantee and debenture dated 19 november 1996 as amended by a supplemental deed dated 06 april 1998 | Erstellt am 24. Nov. 1999 Geliefert am 13. Dez. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys obligations and liabilities owing or incurred to the chargee by the company and mandarin oriental hyde park limited and any other subsidiary | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental deed | Erstellt am 06. Apr. 1998 Geliefert am 20. Apr. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The supplemental deed is supplemental to a composite guarantee and debenture dated 19 november 1996 between the same parties (the "principal deed") whereby the charging companies guaranteed to the lender inter alia the payment by inter alia each other charging company of all moneys due owing or incurred by such company to the lender which guarantee would have extended to the performance by the parent (as defined) of its obligations under certain documentation including without limitation the loan agreement (as defined) | |
Kurze Angaben The supplemental deed states that the principal deed remains in full force and effect as security for all the secured obligations as increased and varied in the case of the said loan agreement in the manner referred to above. Short particulars of all the property mortgaged or charged by the principal deed were set out in a form 395 dated 3 december 1996. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 19. Nov. 1996 Geliefert am 04. Dez. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and all monies due or to become due from each other charging company (as defined) and any other present or future subsidiary of the parent or of any charging company (except any obligations or liabilities of such other charging company or subsidiary as guarantor for the charging company concerned) to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The hyde park hotel, 66 knightsbridge london, city of westminster t/no: ngl 1563. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0