METAVIEW PROPERTIES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | METAVIEW PROPERTIES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03270129 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von METAVIEW PROPERTIES LIMITED?
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich METAVIEW PROPERTIES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 3rd Floor, The Quay 30 Channel Way Ocean Village SO14 3TG Southampton England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von METAVIEW PROPERTIES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Okt. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für METAVIEW PROPERTIES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Okt. 2016 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Okt. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom New Orchard House 14 Cumberland Place Southampton SO15 2BG zum 3rd Floor, the Quay 30 Channel Way Ocean Village Southampton SO14 3TG am 02. Nov. 2016 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Okt. 2015 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Okt. 2014 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Okt. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom New Orchard House 14 Cumberland Place Southampton SO14 2BG England zum New Orchard House 14 Cumberland Place Southampton SO15 2BG am 07. Okt. 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Orchard House 51-67 Commercial Road Southampton Hampshire SO15 1GG zum New Orchard House 14 Cumberland Place Southampton SO14 2BG am 29. Sept. 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 3 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 3 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 3 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 1 vollständig | 3 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 3 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 3 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 3 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Okt. 2013 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Okt. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Okt. 2012 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Okt. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Orchard House 51-67 Commercial Road Southampton Hampshire SO42 7QW England* am 21. Nov. 2012 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von METAVIEW PROPERTIES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARLING, Peter | Sekretär | 30 Channel Way Ocean Village SO14 3TG Southampton 3rd Floor, The Quay England | 156853950001 | |||||||
| LAKE, Margaret Ann | Geschäftsführer | 2 Bedwell Close Rownhams SO16 8FT Southampton Hampshire | England | British | 59397270001 | |||||
| LAKE, Kenneth Toby | Sekretär | Zion Hill Farmhouse Goodacre Drive Chandlers Ford SO53 4LG Eastleigh Hampshire | British | 76426540002 | ||||||
| ROWLES, Maurice John | Sekretär | Bramdene Main Road Dibden SO45 5TD Southampton Hampshire | British | 17409420001 | ||||||
| SANDERS, Jane | Sekretär | 43 Suffolk Avenue SO15 5EF Southampton Hampshire | British | 74037330001 | ||||||
| STARLING, Peter David | Sekretär | 94 New Forest Drive SO42 7QW Brockenhurst Hampshire | British | 66644630001 | ||||||
| ASHCROFT CAMERON SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 4 Rivers House Fentiman Walk SG14 1DB Hertford Hertfordshire | 900004530001 | |||||||
| SMS ACCOUNTING LIMITED | Sekretär | First Floor 349-353 Shirley Road Shirley SO15 3JD Southampton | 87693600001 | |||||||
| EAGLE, Nicolas Julian | Geschäftsführer | Oak House Gazing Lane SO51 6BS West Wellow Hampshire | United Kingdom | British | 81595390002 | |||||
| ASHCROFT CAMERON NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 4 Rivers House Fentiman Walk SG14 1DB Hertford Hertfordshire | 900004520001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei METAVIEW PROPERTIES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Mrs Margaret Ann Lake | 06. Apr. 2016 | 30 Channel Way Ocean Village SO14 3TG Southampton 3rd Floor, The Quay England | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Hat METAVIEW PROPERTIES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Erstellt am 07. Aug. 2009 Geliefert am 14. Aug. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben 62 hamlet way gosport, t/no.HP159063 and 257 market street eastleigh t/no.HP577125. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 10. Okt. 2003 Geliefert am 17. Okt. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben F/H property 62 hamlet way, gosport t/n HP159063. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 10. Okt. 2003 Geliefert am 17. Okt. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben F/H property 257 market street, eastleigh, hampshire t/n HP577125. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage deed | Erstellt am 01. Nov. 2002 Geliefert am 05. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The leasehold property known as 41 the oaks bitterne southampton t/n HP267195. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage deed | Erstellt am 03. Okt. 2002 Geliefert am 16. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 01. Mai 2000 Geliefert am 18. Mai 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £102,000 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben All f/h and l/h properties of the company including all plant and machinery and fixtures and fittings thereon together with all unpaid book debts owing to the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. Mai 2000 Geliefert am 18. Mai 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £102,000 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben 62 hamlet way gosport hampshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. Mai 2000 Geliefert am 18. Mai 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £102,000 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben 257 market street eastliegh hampshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 22. Juli 1997 Geliefert am 23. Juli 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a 62 hamlet way elson gosport hampshire t/no.HP159063. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0