CALATHERM LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCALATHERM LIMITED
    UnternehmensstatusAktiv
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03270136
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenNein
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CALATHERM LIMITED?

    • Herstellung von sonstigen Teilen und Zubehör für Kraftfahrzeuge (29320) / Verarbeitendes Gewerbe

    Wo befindet sich CALATHERM LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    19a Sandy Way
    Amington Industrial Estate
    B77 4DS Tamworth
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CALATHERM LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ELITE KL LIMITED10. Apr. 201410. Apr. 2014
    ELITE AUTOMOTIVE SYSTEMS LIMITED08. Nov. 199608. Nov. 1996
    BLACKBELL LIMITED28. Okt. 199628. Okt. 1996

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CALATHERM LIMITED?

    ÜberfälligNein
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. Dez. 2025
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am30. Sept. 2026
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2024

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für CALATHERM LIMITED?

    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis21. Aug. 2026
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung04. Sept. 2026
    Letzte Bestätigungsbescheinigung
    Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis21. Aug. 2025
    ÜberfälligNein

    Welche sind die letzten Einreichungen für CALATHERM LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Ernennung von Mr Sotos Constantinides als Direktor am 24. Nov. 2025

    2 SeitenAP01

    Bestätigungserklärung erstellt am 21. Aug. 2025 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Change of details for Griffin Newco Limited as a person with significant control on 21. Aug. 2025

    2 SeitenPSC05

    Jahresabschluss für ein mittelständisches Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2024

    21 SeitenAA

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed elite kl LIMITED\certificate issued on 03/03/25
    3 SeitenCERTNM
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name03. März 2025

    Namensänderung durch Beschluss

    NM01
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 27. Feb. 2025

    RES15

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 19a Amington Industrial Estate Tamworth B77 4DS England zum 19a Sandy Way Amington Industrial Estate Tamworth B77 4DS am 19. Feb. 2025

    1 SeitenAD01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Gary Wilson am 17. Feb. 2025

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mrs Carol Maund am 17. Feb. 2025

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Holmes am 17. Feb. 2025

    2 SeitenCH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Elite House Sandy Way Amington Industrial Estate Tamworth Staffordshire B77 4DS zum 19a Amington Industrial Estate Tamworth B77 4DS am 17. Feb. 2025

    1 SeitenAD01

    Bestätigungserklärung erstellt am 21. Aug. 2024 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2023

    23 SeitenAA

    Eintragung der Belastung 032701360009, erstellt am 29. Feb. 2024

    46 SeitenMR01

    Gesellschaftsvertrag und Satzung

    37 SeitenMA

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Eintragung der Belastung 032701360007, erstellt am 29. Feb. 2024

    46 SeitenMR01

    Eintragung der Belastung 032701360008, erstellt am 29. Feb. 2024

    47 SeitenMR01

    Notification of Griffin Newco Limited as a person with significant control on 29. Feb. 2024

    2 SeitenPSC02

    Cessation of Elbit Systems Uk Limited as a person with significant control on 29. Feb. 2024

    1 SeitenPSC07

    Änderung der Details des Direktors für Ms Carol Maund am 29. Feb. 2024

    2 SeitenCH01

    Ernennung von Mr Mark Holmes als Direktor am 29. Feb. 2024

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Ms Carol Maund als Direktor am 29. Feb. 2024

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Gary Wilson als Direktor am 29. Feb. 2024

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Reuven Shahar als Geschäftsführer am 29. Feb. 2024

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Aharon Arotchas als Geschäftsführer am 29. Feb. 2024

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von CALATHERM LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CONSTANTINIDES, Sotos
    Sandy Way
    Amington Industrial Estate
    B77 4DS Tamworth
    19a
    England
    Geschäftsführer
    Sandy Way
    Amington Industrial Estate
    B77 4DS Tamworth
    19a
    England
    United KingdomBritish124622460002
    HOLMES, Mark
    Sandy Way
    Amington Industrial Estate
    B77 4DS Tamworth
    19a
    England
    Geschäftsführer
    Sandy Way
    Amington Industrial Estate
    B77 4DS Tamworth
    19a
    England
    EnglandBritish320195450001
    MAUND, Carol
    Sandy Way
    Amington Industrial Estate
    B77 4DS Tamworth
    19a
    England
    Geschäftsführer
    Sandy Way
    Amington Industrial Estate
    B77 4DS Tamworth
    19a
    England
    EnglandBritish320195320001
    WILSON, Gary
    Sandy Way
    Amington Industrial Estate
    B77 4DS Tamworth
    19a
    England
    Geschäftsführer
    Sandy Way
    Amington Industrial Estate
    B77 4DS Tamworth
    19a
    England
    EnglandBritish320195580001
    DENYER, Raymond Philip
    11 Stuarts Green
    DY9 0XR Stourbridge
    West Midlands
    Sekretär
    11 Stuarts Green
    DY9 0XR Stourbridge
    West Midlands
    British40676090002
    GARBETT, Edwina Ann
    40 Kent Avenue
    Fazeley
    B78 3XR Tamworth
    Staffordshire
    Sekretär
    40 Kent Avenue
    Fazeley
    B78 3XR Tamworth
    Staffordshire
    British52716150001
    ASHCROFT CAMERON SECRETARIES LIMITED
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    Bevollmächtigter Sekretär
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    900004530001
    APPLEGATE, Richard Arthur David
    Elite House Sandy Way
    Amington Industrial Estate
    B77 4DS Tamworth
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Elite House Sandy Way
    Amington Industrial Estate
    B77 4DS Tamworth
    Staffordshire
    EnglandBritish163944330003
    AROTCHAS, Aharon
    Elite House Sandy Way
    Amington Industrial Estate
    B77 4DS Tamworth
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Elite House Sandy Way
    Amington Industrial Estate
    B77 4DS Tamworth
    Staffordshire
    IsraelIsraeli311970100001
    CASPI, Chaim
    Elite House Sandy Way
    Amington Industrial Estate
    B77 4DS Tamworth
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Elite House Sandy Way
    Amington Industrial Estate
    B77 4DS Tamworth
    Staffordshire
    IsraelIsraeli159374880001
    COHEN, Boaz
    Elite House Sandy Way
    Amington Industrial Estate
    B77 4DS Tamworth
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Elite House Sandy Way
    Amington Industrial Estate
    B77 4DS Tamworth
    Staffordshire
    IsraelIsraeli211056790001
    HADAYO, Abraham Aviram
    Elite House Sandy Way
    Amington Industrial Estate
    B77 4DS Tamworth
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Elite House Sandy Way
    Amington Industrial Estate
    B77 4DS Tamworth
    Staffordshire
    IsraelIsraeli159374870001
    KAGAN, Kobi, Dr
    Elite House Sandy Way
    Amington Industrial Estate
    B77 4DS Tamworth
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Elite House Sandy Way
    Amington Industrial Estate
    B77 4DS Tamworth
    Staffordshire
    IsraelIsraeli159374840001
    MILLER, Paul Raymond
    Brindles Barn
    Church Road
    WS14 0NG Shenstone
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Brindles Barn
    Church Road
    WS14 0NG Shenstone
    Staffordshire
    UkBritish43376050002
    NIR, Amir
    Elite House Sandy Way
    Amington Industrial Estate
    B77 4DS Tamworth
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Elite House Sandy Way
    Amington Industrial Estate
    B77 4DS Tamworth
    Staffordshire
    IsraelIsraeli159374920001
    ORENSHTEIN, Oded
    Elite House Sandy Way
    Amington Industrial Estate
    B77 4DS Tamworth
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Elite House Sandy Way
    Amington Industrial Estate
    B77 4DS Tamworth
    Staffordshire
    IsraelIsraeli207606880001
    SHAHAR, Reuven
    Elite House Sandy Way
    Amington Industrial Estate
    B77 4DS Tamworth
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Elite House Sandy Way
    Amington Industrial Estate
    B77 4DS Tamworth
    Staffordshire
    IsraelIsraeli297670830001
    SHALOM, Lilach Broks
    Ramat Hasharon
    Elbit Land
    Israel
    Geschäftsführer
    Ramat Hasharon
    Elbit Land
    Israel
    IsraelIsraeli297717730001
    SHARON, Israel
    Sandy Way
    Amington Industrial Estate
    B77 4DS Tamworth
    Elite House
    Staffordshire
    England
    Geschäftsführer
    Sandy Way
    Amington Industrial Estate
    B77 4DS Tamworth
    Elite House
    Staffordshire
    England
    IsraelIsraeli184537730001
    WOLFF, Dan
    Elite House Sandy Way
    Amington Industrial Estate
    B77 4DS Tamworth
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Elite House Sandy Way
    Amington Industrial Estate
    B77 4DS Tamworth
    Staffordshire
    IsraelIsraeli159374930001
    ASHCROFT CAMERON NOMINEES LIMITED
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    900004520001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CALATHERM LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Sandy Way
    Amington Industrial Estate
    B77 4DS Tamworth
    19a
    Staffordshire
    United Kingdom
    29. Feb. 2024
    Sandy Way
    Amington Industrial Estate
    B77 4DS Tamworth
    19a
    Staffordshire
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageEnglish Law
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer15239861
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.
    Kingsway
    WC2B 6SR London
    77
    England
    06. Apr. 2016
    Kingsway
    WC2B 6SR London
    77
    England
    Ja
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England And Wales)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer05241591
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0