MERRYCHEF HOLDINGS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MERRYCHEF HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03274972 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MERRYCHEF HOLDINGS LIMITED?
- Tätigkeit anderer Holdinggesellschaften n.n.a. (64209) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich MERRYCHEF HOLDINGS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | St Anns Wharf 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MERRYCHEF HOLDINGS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BLAKEDEW TWENTY FOUR LIMITED | 07. Nov. 1996 | 07. Nov. 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MERRYCHEF HOLDINGS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MERRYCHEF HOLDINGS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael James Kachmer als Geschäftsführer am 03. Apr. 2013 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Graham Philip Brisley Veal am 30. Sept. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kevin Blades als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Maurice Delon Jones am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Michael James Kachmer am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Graham Philip Brisley Veal am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Prima Secretary Limited am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH04 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Thomas Doerr als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Adrian David Gray als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MERRYCHEF HOLDINGS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMA SECRETARY LIMITED | Sekretär | 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Ann's Wharf United Kingdom |
| 94529700001 | ||||||||||
| GRAY, Adrian David | Geschäftsführer | Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Ann's Wharf 112 | United Kingdom | British | 146072380001 | |||||||||
| JONES, Maurice Delon | Geschäftsführer | 1650 Westbury Court Manitowoc Wisconsin 54220 Usa | Usa | American | 134328700001 | |||||||||
| VEAL, Graham Philip Brisley | Geschäftsführer | 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Ann's Wharf United Kingdom | England | British | 43215170003 | |||||||||
| HOOPER, David Ross | Sekretär | Mill Road SL7 1UA Marlow 6 Millbank Buckinghamshire | British | 17023730002 | ||||||||||
| KEYWOOD, Joyce Rosalyn | Sekretär | 22 York Gardens KT12 3EP Walton On Thames Surrey | British | 50397900001 | ||||||||||
| BLAKELAW SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Harbour Court Compass Road North Harbour PO6 4ST Portsmouth Hampshire | 900001990001 | |||||||||||
| AIREY, Andrew Robert | Geschäftsführer | Heywood House Mark Way GU7 2BB Godalming Surrey | British | 70927410002 | ||||||||||
| BARKER, Simon Charles | Geschäftsführer | Timberdene Cottage Chalk Road, Ifold RH14 0UD Billingshurst West Sussex | British | 113730600001 | ||||||||||
| BLADES, Kevin Nicholas | Geschäftsführer | Hatch Farm Bossingham Road CT4 6AQ Stelling Minnis Kent | England | British | 79449700002 | |||||||||
| BRAY, Kenneth Ivor | Geschäftsführer | Nether Hall Main Street, Denton NG32 1JR Grantham Lincolnshire | British | 45153770002 | ||||||||||
| DOERR, Thomas | Geschäftsführer | Hillborow Road KT10 9UD Esher Newleigh House Surrey | United States | 134081280001 | ||||||||||
| FINDLER, Jonathan Paul | Geschäftsführer | Westwood House Heathfield Avenue SL5 0AL Ascot Berkshire | British | 45532880003 | ||||||||||
| GALE, Robert Geoffrey | Geschäftsführer | Hurlands Lane GU8 4NT Dunsfold Hurst Hill Lodge Surrey Uk | United Kingdom | British | 138375430001 | |||||||||
| HAMPTON, Mark Richard | Geschäftsführer | Bankside 5 Parsonage Road HP8 4JW Chalfont St. Giles Buckinghamshire | British | 80408810001 | ||||||||||
| HOOPER, David Ross | Geschäftsführer | Mill Road SL7 1UA Marlow 6 Millbank Buckinghamshire | British | 17023730002 | ||||||||||
| HOOPER, David Ross | Geschäftsführer | Long Mynd Burchetts Green Lane Burchetts Green SL6 3QW Maidenhead Berkshire | British | 17023730001 | ||||||||||
| HOUGHTON, Reece | Geschäftsführer | 5 St Barbe Close SO51 5RH Romsey Hampshire | British | 27953100001 | ||||||||||
| JELLY, Aubrey Bruce, Mr. | Geschäftsführer | Wychanger GU5 9QQ Shere Surrey | United Kingdom | British | 82764370003 | |||||||||
| KACHMER, Michael James | Geschäftsführer | Marywood Trail 60187 Wheaton 14 Illinois United States | United States | American | 136570610001 | |||||||||
| KEYWOOD, Joyce Rosalyn | Geschäftsführer | 22 York Gardens KT12 3EP Walton On Thames Surrey | British | 50397900001 | ||||||||||
| LEE, Peter Allan | Geschäftsführer | 4 Clifton Park Road Caversham RG4 7PD Reading Berkshire | British | 81538800001 | ||||||||||
| MILLER, Stuart Purves | Geschäftsführer | 1 Meadway Park SL9 7NN Gerards Cross Buckinghamshire | England | British | 98718070001 | |||||||||
| ROLT, Jeremy Charles | Geschäftsführer | 4 Sycamore Close St Ippolyts SG4 7SN Hitchin Hertfordshire | England | British | 35716980001 | |||||||||
| THORNEYWORK, Nigel | Geschäftsführer | Malden Dale Bailes Lane Normandy GU3 2AX Guildford Surrey | England | British | 9730100001 | |||||||||
| TONER, Robert Anthony | Geschäftsführer | 29 Lamb Close WD25 0TB Watford Hertfordshire | United Kingdom | British | 70516300002 | |||||||||
| WHITELING, Mark Argent | Geschäftsführer | The Treehouse 85 Elmfield Avenue TW11 8BX Teddington Middlesex | England | British | 101297630001 | |||||||||
| WOODHEAD, Graham Geoffrey | Geschäftsführer | Hammer Cottage RH5 6QX Abinger Hammer Surrey | United Kingdom | British | 2703560002 | |||||||||
| BLAKELAW DIRECTOR SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Harbour Court Compass Road North Harbour PO6 4ST Portsmouth Hampshire | 900001980001 |
Hat MERRYCHEF HOLDINGS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Second supplemental security agreement, which is supplemental to the security agreement, dated 20TH november 2001 as supplemented by a supplemental security agreement dated 20TH february 2002 | Erstellt am 11. Apr. 2002 Geliefert am 25. Apr. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The f/h property 13 lower bristol road bath t/n AV190171, l/h property 42 west street gravesend t/n K702855, f/h property 51 bath street gravensend t/n K709759 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental security agreement between, amongst others, the charging company and the facility agent which is supplemental to the security agreement dated 20 november 2001 between the chargors and the facility agent | Erstellt am 20. Feb. 2002 Geliefert am 08. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due of each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement between the chargor and the royal bank of scotland the (facility agent) | Erstellt am 20. Nov. 2001 Geliefert am 30. Nov. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each chargor to any finance party under each finance document | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment of keyman life policies | Erstellt am 28. Juli 1997 Geliefert am 05. Aug. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All indebtedness,liabilities and obligations due or to become due by any group company (as defined) to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The assignor assigned and agreed to assign with full title guarantee to the bank the policies and all monies including bonuses accrued or which may at any time after 28 july 1997 accrue which shall become payable thereunder and the benefit of all powers and remedies for enforcing the same absolutely as a continuing security to the bank.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 20. Dez. 1996 Geliefert am 03. Jan. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 20. Dez. 1996 Geliefert am 27. Dez. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/Hold premises at station road west,ashvale,aldershot,hampshire GU12 5XA; see form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0