PUNCH TAVERNS (PMG) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PUNCH TAVERNS (PMG) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03276276 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PUNCH TAVERNS (PMG) LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich PUNCH TAVERNS (PMG) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Jubilee House Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Staffordshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PUNCH TAVERNS (PMG) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| PUBMASTER GROUP LIMITED | 06. Feb. 1997 | 06. Feb. 1997 |
| BERRYBOSS LIMITED | 05. Nov. 1996 | 05. Nov. 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PUNCH TAVERNS (PMG) LIMITED?
| Überfällig | Nein |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 11. Aug. 2026 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 11. Mai 2027 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 10. Aug. 2025 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für PUNCH TAVERNS (PMG) LIMITED?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 21. Dez. 2026 |
|---|---|
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 04. Jan. 2027 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 21. Dez. 2025 |
| Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für PUNCH TAVERNS (PMG) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 10. Aug. 2025 | 3 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Dez. 2025 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Stephen Peter Dando am 03. Dez. 2025 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 11. Aug. 2024 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Dez. 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 13. Aug. 2023 | 22 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Dez. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 14. Aug. 2022 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Dez. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Francesca Appleby als Sekretär am 22. Aug. 2022 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 15. Aug. 2021 | 21 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Dez. 2021 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 34 Seiten | MA | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Notification of Punch Pubs & Co Limited as a person with significant control on 01. Juli 2021 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||||||
Cessation of Punch Pubs Holdings Limited as a person with significant control on 01. Juli 2021 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 01. Juli 2021
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Notification of Punch Pubs Holdings Limited as a person with significant control on 23. Juni 2021 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||||||
Cessation of Punch Pubs Group Limited as a person with significant control on 23. Juni 2021 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||||||
Notification of Punch Pubs Group Limited as a person with significant control on 23. Juni 2021 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||||||
Cessation of Punch Taverns Limited as a person with significant control on 23. Juni 2021 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PUNCH TAVERNS (PMG) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASHFORTH, Edward Michael | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131551840002 | |||||
| DANDO, Stephen Peter | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 152083750013 | |||||
| APPLEBY, Francesca | Sekretär | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 191628770001 | |||||||
| CROSS, Anthony | Sekretär | 38 The Lane Spinkhill S21 3YF Sheffield South Yorkshire | British | 1812400001 | ||||||
| DEEGAN, Jayne | Sekretär | 5 Hardstruggle Row Eskdaleside YO22 5ET Sleights North Yorkshire | British | 94870790001 | ||||||
| HARRIS, Claire Louise | Sekretär | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 175489440001 | |||||||
| MILLER, Nicola Jane | Sekretär | 27 Hillston Close TS26 0PE Hartlepool | British | 95390370001 | ||||||
| RUDD, Susan Clare | Sekretär | 17 Thacker Drive WS13 6NS Lichfield Staffordshire | British | 81789210004 | ||||||
| STEWART, Claire Susan | Sekretär | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | British | 117216940001 | ||||||
| TYRRELL, Helen | Sekretär | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 161798590001 | |||||||
| LEGIBUS SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 200 Aldersgate Street EC1A 4JJ London | 38508390001 | |||||||
| ARMSTRONG, Michael John | Geschäftsführer | Hunters Gate 56 Palace Road HG4 1HA Ripon North Yorkshire | British | 16410290001 | ||||||
| ASHTON, Kay Elizabeth | Geschäftsführer | 21 Thornhill Square N1 1BQ London | British | 52743960001 | ||||||
| BASHFORTH, Edward Michael | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131551840002 | |||||
| BRACKENBURY, Frederick Edwin John Gedge | Geschäftsführer | 8 Moore Street SW3 2QN London | United Kingdom | British | 53682420001 | |||||
| CROSS, Anthony | Geschäftsführer | 38 The Lane Spinkhill S21 3YF Sheffield South Yorkshire | England | British | 1812400001 | |||||
| DUTTON, Philip | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 141395280001 | |||||
| GIBBONS, Alastair Ronald | Geschäftsführer | 1 Hazlewell Road SW15 6LU London | United Kingdom | British | 43372750001 | |||||
| GRIFFITHS, Neil Robert Ceidrych | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | England | British | 55975990001 | |||||
| GWILLIAM, Vincent Mitchell Lovell | Geschäftsführer | 20 Flanchford Road Stamford Brook W12 9ND London | British | 26448890001 | ||||||
| HATTON, David Sean Michael | Geschäftsführer | 82 Sundridge Avenue BR7 5LU Chislehurst Kent | England | British | 26394710001 | |||||
| LEWIS, John Henry James, Sir | Geschäftsführer | Shute House Donhead St Mary SP7 9DG Shaftesbury Dorset | England | British | 35546800004 | |||||
| MCDONALD, Robert James | Geschäftsführer | 46 Wentworth Drive WS14 9HN Lichfield Staffordshire | British | 42019620001 | ||||||
| PRESTON, Neil David | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 63043630002 | |||||
| SAMMONS, Nigel Anthony | Geschäftsführer | Hutton Lodge Hutton Magna DL11 7HQ Richmond North Yorkshire | British | 59809250002 | ||||||
| SANDS, John Robert | Geschäftsführer | 11 Falcon Lane Norton TS20 1LS Stockton On Tees | United Kingdom | British | 141561650001 | |||||
| THORLEY, Giles Alexander | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 81928120002 | |||||
| TURNBULL, Ronald | Geschäftsführer | 16 Willow Road Dairy Lane Estate DH4 5QF Houghton Le Spring Tyne & Wear | British | 63331360001 | ||||||
| VAUGHAN, Alfred Joseph | Geschäftsführer | The Linn 100 Eglington Road KA22 8NN Ardrossan North Ayreshire | United Kingdom | British | 90987590002 | |||||
| WHITESIDE, Roger Mark | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | England | British | 128819260001 | |||||
| WOMACK, Martin | Geschäftsführer | 13 Hastings Place FY8 5LZ Lytham St Annes Lancashire | British | 106124020001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PUNCH TAVERNS (PMG) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punch Pubs & Co Limited | 01. Juli 2021 | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Punch Pubs Holdings Limited | 23. Juni 2021 | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Punch Taverns Limited | 23. Juni 2021 | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Punch Pubs Group Limited | 23. Juni 2021 | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Punch Pubs & Co Limited | 06. Apr. 2016 | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0