BARLEY SHOWHOMES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BARLEY SHOWHOMES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03278299 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BARLEY SHOWHOMES LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich BARLEY SHOWHOMES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 20 Berkeley Square London W1J 6LH |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BARLEY SHOWHOMES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| TRUSHELFCO (NO.2206) LIMITED | 14. Nov. 1996 | 14. Nov. 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BARLEY SHOWHOMES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BARLEY SHOWHOMES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nicholas Salisbury als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Fiona Freeman als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für James Bernard Sunley am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Richard Evans am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Rory William Michael Gleeson am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Sunley Securities Limited am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BARLEY SHOWHOMES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNLEY SECURITIES LIMITED | Sekretär | Berkeley Square Mayfair W1J 6LH London 20 United Kingdom |
| 77371660001 | ||||||||||
| EVANS, Richard | Geschäftsführer | 20 Berkeley Square London W1J 6LH | United Kingdom | British | 99065600001 | |||||||||
| GLEESON, Rory William Michael | Geschäftsführer | 20 Berkeley Square W1J 6LH London | England | Irish | 104706720007 | |||||||||
| SUNLEY, James Bernard | Geschäftsführer | Berkeley Square W1J 6LH London 20 | England | British | 43436300006 | |||||||||
| DAY, Ann Elizabeth | Sekretär | 20 Baldwyns Park DA5 2BA Bexley Kent | British | 59224910003 | ||||||||||
| MILLGATE, Sean | Sekretär | 11 Bowmans Close BN44 3SR Steyning West Sussex | British | 26295060002 | ||||||||||
| PROUD, Christopher Wilfred Fredrick | Sekretär | 3 Tinkers Drive MK18 3RD Winslow Buckinghamshire | British | 41375220002 | ||||||||||
| ROWLEY, Paul | Sekretär | Copper Beech Holly Close RH12 4PA Horsham West Sussex | British | 89958260001 | ||||||||||
| STRACHAN, Sylvia Rose | Sekretär | 17 Mciver Close Felbridge RH19 2PN East Grinstead West Sussex | British | 57230090001 | ||||||||||
| SUNLEY SECURITIES LIMITED | Sekretär | 20 Berkeley Square Mayfair W1J 6LH London | 77371660001 | |||||||||||
| TRUSEC LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 35 Basinghall Street EC2V 5DB London | 900007200001 | |||||||||||
| DAY, Ann Elizabeth | Geschäftsführer | 20 Baldwyns Park DA5 2BA Bexley Kent | British | 59224910003 | ||||||||||
| FREEMAN, Fiona Lynne | Geschäftsführer | Churchill Place E14 5HP London 1 | United Kingdom | British | 137805060001 | |||||||||
| FREEMAN, Fiona Lynne | Geschäftsführer | 21 Fir Tree Close KT17 3LD Epsom Surrey | British | 73653530001 | ||||||||||
| MILLGATE, Sean | Geschäftsführer | 11 Bowmans Close BN44 3SR Steyning West Sussex | British | 26295060002 | ||||||||||
| PARR, Richard Charles Neale | Geschäftsführer | Forest View 19 Estcots Drive RH19 3DA East Grinstead West Sussex | England | British | 87872830001 | |||||||||
| PAYNE, Richard William Norris | Geschäftsführer | 1 Churchill Place E14 5HP London | United Kingdom | British | 77845170003 | |||||||||
| PROUD, Christopher Wilfred Fredrick | Geschäftsführer | 3 Tinkers Drive MK18 3RD Winslow Buckinghamshire | British | 41375220002 | ||||||||||
| REARDON, Pamela Mae | Geschäftsführer | 37 Thames Close KT16 8NQ Chertsey Surrey | British | 70841810001 | ||||||||||
| ROWE, Drusilla Charlotte Jane | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Flat E 13 Saint Georges Drive SW1V 4DJ London | British | 900010990001 | ||||||||||
| ROWLEY, Paul | Geschäftsführer | Copper Beech Holly Close RH12 4PA Horsham West Sussex | British | 89958260001 | ||||||||||
| SALISBURY, Nicholas William | Geschäftsführer | Barclays Bank Plc 1 Churchill Place E14 5HP London | United Kingdom | British | 4380320005 | |||||||||
| SPARROW, Derek Tuart | Geschäftsführer | 52 Brittany Road BN3 4PB Hove East Sussex | United Kingdom | British | 23780460003 | |||||||||
| TICE, Richard James Sunley | Geschäftsführer | Old Rectory Church Lane Lathbury MK16 8JY Newport Pagnell Buckinghamshire | United Kingdom | British | 151240670006 | |||||||||
| TINDALL, Terence William | Geschäftsführer | 19 Oak Tree Close GU25 4JF Virginia Water Surrey | England | British | 4380330001 | |||||||||
| TUCKER, Gary William | Geschäftsführer | 18 The Castle Holbrook RH12 5PX Horsham West Sussex | England | British | 82937600001 | |||||||||
| WIBLING, Andrew Charles | Geschäftsführer | Kilchurn Winterpit Lane RH13 6LZ Mannings Heath West Sussex | British | 74387530001 | ||||||||||
| ZUERCHER, Eleanor Jane | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 26 Springfield Road Linslade LU7 7QS Leighton Buzzard Bedfordshire | British | 900014530001 |
Hat BARLEY SHOWHOMES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 08. Aug. 2003 Geliefert am 11. Aug. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Plot 79 lacuna west malling kent part t/n K818481, plot 5 pavillions mumby road gosport hampshire part t/n HP583002 and plot 110 pavillions mumby road gosport hampshire part t/n HP583002. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Aug. 2003 Geliefert am 11. Aug. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Plot 79 lacuna west malling kent part t/n K818481, plot 5 pavillions mumby road gosport hampshire part t/n HP583002 and plot 110 pavillions mumby road gosport hampshire part t/n HP583002. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. Okt. 2002 Geliefert am 25. Okt. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Including (I) plot 1 whispers,broomhall road,woking,surrey; part t/no SY706197; (ii) plot 2 whispers,broomhall road,woking,surrey; part t/no SY706197; (iii) plot 3 whispers,broomhall road,woking,surrey; part t/no SY706197. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. Okt. 2002 Geliefert am 25. Okt. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Including (I) plot 1 whispers,broomhall road,woking,surrey; part t/no SY706197; (ii) plot 2 whispers,broomhall road,woking,surrey; part t/no SY706197; (iii) plot 3 whispers,broomhall road,woking,surrey; part t/no SY706197. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Okt. 2002 Geliefert am 25. Okt. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Plot 63 lacuna, discovery drive, kings hill, west malling, kent part of t/n K818481. Plot 17 borrerfields, henfield part of t/n WSX257853. Plot 18 borrerfields, henfield part of t/n WSX257853. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill and uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Okt. 2002 Geliefert am 25. Okt. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Plot 63 lacuna, discovery drive, kings hill, west malling, kent part of t/n K818481. Plot 17 borrerfields, henfield part of t/n WSX257853. Plot 18 borrerfields, henfield part of t/n WSX257853. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill and uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Sept. 2002 Geliefert am 07. Okt. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Plot 63 lacuna discovery drive kings hill west malling kent part t/n K818481, plot 17 borrerfields henfield part t/n WSX257853 and plot 18 borrerfields henfield part t/n WSX257853. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Sept. 2002 Geliefert am 07. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Plot 63 lacuna discovery drive kings hill west malling kent part t/n K818481, plot 17 borrerfields henfield part t/n WSX257853 and plot 18 borrerfields henfield part t/n WSX257853. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Dez. 2001 Geliefert am 08. Jan. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Dez. 2001 Geliefert am 08. Jan. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 29. Jan. 1999 Geliefert am 03. Feb. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 29. Jan. 1999 Geliefert am 03. Feb. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. Dez. 1996 Geliefert am 07. Jan. 1997 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. Dez. 1996 Geliefert am 07. Jan. 1997 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0