BARLEY SHOWHOMES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBARLEY SHOWHOMES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03278299
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BARLEY SHOWHOMES LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich BARLEY SHOWHOMES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    20 Berkeley Square
    London
    W1J 6LH
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BARLEY SHOWHOMES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    TRUSHELFCO (NO.2206) LIMITED14. Nov. 199614. Nov. 1996

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BARLEY SHOWHOMES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für BARLEY SHOWHOMES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 14. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital16. Nov. 2012

    Kapitalaufstellung am 16. Nov. 2012

    • Kapital: GBP 11
    SH01

    Jahresrückblick erstellt bis 14. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    12 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 14. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Nicholas Salisbury als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Fiona Freeman als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    12 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 14. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für James Bernard Sunley am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Richard Evans am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Rory William Michael Gleeson am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Sunley Securities Limited am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH04

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    13 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    5 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    10 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    10 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005

    10 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von BARLEY SHOWHOMES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SUNLEY SECURITIES LIMITED
    Berkeley Square
    Mayfair
    W1J 6LH London
    20
    United Kingdom
    Sekretär
    Berkeley Square
    Mayfair
    W1J 6LH London
    20
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer2262230
    77371660001
    EVANS, Richard
    20 Berkeley Square
    London
    W1J 6LH
    Geschäftsführer
    20 Berkeley Square
    London
    W1J 6LH
    United KingdomBritish99065600001
    GLEESON, Rory William Michael
    20 Berkeley Square
    W1J 6LH London
    Geschäftsführer
    20 Berkeley Square
    W1J 6LH London
    EnglandIrish104706720007
    SUNLEY, James Bernard
    Berkeley Square
    W1J 6LH London
    20
    Geschäftsführer
    Berkeley Square
    W1J 6LH London
    20
    EnglandBritish43436300006
    DAY, Ann Elizabeth
    20 Baldwyns Park
    DA5 2BA Bexley
    Kent
    Sekretär
    20 Baldwyns Park
    DA5 2BA Bexley
    Kent
    British59224910003
    MILLGATE, Sean
    11 Bowmans Close
    BN44 3SR Steyning
    West Sussex
    Sekretär
    11 Bowmans Close
    BN44 3SR Steyning
    West Sussex
    British26295060002
    PROUD, Christopher Wilfred Fredrick
    3 Tinkers Drive
    MK18 3RD Winslow
    Buckinghamshire
    Sekretär
    3 Tinkers Drive
    MK18 3RD Winslow
    Buckinghamshire
    British41375220002
    ROWLEY, Paul
    Copper Beech
    Holly Close
    RH12 4PA Horsham
    West Sussex
    Sekretär
    Copper Beech
    Holly Close
    RH12 4PA Horsham
    West Sussex
    British89958260001
    STRACHAN, Sylvia Rose
    17 Mciver Close
    Felbridge
    RH19 2PN East Grinstead
    West Sussex
    Sekretär
    17 Mciver Close
    Felbridge
    RH19 2PN East Grinstead
    West Sussex
    British57230090001
    SUNLEY SECURITIES LIMITED
    20 Berkeley Square
    Mayfair
    W1J 6LH London
    Sekretär
    20 Berkeley Square
    Mayfair
    W1J 6LH London
    77371660001
    TRUSEC LIMITED
    35 Basinghall Street
    EC2V 5DB London
    Bevollmächtigter Sekretär
    35 Basinghall Street
    EC2V 5DB London
    900007200001
    DAY, Ann Elizabeth
    20 Baldwyns Park
    DA5 2BA Bexley
    Kent
    Geschäftsführer
    20 Baldwyns Park
    DA5 2BA Bexley
    Kent
    British59224910003
    FREEMAN, Fiona Lynne
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    Geschäftsführer
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    United KingdomBritish137805060001
    FREEMAN, Fiona Lynne
    21 Fir Tree Close
    KT17 3LD Epsom
    Surrey
    Geschäftsführer
    21 Fir Tree Close
    KT17 3LD Epsom
    Surrey
    British73653530001
    MILLGATE, Sean
    11 Bowmans Close
    BN44 3SR Steyning
    West Sussex
    Geschäftsführer
    11 Bowmans Close
    BN44 3SR Steyning
    West Sussex
    British26295060002
    PARR, Richard Charles Neale
    Forest View
    19 Estcots Drive
    RH19 3DA East Grinstead
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Forest View
    19 Estcots Drive
    RH19 3DA East Grinstead
    West Sussex
    EnglandBritish87872830001
    PAYNE, Richard William Norris
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Geschäftsführer
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    United KingdomBritish77845170003
    PROUD, Christopher Wilfred Fredrick
    3 Tinkers Drive
    MK18 3RD Winslow
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    3 Tinkers Drive
    MK18 3RD Winslow
    Buckinghamshire
    British41375220002
    REARDON, Pamela Mae
    37 Thames Close
    KT16 8NQ Chertsey
    Surrey
    Geschäftsführer
    37 Thames Close
    KT16 8NQ Chertsey
    Surrey
    British70841810001
    ROWE, Drusilla Charlotte Jane
    Flat E
    13 Saint Georges Drive
    SW1V 4DJ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Flat E
    13 Saint Georges Drive
    SW1V 4DJ London
    British900010990001
    ROWLEY, Paul
    Copper Beech
    Holly Close
    RH12 4PA Horsham
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Copper Beech
    Holly Close
    RH12 4PA Horsham
    West Sussex
    British89958260001
    SALISBURY, Nicholas William
    Barclays Bank Plc
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Geschäftsführer
    Barclays Bank Plc
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    United KingdomBritish4380320005
    SPARROW, Derek Tuart
    52 Brittany Road
    BN3 4PB Hove
    East Sussex
    Geschäftsführer
    52 Brittany Road
    BN3 4PB Hove
    East Sussex
    United KingdomBritish23780460003
    TICE, Richard James Sunley
    Old Rectory
    Church Lane Lathbury
    MK16 8JY Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Old Rectory
    Church Lane Lathbury
    MK16 8JY Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish151240670006
    TINDALL, Terence William
    19 Oak Tree Close
    GU25 4JF Virginia Water
    Surrey
    Geschäftsführer
    19 Oak Tree Close
    GU25 4JF Virginia Water
    Surrey
    EnglandBritish4380330001
    TUCKER, Gary William
    18 The Castle
    Holbrook
    RH12 5PX Horsham
    West Sussex
    Geschäftsführer
    18 The Castle
    Holbrook
    RH12 5PX Horsham
    West Sussex
    EnglandBritish82937600001
    WIBLING, Andrew Charles
    Kilchurn
    Winterpit Lane
    RH13 6LZ Mannings Heath
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Kilchurn
    Winterpit Lane
    RH13 6LZ Mannings Heath
    West Sussex
    British74387530001
    ZUERCHER, Eleanor Jane
    26 Springfield Road
    Linslade
    LU7 7QS Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    26 Springfield Road
    Linslade
    LU7 7QS Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British900014530001

    Hat BARLEY SHOWHOMES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 08. Aug. 2003
    Geliefert am 11. Aug. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Plot 79 lacuna west malling kent part t/n K818481, plot 5 pavillions mumby road gosport hampshire part t/n HP583002 and plot 110 pavillions mumby road gosport hampshire part t/n HP583002. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Sunley Properties Limited
    Transaktionen
    • 11. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 08. Aug. 2003
    Geliefert am 11. Aug. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Plot 79 lacuna west malling kent part t/n K818481, plot 5 pavillions mumby road gosport hampshire part t/n HP583002 and plot 110 pavillions mumby road gosport hampshire part t/n HP583002. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 24. Okt. 2002
    Geliefert am 25. Okt. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Including (I) plot 1 whispers,broomhall road,woking,surrey; part t/no SY706197; (ii) plot 2 whispers,broomhall road,woking,surrey; part t/no SY706197; (iii) plot 3 whispers,broomhall road,woking,surrey; part t/no SY706197. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Sunley Properties Limited
    Transaktionen
    • 25. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 24. Okt. 2002
    Geliefert am 25. Okt. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Including (I) plot 1 whispers,broomhall road,woking,surrey; part t/no SY706197; (ii) plot 2 whispers,broomhall road,woking,surrey; part t/no SY706197; (iii) plot 3 whispers,broomhall road,woking,surrey; part t/no SY706197. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 18. Okt. 2002
    Geliefert am 25. Okt. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Plot 63 lacuna, discovery drive, kings hill, west malling, kent part of t/n K818481. Plot 17 borrerfields, henfield part of t/n WSX257853. Plot 18 borrerfields, henfield part of t/n WSX257853. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill and uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Sunley Properties Limited
    Transaktionen
    • 25. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 18. Okt. 2002
    Geliefert am 25. Okt. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Plot 63 lacuna, discovery drive, kings hill, west malling, kent part of t/n K818481. Plot 17 borrerfields, henfield part of t/n WSX257853. Plot 18 borrerfields, henfield part of t/n WSX257853. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill and uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 30. Sept. 2002
    Geliefert am 07. Okt. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Plot 63 lacuna discovery drive kings hill west malling kent part t/n K818481, plot 17 borrerfields henfield part t/n WSX257853 and plot 18 borrerfields henfield part t/n WSX257853. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Sunley Properties Limited
    Transaktionen
    • 07. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 30. Sept. 2002
    Geliefert am 07. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Plot 63 lacuna discovery drive kings hill west malling kent part t/n K818481, plot 17 borrerfields henfield part t/n WSX257853 and plot 18 borrerfields henfield part t/n WSX257853. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Dez. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 21. Dez. 2001
    Geliefert am 08. Jan. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 21. Dez. 2001
    Geliefert am 08. Jan. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Sunley Properties Limited
    Transaktionen
    • 08. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 29. Jan. 1999
    Geliefert am 03. Feb. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 29. Jan. 1999
    Geliefert am 03. Feb. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Sunley Properties Limited
    Transaktionen
    • 03. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 31. Dez. 1996
    Geliefert am 07. Jan. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Sunley Properties Limited
    Transaktionen
    • 07. Jan. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 31. Dez. 1996
    Geliefert am 07. Jan. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Jan. 1997Registrierung einer Belastung (395)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0