ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03279316 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1st Floor 30 Cannon Street EC4M 6YN London England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| INHOCO 570 LIMITED | 15. Nov. 1996 | 15. Nov. 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Bmi Healthcare House 3 Paris Garden Southwark London SE1 8nd zum 1st Floor 30 Cannon Street London EC4M 6YN am 30. Mai 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2018 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Catherine Mary Jane Vickery als Sekretär am 30. Nov. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Dr Karen Anita Prins am 09. Nov. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Catherine Mary Jane Vickery als Geschäftsführer am 30. Nov. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Nov. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2017 bis 31. März 2018 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Nov. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Dr Karen Anita Prins als Direktor am 01. Okt. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jill Margaret Watts als Geschäftsführer am 30. Sept. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2016 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Nov. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2015 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Nov. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Henry Jonathan Davies als Direktor am 01. Sept. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Ms Catherine Mary Jane Vickery als Direktor am 01. Mai 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Craig Barry Lovelace als Geschäftsführer am 30. Apr. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2014 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Jill Margaret Watts als Direktor am 17. Nov. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen John Collier als Geschäftsführer am 16. Nov. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Nov. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2013 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVIES, Henry Jonathan | Geschäftsführer | 30 Cannon Street EC4M 6YN London 1st Floor England | England | British | 201206200001 | |||||
| PRINS, Karen Anita, Dr | Geschäftsführer | 30 Cannon Street EC4M 6YN London 1st Floor England | England | South African | 238969330004 | |||||
| DAY, Jonathan | Sekretär | 19 Kenwood Road Highgate N6 4EA London | British | 122061300001 | ||||||
| RICHARDSON, Ian Ashley | Sekretär | Monkswell The Ridgeway EN6 4BH Northaw Hertfordshire | British | 66535330002 | ||||||
| VICKERY, Catherine Mary Jane | Sekretär | 3 Paris Garden Southwark SE1 8ND London Bmi Healthcare House United Kingdom | 157319350001 | |||||||
| A B & C SECRETARIAL LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 900006570001 | |||||||
| AINLEY, Harvey Bertenshaw | Geschäftsführer | Priory Road SL5 8EB Ascot Orchard House Berkshire United Kingdom | England | British | 134262810002 | |||||
| BUCKLEY, Fiona Marie | Geschäftsführer | Browning House 14 Barry Rise WA14 3JS Bowdon Cheshire | United Kingdom | British | 61688100004 | |||||
| COLLIER, Stephen John | Geschäftsführer | 3 Paris Garden Southwark SE1 8ND London Bmi Healthcare House United Kingdom | United Kingdom | British | 18350160001 | |||||
| HEMMING, Eric Rodney | Geschäftsführer | The Elms 4 Clifton Drive FY8 5PP Lytham St. Annes Lancashire | British | 84030950001 | ||||||
| ISHAK HANNA, Magdy Adib, Dr | Geschäftsführer | Eliot House 40 Bishops Avenue Hampstead N2 0BA London | England | British | 76628190003 | |||||
| LOVELACE, Craig Barry | Geschäftsführer | 3 Paris Garden Southwark SE1 8ND London Bmi Healthcare House United Kingdom | England | British | 198852370001 | |||||
| RAMSAY, James | Geschäftsführer | The Old Post Office Village Road Dorney SL4 6QW Windsor Berkshire | British | 40105120004 | ||||||
| RICHARDSON, Ian Ashley | Geschäftsführer | Monkswell The Ridgeway EN6 4BH Northaw Hertfordshire | England | British | 66535330002 | |||||
| ROBERTSON, Nigel Mark Inches | Geschäftsführer | Sopworth SN14 6PT Chippenham Wookeys Barn Wiltshire United Kingdom | England | British | 97170790002 | |||||
| SMITH, Michael John | Geschäftsführer | 11 Lower Park Road IG10 4NB Loughton Essex | England | British | 641150001 | |||||
| VICKERY, Catherine Mary Jane | Geschäftsführer | 3 Paris Garden Southwark SE1 8ND London Bmi Healthcare House | United Kingdom | British | 102009810003 | |||||
| WATTS, Jill Margaret | Geschäftsführer | 3 Paris Garden Southwark SE1 8ND London Bmi Healthcare House | England | British | 187252950001 | |||||
| WIELAND, Phil | Geschäftsführer | Thameside Centre Kew Bridge Road TW8 0HF Brentford 4 Middlesex | England | British | 119448000002 | |||||
| INHOCO FORMATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 900006560001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbey Hospitals (Property) Limited | 06. Apr. 2016 | 3 Paris Garden Southwark SE1 8ND London Bmi Healthcare House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 14. Apr. 2005 Geliefert am 29. Apr. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any group company to the security trustee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Juni 2002 Geliefert am 05. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 17. Juni 2002 Geliefert am 27. Juni 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that leasehold property known as land lying to the south of dalton lane barrow-in-furness LA14 4LF t/n CU88004. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 22. Jan. 2002 Geliefert am 01. Feb. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The original securities; all rights moneys (including without limitation dividends) and property whatsoever which may from time to time at any time be derived from accrue on or be offered in respect of the original securities,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed to a legal charge dated 7TH march 1997 | Erstellt am 25. Sept. 1998 Geliefert am 30. Sept. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee as defined in relation to the company in a composite guarantee and debenture dated 7TH march 1997 and made between inhoco 588 limited,abbey hospitals limited,inhoco 575 limited,the company and hsbc equity limited,as amended by a supplemental deed to the composite guarantee and debenture dated 25TH september 1998 (as defined) | |
Kurze Angaben L/Hold property at barrow,cumbria; t/no cu 88004. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed to a composite guarantee and debenture dated 7TH march 1997 | Erstellt am 25. Sept. 1998 Geliefert am 30. Sept. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in respect of the loan notes (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 07. März 1997 Geliefert am 14. März 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company formally known as inhoco 570 limited or any group company as defined to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 07. März 1997 Geliefert am 14. März 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company formally known as inhoco 570 limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that l/h property k/a abbey park hospital,dalton lane,barrow in furness,cumbria.t/no.CU88004. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 07. März 1997 Geliefert am 11. März 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All indebtedness liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of the loan notes and this charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 07. März 1997 Geliefert am 11. März 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys and liabilities due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of a composite guarantee and debenture of even date and this charge | |
Kurze Angaben The underlease in the property k/a abbey park hospital dalton lane barrow cumbria t/no CU88004. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0