ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameABBEY PARK HOSPITAL LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03279316
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1st Floor 30 Cannon Street
    EC4M 6YN London
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    INHOCO 570 LIMITED15. Nov. 199615. Nov. 1996

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Bmi Healthcare House 3 Paris Garden Southwark London SE1 8nd zum 1st Floor 30 Cannon Street London EC4M 6YN am 30. Mai 2019

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2018

    4 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Catherine Mary Jane Vickery als Sekretär am 30. Nov. 2018

    1 SeitenTM02

    Änderung der Details des Direktors für Dr Karen Anita Prins am 09. Nov. 2018

    2 SeitenCH01

    Beendigung der Bestellung von Catherine Mary Jane Vickery als Geschäftsführer am 30. Nov. 2018

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Nov. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2017 bis 31. März 2018

    1 SeitenAA01

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Nov. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Dr Karen Anita Prins als Direktor am 01. Okt. 2017

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Jill Margaret Watts als Geschäftsführer am 30. Sept. 2017

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2016

    4 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Nov. 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2015

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 15. Nov. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital16. Dez. 2015

    Kapitalaufstellung am 16. Dez. 2015

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Ernennung von Henry Jonathan Davies als Direktor am 01. Sept. 2015

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Ms Catherine Mary Jane Vickery als Direktor am 01. Mai 2015

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Craig Barry Lovelace als Geschäftsführer am 30. Apr. 2015

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2014

    4 SeitenAA

    Ernennung von Jill Margaret Watts als Direktor am 17. Nov. 2014

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Stephen John Collier als Geschäftsführer am 16. Nov. 2014

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 15. Nov. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital24. Dez. 2014

    Kapitalaufstellung am 24. Dez. 2014

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2013

    4 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DAVIES, Henry Jonathan
    30 Cannon Street
    EC4M 6YN London
    1st Floor
    England
    Geschäftsführer
    30 Cannon Street
    EC4M 6YN London
    1st Floor
    England
    EnglandBritish201206200001
    PRINS, Karen Anita, Dr
    30 Cannon Street
    EC4M 6YN London
    1st Floor
    England
    Geschäftsführer
    30 Cannon Street
    EC4M 6YN London
    1st Floor
    England
    EnglandSouth African238969330004
    DAY, Jonathan
    19 Kenwood Road
    Highgate
    N6 4EA London
    Sekretär
    19 Kenwood Road
    Highgate
    N6 4EA London
    British122061300001
    RICHARDSON, Ian Ashley
    Monkswell
    The Ridgeway
    EN6 4BH Northaw
    Hertfordshire
    Sekretär
    Monkswell
    The Ridgeway
    EN6 4BH Northaw
    Hertfordshire
    British66535330002
    VICKERY, Catherine Mary Jane
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    United Kingdom
    Sekretär
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    United Kingdom
    157319350001
    A B & C SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Bevollmächtigter Sekretär
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006570001
    AINLEY, Harvey Bertenshaw
    Priory Road
    SL5 8EB Ascot
    Orchard House
    Berkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Priory Road
    SL5 8EB Ascot
    Orchard House
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish134262810002
    BUCKLEY, Fiona Marie
    Browning House
    14 Barry Rise
    WA14 3JS Bowdon
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Browning House
    14 Barry Rise
    WA14 3JS Bowdon
    Cheshire
    United KingdomBritish61688100004
    COLLIER, Stephen John
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    United Kingdom
    United KingdomBritish18350160001
    HEMMING, Eric Rodney
    The Elms
    4 Clifton Drive
    FY8 5PP Lytham St. Annes
    Lancashire
    Geschäftsführer
    The Elms
    4 Clifton Drive
    FY8 5PP Lytham St. Annes
    Lancashire
    British84030950001
    ISHAK HANNA, Magdy Adib, Dr
    Eliot House
    40 Bishops Avenue Hampstead
    N2 0BA London
    Geschäftsführer
    Eliot House
    40 Bishops Avenue Hampstead
    N2 0BA London
    EnglandBritish76628190003
    LOVELACE, Craig Barry
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    United Kingdom
    EnglandBritish198852370001
    RAMSAY, James
    The Old Post Office
    Village Road Dorney
    SL4 6QW Windsor
    Berkshire
    Geschäftsführer
    The Old Post Office
    Village Road Dorney
    SL4 6QW Windsor
    Berkshire
    British40105120004
    RICHARDSON, Ian Ashley
    Monkswell
    The Ridgeway
    EN6 4BH Northaw
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Monkswell
    The Ridgeway
    EN6 4BH Northaw
    Hertfordshire
    EnglandBritish66535330002
    ROBERTSON, Nigel Mark Inches
    Sopworth
    SN14 6PT Chippenham
    Wookeys Barn
    Wiltshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Sopworth
    SN14 6PT Chippenham
    Wookeys Barn
    Wiltshire
    United Kingdom
    EnglandBritish97170790002
    SMITH, Michael John
    11 Lower Park Road
    IG10 4NB Loughton
    Essex
    Geschäftsführer
    11 Lower Park Road
    IG10 4NB Loughton
    Essex
    EnglandBritish641150001
    VICKERY, Catherine Mary Jane
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    Geschäftsführer
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    United KingdomBritish102009810003
    WATTS, Jill Margaret
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    Geschäftsführer
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    EnglandBritish187252950001
    WIELAND, Phil
    Thameside Centre
    Kew Bridge Road
    TW8 0HF Brentford
    4
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Thameside Centre
    Kew Bridge Road
    TW8 0HF Brentford
    4
    Middlesex
    EnglandBritish119448000002
    INHOCO FORMATIONS LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006560001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Abbey Hospitals (Property) Limited
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    England
    06. Apr. 2016
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    England
    Nein
    RechtsformCompany Limited By Shares
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortRegistrar Of Companies For England And Wales
    Registrierungsnummer03279311
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 14. Apr. 2005
    Geliefert am 29. Apr. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group company to the security trustee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland ) as Security Trustee for the Secured Parties)(In Such Capacity the "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 29. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 17. Juni 2002
    Geliefert am 05. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 05. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Juni 2002
    Geliefert am 27. Juni 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that leasehold property known as land lying to the south of dalton lane barrow-in-furness LA14 4LF t/n CU88004. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 27. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 22. Jan. 2002
    Geliefert am 01. Feb. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The original securities; all rights moneys (including without limitation dividends) and property whatsoever which may from time to time at any time be derived from accrue on or be offered in respect of the original securities,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Fortis Bank S.A./N.V.
    Transaktionen
    • 01. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juni 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental deed to a legal charge dated 7TH march 1997
    Erstellt am 25. Sept. 1998
    Geliefert am 30. Sept. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as defined in relation to the company in a composite guarantee and debenture dated 7TH march 1997 and made between inhoco 588 limited,abbey hospitals limited,inhoco 575 limited,the company and hsbc equity limited,as amended by a supplemental deed to the composite guarantee and debenture dated 25TH september 1998 (as defined)
    Kurze Angaben
    L/Hold property at barrow,cumbria; t/no cu 88004.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Equity Limited,as Agent and Security Trustee for the Investors (As Defined)
    Transaktionen
    • 30. Sept. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Jan. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental deed to a composite guarantee and debenture dated 7TH march 1997
    Erstellt am 25. Sept. 1998
    Geliefert am 30. Sept. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in respect of the loan notes (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Equity Limited,as Agent and Security Trustee for the Investors (As Defined)
    Transaktionen
    • 30. Sept. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Jan. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 07. März 1997
    Geliefert am 14. März 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company formally known as inhoco 570 limited or any group company as defined to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. März 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Feb. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 07. März 1997
    Geliefert am 14. März 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company formally known as inhoco 570 limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that l/h property k/a abbey park hospital,dalton lane,barrow in furness,cumbria.t/no.CU88004.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. März 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juni 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 07. März 1997
    Geliefert am 11. März 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All indebtedness liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of the loan notes and this charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Equity Limited as Agent and Security Trustee for the Investors (As Defined)
    Transaktionen
    • 11. März 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Jan. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 07. März 1997
    Geliefert am 11. März 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys and liabilities due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of a composite guarantee and debenture of even date and this charge
    Kurze Angaben
    The underlease in the property k/a abbey park hospital dalton lane barrow cumbria t/no CU88004.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Equity Limited as Agent and Security Trustee for the Investors (As Defined)
    Transaktionen
    • 11. März 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Jan. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0