ALLEN WARNER LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameALLEN WARNER LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03279722
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ALLEN WARNER LIMITED?

    • (4521) /

    Wo befindet sich ALLEN WARNER LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Suite 1 Meadow Court 2-4 Meadow Close
    Ise Valley Estate
    NN8 4BH Wellingborough
    Northamptonshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ALLEN WARNER LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    QUALITY PROPERTY MANAGEMENT LIMITED18. Nov. 199618. Nov. 1996

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ALLEN WARNER LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Apr. 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für ALLEN WARNER LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Jan. 2013

    9 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    13 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. März 2012

    7 Seiten4.68

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    11 Seiten4.20

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 07. März 2011

    LRESEX

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Rutland House, Minerva Business Park, Lynch Wood Peterborough PE2 6PZ am 18. März 2011

    2 SeitenAD01

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 07. März 2011

    LRESEX

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital07. Dez. 2009

    Kapitalaufstellung am 07. Dez. 2009

    • Kapital: GBP 102
    SH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr Stephen James Allen am 08. Okt. 2009

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Mr Brent Edward Warner am 08. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    legacy

    1 Seiten288c

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2008

    7 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2007

    6 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2006

    6 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten287

    Gesellschaftsvertrag und Satzung

    9 SeitenMA

    Beschlüsse

    Resolutions
    SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Änderung der Aktienrechte oder der Bezeichnung

    RES12

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Wer sind die Geschäftsführer von ALLEN WARNER LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ALLEN, Stephen James
    Coates
    PE7 2DU Peterborough
    Poplar Farm
    United Kingdom
    Sekretär
    Coates
    PE7 2DU Peterborough
    Poplar Farm
    United Kingdom
    British14138990001
    WARNER, Brent Edward
    Coates
    PE7 2DU Peterborough
    Poplar Farm
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Coates
    PE7 2DU Peterborough
    Poplar Farm
    United Kingdom
    EnglandBritish255158470001
    JENNINGS, Susan Ann
    48 Broadway
    PE1 1YW Peterborough
    Cambridgeshire
    Sekretär
    48 Broadway
    PE1 1YW Peterborough
    Cambridgeshire
    British41388220001
    WARNER, Brent Edward
    8 Plank Drove
    PE6 0BY Crowland
    Peterborough
    Sekretär
    8 Plank Drove
    PE6 0BY Crowland
    Peterborough
    British43371760002
    FNCS SECRETARIES LIMITED
    16 Churchill Way
    CF1 4DX Cardiff
    Bevollmächtigter Sekretär
    16 Churchill Way
    CF1 4DX Cardiff
    900011830001
    ALLEN, Stephen James
    8 Boyce Close
    Whittlesey
    PE7 1JF Peterborough
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    8 Boyce Close
    Whittlesey
    PE7 1JF Peterborough
    Cambridgeshire
    EnglandBritish14138990001
    HOWELLS, Michael John
    394 Eastfield Road
    PE1 4RE Peterborough
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    394 Eastfield Road
    PE1 4RE Peterborough
    Cambridgeshire
    British43371740001
    PICKERING, Duncan Anthony
    4 Southfields
    PE10 9TZ Bourne
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    4 Southfields
    PE10 9TZ Bourne
    Lincolnshire
    United KingdomBritish65322780001
    FNCS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF1 4DX Cardiff
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    16 Churchill Way
    CF1 4DX Cardiff
    900011820001

    Hat ALLEN WARNER LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Mortgage
    Erstellt am 25. Mai 2006
    Geliefert am 27. Mai 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    129-137 winsover road spalding lincolnshire t/no LL84268 together with the buildings erections fixed machinery and fixtures and fittings now or hereinafter erected on or affixed to the said land or any part thereof.
    Berechtigte Personen
    • Cambridge Building Society
    Transaktionen
    • 27. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 27. Mai 2003
    Geliefert am 14. Juni 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h land known as land at rear of matley dental surgery orton brimbles peterborough. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 06. Aug. 2002
    Geliefert am 14. Aug. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a 50 huntly grove peterborough. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 21. Juli 2002
    Geliefert am 07. Aug. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 20. Apr. 2000
    Geliefert am 28. Apr. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 50, 50A & 52 huntly grove peterborough t/no: CB37386 (52 huntly grove). And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 12. Juni 1997
    Geliefert am 19. Juni 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land on the east side of furze street poplar l/b of tower hamlets t/n EGL354211. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Juni 1997Registrierung einer Belastung (395)

    Hat ALLEN WARNER LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    17. Apr. 2013Aufgelöst am
    07. März 2011Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    R N N Marshman
    Marshman Price
    Po Box 5895
    NN8 5ZD Wellingborough
    Northants
    Praktiker
    Marshman Price
    Po Box 5895
    NN8 5ZD Wellingborough
    Northants
    Alan Redvers Price
    Marshman Price
    Po Box 5895
    NN8 5ZD Wellingborough
    Northants
    Praktiker
    Marshman Price
    Po Box 5895
    NN8 5ZD Wellingborough
    Northants

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0