RAL (S&G) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameRAL (S&G) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03280526
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von RAL (S&G) LIMITED?

    • (9271) /

    Wo befindet sich RAL (S&G) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o MAZARS LLP
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von RAL (S&G) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    RAL HOLDINGS LIMITED14. Nov. 199614. Nov. 1996

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RAL (S&G) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis13. Juni 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für RAL (S&G) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    4 Seiten4.71

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Apr. 2011

    4 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Lancaster House 67 Newhall Street Birmingham B3 1NG am 07. Okt. 2010

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Silbury Court 368 Silbury Boulevard Milton Keynes MK9 2AF am 07. Mai 2010

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Insolvenzbeschluss

    Resolution INSOLVENCY:Extraordinary Resolution :- "In Specie"
    1 SeitenLIQ MISC RES

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 21. Apr. 2010

    LRESSP

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 13. Juni 2009

    1 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 14. Juni 2008

    1 SeitenAA

    Verschiedenes

    Section 519
    2 SeitenMISC

    legacy

    1 Seiten225

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten353

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von RAL (S&G) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HARVEY, Peter James
    3 Gates Court
    High Street
    SG7 6GA Baldock
    Hertfordshire
    Sekretär
    3 Gates Court
    High Street
    SG7 6GA Baldock
    Hertfordshire
    BritishAccountant103770410001
    REDMOND, Brendan Patrick
    57 Crisp Street
    3188 Hampton
    Victoria 3188
    Australia
    Geschäftsführer
    57 Crisp Street
    3188 Hampton
    Victoria 3188
    Australia
    AustraliaIrishCompany Director117576220001
    GARLAND, Jeremy Neil
    14 Brockwell
    Oakley
    MK43 7TD Bedford
    Bedfordshire
    Sekretär
    14 Brockwell
    Oakley
    MK43 7TD Bedford
    Bedfordshire
    British63471220001
    MERCY, Raymond Charles
    66 Kimpton Road Blackmore End
    Wheathampstead
    AL4 8LH St Albans
    Hertfordshire
    Sekretär
    66 Kimpton Road Blackmore End
    Wheathampstead
    AL4 8LH St Albans
    Hertfordshire
    BritishFinance Director50637030001
    YANTIN, Gary Laurence
    85 Cardinal Avenue
    WD6 1ST Borehamwood
    Hertfordshire
    Sekretär
    85 Cardinal Avenue
    WD6 1ST Borehamwood
    Hertfordshire
    British119004760001
    LAWNSWOOD NOMINEES (HOLDINGS) LIMITED
    70 New Cavendish Street
    W1M 8AT London
    Sekretär
    70 New Cavendish Street
    W1M 8AT London
    19960960001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Black Friars Lane
    EC4V 6HD London
    20
    Sekretär
    Black Friars Lane
    EC4V 6HD London
    20
    39182980001
    OVALSEC LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Bevollmächtigter Sekretär
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002570001
    BRYDON, Leslie
    1 Victoria House
    Market Place
    DL8 4NP Middleham
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    1 Victoria House
    Market Place
    DL8 4NP Middleham
    North Yorkshire
    BritishCommercial Director103621720001
    DIGGINES, Jonathan Brett
    Rossways
    32 Broad Lane
    WA15 0DH Hale
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Rossways
    32 Broad Lane
    WA15 0DH Hale
    Cheshire
    BritishFund Manager80119110001
    GARLAND, Jeremy Neil
    14 Brockwell
    Oakley
    MK43 7TD Bedford
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    14 Brockwell
    Oakley
    MK43 7TD Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritishFinance Director63471220001
    HALL, Andrew James
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director30306840002
    HARDING, Nicholas Simon
    The Old Wharf House
    The Wharf
    MK14 5AS Great Linford
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    The Old Wharf House
    The Wharf
    MK14 5AS Great Linford
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector150860820001
    HENRY, Maurice Charles
    11 Clonard Way
    HA5 4BT Hatch End
    Middlesex
    Geschäftsführer
    11 Clonard Way
    HA5 4BT Hatch End
    Middlesex
    EnglandBritishDirector Of Companies91857380001
    MERCY, Raymond Charles
    66 Kimpton Road Blackmore End
    Wheathampstead
    AL4 8LH St Albans
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    66 Kimpton Road Blackmore End
    Wheathampstead
    AL4 8LH St Albans
    Hertfordshire
    BritishDirector50637030001
    SOLOMON, Nathaniel
    4 Pembroke Walk
    Kensington
    W8 6PQ London
    Geschäftsführer
    4 Pembroke Walk
    Kensington
    W8 6PQ London
    EnglandBritishCompany Director3776000001
    WILLIAMS, David Jeffreys
    Surville
    La Ruette Pinel St Helier
    JE2 3HF Jersey
    Channel Islands
    Geschäftsführer
    Surville
    La Ruette Pinel St Helier
    JE2 3HF Jersey
    Channel Islands
    JerseyBritishDirector141743090001

    Hat RAL (S&G) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 04. Apr. 2007
    Geliefert am 17. Apr. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Finance Parties
    Transaktionen
    • 17. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 08. Feb. 2007
    Geliefert am 14. Feb. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future moneys debts and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the benefit of the finance parties (the "the security trustee") on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 14. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment of keyman policy
    Erstellt am 01. Juni 2005
    Geliefert am 07. Juni 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Norwich union policy number 7821768EJ and 7806968ET dated 14TH may 2002 for the sum of £1MILLION and £1 million life assured mr n s harding together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 01. Juni 2005
    Geliefert am 07. Juni 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 04. Aug. 2003
    Geliefert am 14. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 14. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 13. Sept. 2002
    Geliefert am 01. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and all obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the mezzanine lenders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings at 1 north gate halifax and 10 old market halifax t/nos: WYK423622 and WYK234169; 70 and 72 high street dudley west midlands t/nos: WM186753 WM277822. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Aberdeen Asset Managers Limited
    Transaktionen
    • 01. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Aug. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 05. Juli 2001
    Geliefert am 12. Juli 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £100,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Maurice Charles Henry
    Transaktionen
    • 12. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Aug. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 05. Juli 2001
    Geliefert am 12. Juli 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £50,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nathaniel Solomon
    Transaktionen
    • 12. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Aug. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage of life policy
    Erstellt am 06. Dez. 1996
    Geliefert am 12. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The policy dated 29TH november 1996 taken out by the company with allied dunbar assurance limited over the life of raymond charles mercy in an amount (exclusive of bonus) of £500,,000 (policy number 5460107 das). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Aug. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage of life policy
    Erstellt am 06. Dez. 1996
    Geliefert am 12. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The policy dated 29TH november 1996 taken out by the company with allied dunbar assurance limited over the life of raymond charles mercy in an amount (exclusive of bonus) of £1,000,000 (policy number 5460107 das). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Aug. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage of life policy
    Erstellt am 29. Nov. 1996
    Geliefert am 12. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The policy dated 29TH november 1996 taken out by the company with allied dunbar assurance limited over the life of nicholas simon harding in an amount (exclusive of bonus) of £1,000,000 (policy number 5461107 dhs). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Aug. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage of life policy
    Erstellt am 29. Nov. 1996
    Geliefert am 12. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The policy dated 29TH november 1996 taken out by the company with allied dunbar assurance limited over the life of raymond charles mercy in an amount (exclusive of bonus) of £500,000 (policy no: 5463107 dhs). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Aug. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 29. Nov. 1996
    Geliefert am 11. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Aug. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment of keyman insurance policies
    Erstellt am 29. Nov. 1996
    Geliefert am 06. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Liens and encumbrances (other than those in favour of the lender and lloyds bank PLC) all its rights, title and interest in and to the keyman insurance policies. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Aib Capital Markets PLC
    Transaktionen
    • 06. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 29. Nov. 1996
    Geliefert am 06. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Aib Capital Markets PLC
    Transaktionen
    • 06. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat RAL (S&G) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    21. Apr. 2010Beginn der Liquidation
    14. Okt. 2011Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Alistair Steven Wood
    Mazars Llp
    Lancaster House
    B3 1NG 67 Newhall Street
    Birmingham
    Praktiker
    Mazars Llp
    Lancaster House
    B3 1NG 67 Newhall Street
    Birmingham
    Simon David Chandler
    6 Dominus Way
    Meridian Business Park
    LE19 1RP Leicester
    Leicestershire
    Praktiker
    6 Dominus Way
    Meridian Business Park
    LE19 1RP Leicester
    Leicestershire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0