V.V. EDINBURGH R.W. G.P. LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | V.V. EDINBURGH R.W. G.P. LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03282078 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von V.V. EDINBURGH R.W. G.P. LIMITED?
- (7415) /
- (7499) /
Wo befindet sich V.V. EDINBURGH R.W. G.P. LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | KPMG RESTRUCTURING 8 Salisbury Square EC4Y 8BB London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von V.V. EDINBURGH R.W. G.P. LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| NOBOTRADE LIMITED | 21. Nov. 1996 | 21. Nov. 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von V.V. EDINBURGH R.W. G.P. LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2006 |
Welche sind die letzten Einreichungen für V.V. EDINBURGH R.W. G.P. LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 3 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Nov. 2009 | 5 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 8 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 10 Seiten | 363s | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2005 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 9 Seiten | 363s | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2004 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 9 Seiten | 363s | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2003 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 9 Seiten | 363s | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2002 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 9 Seiten | 363s | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2001 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von V.V. EDINBURGH R.W. G.P. LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HENDERSON SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | 4 Broadgate EC2M 2DA London | 6118210006 | |||||||
| ANDERSON, William Wallace | Geschäftsführer | 141 Rosendale Road SE21 8HE London | England | British | 2894560001 | |||||
| CARPENTER, Mark Richard Charles | Geschäftsführer | 62 Murray Road SW19 4PE Wimbledon | England | British | 69709970001 | |||||
| ELY, Roger Benjamin | Geschäftsführer | 53 Five Arches Orton Wistow PE2 6FQ Peterborough Cambridgeshire | United Kingdom | British | 69707840001 | |||||
| GEIPEL FABER, Ute | Geschäftsführer | Robert-Koch Strasse Munchen 80538 Germany | German | 66364770002 | ||||||
| JARRETT, Desmond Mason | Geschäftsführer | 19 Hambalt Road Clapham SW4 9EA London | England | British | 72779980001 | |||||
| KRONESTER, Karl Heinz | Geschäftsführer | Bertelestr 23 Munich FOREIGN 81479 Germany | German | 69708410001 | ||||||
| HENDERSON SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Geschäftsführer | 4 Broadgate EC2M 2DA London | 6118210006 | |||||||
| DAWS, Raymond Kenneth | Sekretär | 2 Ashleigh Gardens SM1 3EN Sutton Surrey | British | 54856640001 | ||||||
| FITZGERALD, John Edward | Sekretär | 45 Parkstead Lodge Upper Park Road NW3 2UL London | Irish | 55701370001 | ||||||
| GRAHAM, Ronald Stewart | Sekretär | 15a Marmion Road Clapham SW11 5PD London | British | 60046510004 | ||||||
| SIMMS, John Geoffrey | Sekretär | 1 The Ridgeway AL4 9AL St Albans Hertfordshire | British | 49583890001 | ||||||
| NORTON ROSE LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Kempson House P.O. Box 570, Camomile Street EC3A 7AN London | 900006420001 | |||||||
| BRIGHT, Keith | Geschäftsführer | 5 Bateman Road Croxley Green WD3 3BL Rickmansworth Hertfordshire | United Kingdom | British | 65764440001 | |||||
| BUSHNELL, Patrick James | Geschäftsführer | Pounce Hall Sewards End CB10 2LE Saffron Walden Essex | United Kingdom | British | 26791960001 | |||||
| BYSH, Rodney Alexander | Geschäftsführer | Wiesenstrasse 33 60385 Frankfurt Germany | British | 45848330001 | ||||||
| DAWS, Raymond Kenneth | Geschäftsführer | 2 Ashleigh Gardens SM1 3EN Sutton Surrey | British | 54856640001 | ||||||
| FITZGERALD, John Edward | Geschäftsführer | 45 Parkstead Lodge Upper Park Road NW3 2UL London | Irish | 55701370001 | ||||||
| FOX, Ian John | Geschäftsführer | Flat 6 1 Queens Avenue Muswell Hill N10 3PE London | British | 55591880001 | ||||||
| GRAHAM, Ronald Stewart | Geschäftsführer | 15a Marmion Road Clapham SW11 5PD London | British | 60046510004 | ||||||
| SIMMS, John Geoffrey | Geschäftsführer | 1 The Ridgeway AL4 9AL St Albans Hertfordshire | British | 49583890001 | ||||||
| SMITH, Andrew Richard Ingram | Geschäftsführer | 15 Hurst Farm Road RH19 4DQ East Grinstead West Sussex | British | 71449570001 | ||||||
| UNDERHILL, Anthony Owen | Geschäftsführer | 10 Burghley Close MK45 1TF Flitwick Bedfordshire | British | 80855550001 | ||||||
| NOROSE LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Kempson House P.O. Box 570, Camomile Street EC3A 7AN London | 900006410001 | |||||||
| NORTON ROSE LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Kempson House P.O. Box 570, Camomile Street EC3A 7AN London | 900006420001 |
Hat V.V. EDINBURGH R.W. G.P. LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Assignation of rental assignation | Erstellt am 14. Okt. 1999 Geliefert am 26. Okt. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed | |
Kurze Angaben 1-17 glasgow road/units 1 and 2 gylemuir road edinburgh. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignation of standard security | Erstellt am 06. Okt. 1999 Geliefert am 09. Okt. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of any of the finance documents and/or in connection with any loan facility or other financial accommodation | |
Kurze Angaben All and whole that area of ground lying between glasgow road and gylemuir road, edinburgh in the former city of edinburgh district of lothian. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rental assignation dated 26TH march 1997 and | Erstellt am 27. März 1997 Geliefert am 04. Apr. 1997 | Ausstehend | Gesicherter Betrag Certain facilities made available to the company by the bank | |
Kurze Angaben The company's whole entitlement to receive from each of the tenants for the time being under the leases of parts of all and whole that area of ground lying between glasgow road and gylemuir road,edinburgh. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 26. März 1997 Geliefert am 15. Apr. 1997 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben Floating charge all the property undertaking rights benefits and assets of the company whatsoever and wheresoever present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge and assignment by way of security | Erstellt am 26. März 1997 Geliefert am 15. Apr. 1997 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben All the company's right title and interest in the accounts the deposit and the collateral warranties. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security presented for registration in scotland on 28TH march 1997 and | Erstellt am 26. März 1997 Geliefert am 04. Apr. 1997 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of any of the loan agreement dated 27 march 1997 (or within seven days of that date) (as defined) and this charge | |
Kurze Angaben All and whole that area of ground lying between glasgow road and gylemuir road,edinburgh. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat V.V. EDINBURGH R.W. G.P. LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0