V.V. READING G.P. LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameV.V. READING G.P. LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03282084
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von V.V. READING G.P. LIMITED?

    • (7415) /
    • (7499) /

    Wo befindet sich V.V. READING G.P. LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    KPMG RESTRUCTURING
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von V.V. READING G.P. LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    V.V. TAUNTON G.P. LIMITED06. Feb. 199706. Feb. 1997
    DONTRADE LIMITED21. Nov. 199621. Nov. 1996

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von V.V. READING G.P. LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2006

    Welche sind die letzten Einreichungen für V.V. READING G.P. LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    3 Seiten4.71

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Nov. 2009

    5 Seiten4.68

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 13. Nov. 2008

    LRESSP

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    8 Seiten363a

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    11 SeitenAA

    legacy

    10 Seiten363s

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005

    12 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten288a

    legacy

    3 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    9 Seiten363s

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2004

    12 SeitenAA

    legacy

    9 Seiten363s

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2003

    12 SeitenAA

    legacy

    9 Seiten363s

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed V.V. taunton G.P. LIMITED\certificate issued on 09/09/03
    2 SeitenCERTNM

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2002

    12 SeitenAA

    legacy

    7 Seiten395

    legacy

    7 Seiten395

    legacy

    9 Seiten363s

    Wer sind die Geschäftsführer von V.V. READING G.P. LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HENDERSON SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    4 Broadgate
    EC2M 2DA London
    Sekretär
    4 Broadgate
    EC2M 2DA London
    6118210006
    ANDERSON, William Wallace
    141 Rosendale Road
    SE21 8HE London
    Geschäftsführer
    141 Rosendale Road
    SE21 8HE London
    EnglandBritish2894560001
    CARPENTER, Mark Richard Charles
    62 Murray Road
    SW19 4PE Wimbledon
    Geschäftsführer
    62 Murray Road
    SW19 4PE Wimbledon
    EnglandBritish69709970001
    ELY, Roger Benjamin
    53 Five Arches
    Orton Wistow
    PE2 6FQ Peterborough
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    53 Five Arches
    Orton Wistow
    PE2 6FQ Peterborough
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish69707840001
    GEIPEL FABER, Ute
    Robert-Koch Strasse
    Munchen
    80538
    Germany
    Geschäftsführer
    Robert-Koch Strasse
    Munchen
    80538
    Germany
    German66364770002
    JARRETT, Desmond Mason
    19 Hambalt Road
    Clapham
    SW4 9EA London
    Geschäftsführer
    19 Hambalt Road
    Clapham
    SW4 9EA London
    EnglandBritish72779980001
    KRONESTER, Karl Heinz
    Bertelestr 23
    Munich
    FOREIGN 81479
    Germany
    Geschäftsführer
    Bertelestr 23
    Munich
    FOREIGN 81479
    Germany
    German69708410001
    HENDERSON SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    4 Broadgate
    EC2M 2DA London
    Geschäftsführer
    4 Broadgate
    EC2M 2DA London
    6118210006
    DAWS, Raymond Kenneth
    2 Ashleigh Gardens
    SM1 3EN Sutton
    Surrey
    Sekretär
    2 Ashleigh Gardens
    SM1 3EN Sutton
    Surrey
    British54856640001
    FITZGERALD, John Edward
    45 Parkstead Lodge
    Upper Park Road
    NW3 2UL London
    Sekretär
    45 Parkstead Lodge
    Upper Park Road
    NW3 2UL London
    Irish55701370001
    GRAHAM, Ronald Stewart
    15a Marmion Road
    Clapham
    SW11 5PD London
    Sekretär
    15a Marmion Road
    Clapham
    SW11 5PD London
    British60046510004
    SIMMS, John Geoffrey
    1 The Ridgeway
    AL4 9AL St Albans
    Hertfordshire
    Sekretär
    1 The Ridgeway
    AL4 9AL St Albans
    Hertfordshire
    British49583890001
    NORTON ROSE LIMITED
    Kempson House
    Camomile Street
    EC3A 7AN London
    Sekretär
    Kempson House
    Camomile Street
    EC3A 7AN London
    82740540001
    BRIGHT, Keith
    5 Bateman Road
    Croxley Green
    WD3 3BL Rickmansworth
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    5 Bateman Road
    Croxley Green
    WD3 3BL Rickmansworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritish65764440001
    BUSHNELL, Patrick James
    Pounce Hall
    Sewards End
    CB10 2LE Saffron Walden
    Essex
    Geschäftsführer
    Pounce Hall
    Sewards End
    CB10 2LE Saffron Walden
    Essex
    United KingdomBritish26791960001
    BYSH, Rodney Alexander
    Wiesenstrasse 33
    60385 Frankfurt
    Germany
    Geschäftsführer
    Wiesenstrasse 33
    60385 Frankfurt
    Germany
    British45848330001
    DAWS, Raymond Kenneth
    2 Ashleigh Gardens
    SM1 3EN Sutton
    Surrey
    Geschäftsführer
    2 Ashleigh Gardens
    SM1 3EN Sutton
    Surrey
    British54856640001
    FITZGERALD, John Edward
    45 Parkstead Lodge
    Upper Park Road
    NW3 2UL London
    Geschäftsführer
    45 Parkstead Lodge
    Upper Park Road
    NW3 2UL London
    Irish55701370001
    FOX, Ian John
    Flat 6 1 Queens Avenue
    Muswell Hill
    N10 3PE London
    Geschäftsführer
    Flat 6 1 Queens Avenue
    Muswell Hill
    N10 3PE London
    British55591880001
    GRAHAM, Ronald Stewart
    15a Marmion Road
    Clapham
    SW11 5PD London
    Geschäftsführer
    15a Marmion Road
    Clapham
    SW11 5PD London
    British60046510004
    SIMMS, John Geoffrey
    1 The Ridgeway
    AL4 9AL St Albans
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    1 The Ridgeway
    AL4 9AL St Albans
    Hertfordshire
    British49583890001
    SMITH, Andrew Richard Ingram
    15 Hurst Farm Road
    RH19 4DQ East Grinstead
    West Sussex
    Geschäftsführer
    15 Hurst Farm Road
    RH19 4DQ East Grinstead
    West Sussex
    British71449570001
    UNDERHILL, Anthony Owen
    10 Burghley Close
    MK45 1TF Flitwick
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    10 Burghley Close
    MK45 1TF Flitwick
    Bedfordshire
    British80855550001
    NOROSE LIMITED
    Kempson House Camomile Street
    EC3A 7AN London
    Geschäftsführer
    Kempson House Camomile Street
    EC3A 7AN London
    58052910001
    NORTON ROSE LIMITED
    Kempson House
    Camomile Street
    EC3A 7AN London
    Geschäftsführer
    Kempson House
    Camomile Street
    EC3A 7AN London
    82740540001

    Hat V.V. READING G.P. LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Floating charge
    Erstellt am 06. Feb. 2003
    Geliefert am 19. Feb. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrower and/or the mortgagor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Floating charge all the undertaking and all property rghts and benefits and assets of the chargee whatsoever and wheresoever at the date of the charge and thereafter. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale
    Transaktionen
    • 19. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Feb. 2003
    Geliefert am 19. Feb. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrower and/or the mortgagor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property k/a the land at the junction of rushey way and chalfont way lower earley t/n BK365144 including the whole or any parts thereof and all buildings and other structures from time to time erected thereon by way of assignment all rental and other income the benefit of all warranties all the rights interests and entitlements under and/or in relation to any compensation and/or insurance policies and insurance monies specific charge all rights in respect of deeds and documents the benefit of covenants for title and the benefit of any contract of sale. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale
    Transaktionen
    • 19. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge granted by (1) the general partner (2) V.V. nominees limited (the nominee) and (3) crown walk taunton limited (the jersey nominee) in favour of (4) landesbank hessen-thuringen girozentrale (the bank)
    Erstellt am 29. Feb. 2000
    Geliefert am 18. März 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All moneys, obligations and liabilities on the part of the borrower and/or the mortgagor to the chargee pursuant to the finance documents and/or in connection with any loan facility or other financial accommodation from time to time granted or otherwise made available pursuant thereto together with all moneys, obligations and liabilities on the part of the borrower and/or the mortgagor to the chargee on any account whatsoever together with all expenses, and any interest charged under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    F/H 59/63 high street and 1/9 crown walk taunton somerset - ST9823 and all buildings and other structures and all fixtures and assigns to the bank all rental income and other income from the property together with the benefit of all warranties - for full details see form 395.
    Berechtigte Personen
    • Landesbank Hessen-Thurigen Girozentrale ("the Bank")
    Transaktionen
    • 18. März 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Floating charge
    Erstellt am 11. Apr. 1997
    Geliefert am 28. Apr. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All present or future obligations and liabilities of the company and/or the borrower to the chargee under any agreement or in any manner whatever pursuant to the terms of the charge
    Kurze Angaben
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerishe Vereinsbank Aktiengesellschaft
    Transaktionen
    • 28. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Account charge and assignment
    Erstellt am 11. Apr. 1997
    Geliefert am 28. Apr. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities of the company and/or the borrower to the chargee under any agreement or in any manner whatever pursuant to the terms of the charge
    Kurze Angaben
    All its right title and interest in the account and the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerishe Vereinsbank Aktiengesellschat
    Transaktionen
    • 28. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Apr. 1997
    Geliefert am 28. Apr. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All moneys obligations and liabilities of the company and/or the borrower to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of any of the finance documents and/or any loan facility (as defined)
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage all the property and assigns to the bank all rental & other incomefrom the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerishe Vereinsbank Aktiengesellschaft
    Transaktionen
    • 28. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)

    Hat V.V. READING G.P. LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    13. Nov. 2008Beginn der Liquidation
    17. Juni 2010Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Jeremy Simon Spratt
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Finbarr O'Connell
    Kpmg Corporate Recovery
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    Kpmg Corporate Recovery
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0