THORNHILL NOMINEES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | THORNHILL NOMINEES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03286309 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von THORNHILL NOMINEES LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich THORNHILL NOMINEES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 16 Palace Street SW1E 5BN London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von THORNHILL NOMINEES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| THORNHILL HOLDINGS LIMITED | 21. Jan. 1997 | 21. Jan. 1997 |
| SKIPTIME LIMITED | 02. Dez. 1996 | 02. Dez. 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von THORNHILL NOMINEES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2008 |
Welche sind die letzten Einreichungen für THORNHILL NOMINEES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | Seiten | GAZ2(A) | ||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Sept. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | Seiten | AR01 | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | Seiten | GAZ1(A) | ||
legacy | Seiten | 652a | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | Seiten | AA | ||
legacy | Seiten | 287 | ||
legacy | Seiten | 363a | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | Seiten | AA | ||
legacy | Seiten | 288b | ||
legacy | Seiten | 363s | ||
legacy | Seiten | 363(288) | ||
legacy | Seiten | 288c | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | Seiten | AA | ||
legacy | Seiten | 363s | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005 | Seiten | AA | ||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | Seiten | MA | ||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed thornhill holdings LIMITED\certificate issued on 21/11/05 | Seiten | CERTNM | ||
legacy | Seiten | 288a | ||
legacy | Seiten | 288a | ||
legacy | Seiten | 288b | ||
legacy | Seiten | 363s | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2004 | Seiten | AA | ||
legacy | Seiten | 288c | ||
legacy | Seiten | 288a | ||
legacy | Seiten | 363s | ||
Wer sind die Geschäftsführer von THORNHILL NOMINEES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REID, Alistair Garnet | Sekretär | 5 Avenue Road CR3 5TR Caterham Surrey | British | 9275110002 | ||||||
| DAVIES, Mark Edward Trehearne | Geschäftsführer | 26 Chester Street SW1X 7BL London | England | British | 82536300001 | |||||
| DUDGEON, Alexander Stewart | Geschäftsführer | Humbie EH29 9EG Kirkliston West Lothian | United Kingdom | British | 61131230006 | |||||
| ELKINGTON, Robert John | Geschäftsführer | Cranbourne Grange Sutton Scotney SO21 3NA Winchester Hampshire | British | 3175220001 | ||||||
| MULVEY, Andrew John | Geschäftsführer | Bucklers Croft Perry Green SG10 6EB Much Hadham Hertfordshire | British | 37403440003 | ||||||
| REID, Alistair Garnet | Geschäftsführer | 5 Avenue Road CR3 5TR Caterham Surrey | England | British | 9275110002 | |||||
| CROSS, Simon James | Sekretär | 102a Offord Road Islington N1 1PF London | British | 90564210001 | ||||||
| GERAGHTY, Clement Delville Wood | Sekretär | 4 Carmalt Gardens KT12 5HH Hersham Surrey | British | 101284310001 | ||||||
| MULVEY, Andrew John | Sekretär | 4 Coopers Close St Michaels Mead CM23 4GA Bishops Stortford Hertfordshire | British | 37403440002 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| CAVE, James Andrew | Geschäftsführer | Flat E 46 Mount Street W1K 2SA London | England | British | 6612160002 | |||||
| GASSNER, Hans | Geschäftsführer | Aeulestrasse 74 Fl-9490 Vaduz Liechtenstein | Liechtenstein | 11277950001 | ||||||
| PACKARD, Fred Arthur Rank | Geschäftsführer | 13 Chester Street SW1X 7BB London | British | 3125910001 | ||||||
| ROBB, George Alan | Geschäftsführer | The Cedars Compton Way GU10 1QY Moor Park Farnham Surrey | British | 35558670005 | ||||||
| WALLIS, Russell | Geschäftsführer | Clyffe Pypard SN4 7PY Swindon Old Vicarage Wiltshire | England | British | 138505360001 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Hat THORNHILL NOMINEES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Further deed of assignment by way of security of key man policy | Erstellt am 22. Apr. 1999 Geliefert am 08. Mai 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All amounts and liabilities due owing or incurred by the company to the registered owners of the £900,000 11.11% unsecured loan notes 2007 of £1 each in the company and/or the chargee (as agent and trustee for the noteholders) under or in connection with the loan notes (as from time to time varied extended or replaced) and/or under the further deed of assignment | |
Kurze Angaben All right title and interest in and to the key man life policy no L0199958601 in respect of james andrew cave. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment by way of security of key man policy | Erstellt am 22. Apr. 1999 Geliefert am 08. Mai 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All amounts and liabilities due owing or incurred by the company to the registered owners of the £500,000 12% unsecured loan notes 2007 of £1 each in the company and/or the chargee (as agent and trustee for the noteholders) under or in connection with the loan notes (as from time to time varied extended or replaced) and/or under the deed of assignment | |
Kurze Angaben All right title and interest in and to the key man life policy no 201047023341 in respect of james andrew cave. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of variation to deed of assignment by way of security of keyman policy dated 14TH march 1997 | Erstellt am 31. Dez. 1997 Geliefert am 14. Jan. 1998 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies and liabilities due or to become due by the company to the chargee in connection with the issue of 900,000 11.11% unsecured loan notes 2007 of £1 each in the company as from time to time varied extended or replaced. (The issue of 900,000 loan notes being made by way of an issue of 500,000 loan notes on 14TH march 1997, and a further issue of 400,000 loan notes on 31ST december 1997 | |
Kurze Angaben Keyman insurance policy number 20104702334V held by thornhill holdings limited issued by guardian finance services limited (the "new assignment"). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment | Erstellt am 14. März 1997 Geliefert am 22. März 1997 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies and liabilities due or to become due by the company in connection with £500,000 12% unsecured loan notes 2007 of £1 each in the company as from time to time varied extended or replaced | |
Kurze Angaben Keyman policy number 20104702334V held by thornhill holdings limited issued by guardian finance services limited. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0